SELECTRONIC LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSELECTRONIC LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01465562
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SELECTRONIC LIMITED ?

    • Commerce de gros d'équipements électroniques et de télécommunications et de pièces détachées (46520) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe SELECTRONIC LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Acre House
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SELECTRONIC LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PBM SELECTRONIC LIMITED07 déc. 197907 déc. 1979

    Quels sont les derniers comptes de SELECTRONIC LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour SELECTRONIC LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Paul Hudson Kidner en tant que directeur le 30 avr. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Paul Hudson Kidner en tant que secrétaire le 30 avr. 2022

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 27 févr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Selectronic Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 mars 2020

    2 pagesPSC05

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    10 pagesAA

    Modification des détails de Selectronic Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Déclaration de confirmation établie le 27 févr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Paul Craig Mullen en tant que directeur le 20 août 2020

    1 pagesTM01

    Période comptable actuelle raccourcie du 31 mars 2021 au 31 déc. 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de Book End Witney Oxfordshire OX29 0YE à Acre House 11-15 William Road London NW1 3ER le 19 mars 2020

    1 pagesAD01

    Période comptable actuelle prolongée du 30 nov. 2020 au 31 mars 2021

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Leon Peter Quinn en tant que secrétaire le 10 mars 2020

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Clare Maceachrane en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Clive George Hemsley en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Leon Peter Quinn en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kelvin Walter John Stark en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Kevin Charles Dry en tant que directeur le 10 mars 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Hudson Kidner en tant que secrétaire le 10 mars 2020

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de SELECTRONIC LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LIM, Bernard Ching-Bing
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    Administrateur
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    CanadaMalaysianEngineer45062380002
    BORRETT, David Malcolm
    5 Emery Acres
    RG8 8NY Upper Basildon
    Berkshire
    Secrétaire
    5 Emery Acres
    RG8 8NY Upper Basildon
    Berkshire
    British6796590002
    KIDNER, Paul Hudson
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    Secrétaire
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    268045160001
    QUINN, Leon Peter
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    Secrétaire
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    166293280001
    BORRETT, David Malcolm
    5 Emery Acres
    RG8 8NY Upper Basildon
    Berkshire
    Administrateur
    5 Emery Acres
    RG8 8NY Upper Basildon
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant6796590002
    DIMBERLINE, Christopher James, The Estate Of Mr
    Springfield Mill Lane
    Moddershall
    ST15 8TG Stone
    Staffs
    Administrateur
    Springfield Mill Lane
    Moddershall
    ST15 8TG Stone
    Staffs
    EnglandBritishEngineer6796610001
    DRY, Kevin Charles
    Fairlawns
    School Road Hurst
    RG10 0DR Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Fairlawns
    School Road Hurst
    RG10 0DR Reading
    Berkshire
    EnglandBritishManaging Director50849580004
    EGGINTON, Sarah Diane
    43 Crawley Road
    OX28 1HX Witney
    Oxfordshire
    Administrateur
    43 Crawley Road
    OX28 1HX Witney
    Oxfordshire
    BritishAdminstrator79580920001
    HEMSLEY, Clive George
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    Administrateur
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    EnglandBritishNon-Executive Director10607790002
    HIGGS, Peter John
    Home Farmhouse
    Aston Road
    OX8 7QW Brighthampton
    Oxon
    Administrateur
    Home Farmhouse
    Aston Road
    OX8 7QW Brighthampton
    Oxon
    BritishSales Director8661770003
    KIDNER, Paul Hudson
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    Administrateur
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    EnglandBritishChartered Accountant8693340003
    MACEACHRANE, Clare
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    Administrateur
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    EnglandBritishDirector255738210001
    MAYALL, Robert Charles
    Wentworth Cottage 15 Wentworth Road
    Four Oaks Sutton Coldfield
    B74 2SD Birmingham
    Administrateur
    Wentworth Cottage 15 Wentworth Road
    Four Oaks Sutton Coldfield
    B74 2SD Birmingham
    BritishEngineer6011420001
    MULLEN, Paul Craig
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    Administrateur
    11-15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    England
    EnglandBritishCompany Director56477320002
    QUINN, Leon Peter
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    Administrateur
    Book End
    Witney
    OX29 0YE Oxfordshire
    EnglandBritishDirector255737600001
    STARK, Kelvin Walter John
    16 Springfield Road
    BS20 6LH Portishead
    North Somerset
    Administrateur
    16 Springfield Road
    BS20 6LH Portishead
    North Somerset
    EnglandBritishSales Director88822630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SELECTRONIC LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Selectronic Holdings Limited
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    11/15 William Road
    NW1 3ER London
    Acre House
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement02839864
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    SELECTRONIC LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal assignment
    Créé le 08 févr. 2012
    Livré le 10 févr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due under the contract (the contract monies).
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 26 janv. 2012
    Livré le 28 janv. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder & the company including the associated rights relating thereto, which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 28 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 sept. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 26 janv. 2012
    Livré le 28 janv. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 28 janv. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 sept. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collateral debenture
    Créé le 01 avr. 2003
    Livré le 04 avr. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Up to £788,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All. Undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • The Holders from Time to Time of the Series of £788,000 Nominal Secured Loan Notes 2013
    Transactions
    • 04 avr. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 18 mars 1994
    Livré le 24 mars 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 mars 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 oct. 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 28 oct. 1986
    Livré le 04 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Including trade fixtures. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Standard Chartered Bank
    Transactions
    • 04 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 27 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 19 avr. 1982
    Livré le 24 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
    Transactions
    • 24 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 19 janv. 1980
    Livré le 24 janv. 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £2,400 and further advances not exceeding £15,000
    Brèves mentions
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Contelec Supplies (Wolverhampton) Limited.
    Transactions
    • 24 janv. 1980Enregistrement d'une charge
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0