SAPA UK LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSAPA UK LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01469120
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SAPA UK LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SAPA UK LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o SAPA BUILDING SYSTEMS
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park 5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SAPA UK LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SAPA HOLDINGS LIMITED02 avr. 198002 avr. 1980
    WELHIND TWENTY-SECOND LIMITED27 déc. 197927 déc. 1979

    Quels sont les derniers comptes de SAPA UK LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour SAPA UK LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    23 pagesAA

    État du capital au 13 juil. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de James Frederick Tate en tant que directeur le 20 juin 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Nicholas Viner en tant qu'administrateur le 16 juin 2016

    2 pagesAP01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 févr. 2016

    État du capital au 03 févr. 2016

    • Capital: GBP 19,137,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    20 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Nicholas Viner en tant que secrétaire le 23 mars 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Peter Ashby en tant que secrétaire le 23 mars 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2015

    État du capital au 27 févr. 2015

    • Capital: GBP 19,137,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    23 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 févr. 2014

    État du capital au 24 févr. 2014

    • Capital: GBP 19,137,000
    SH01

    Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury Gloucestershire GL20 8TX United Kingdom* le 24 févr. 2014

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de SAPA UK LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VINER, Simon Nicholas
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    Secrétaire
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    196239130001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector24297480001
    VINER, Simon Nicholas
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    Administrateur
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    EnglandBritishFinance Director169860470001
    ASHBY, David Peter
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    Secrétaire
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    170761660001
    DANIELS, Anthony Patrick
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Derwent 26 Sydenham Road
    GL52 6EA Cheltenham
    Gloucestershire
    British24297480001
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    British4565330001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    British42825970001
    ASKVIK, Bo Ingema
    Banergatan 49
    FOREIGN Stockholm
    Se-77522
    Sweden
    Administrateur
    Banergatan 49
    FOREIGN Stockholm
    Se-77522
    Sweden
    SwedishChief Financial Officer104367720001
    BERGENHEM, Lars
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    Administrateur
    9 Headfort Place
    SW1 7DE London
    SwedishDirector78626550001
    BOAST, David John
    Greenways Cleeve Hill
    GL52 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Greenways Cleeve Hill
    GL52 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishManaging Director80530700001
    BOAST, David John
    Greenways Cleeve Hill
    GL52 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Greenways Cleeve Hill
    GL52 3PR Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector80530700001
    BOHMAN, Staffan
    Orevagen 21
    167 71 Bromma
    Sweden
    Administrateur
    Orevagen 21
    167 71 Bromma
    Sweden
    SwedishChief Executive Officer107002600001
    BOUVENG, Nils
    Hallinge Gard
    FOREIGN S 57494 Vetlanda
    Sweden
    Administrateur
    Hallinge Gard
    FOREIGN S 57494 Vetlanda
    Sweden
    SwedishDirector24520960001
    COEFFIC, Francois Louis
    Rue Tony Neuman 41
    Luxembourg 2241
    Administrateur
    Rue Tony Neuman 41
    Luxembourg 2241
    FrenchCompany Director80628910001
    ELLIOTT, Leslie Charles
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    5 Parkside Drive
    Long Eaton
    NG10 4AL Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishManaging Director3825910001
    GREENSLADE, Robin Alastair
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishDirector4565340001
    GREENSLADE, Robin Alastair
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    Avonscroft Dock Lane
    Bredon
    GL20 6LG Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishDirector4565340001
    HERRINGTON, Hugh Richard
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Touchwood Grimms Hill
    HP16 9BG Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director6360950001
    PHILLIPS, Derek Edward
    Penquit House
    Ermington
    PL21 0LU Ivybridge
    Devon
    Administrateur
    Penquit House
    Ermington
    PL21 0LU Ivybridge
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director80530550001
    PHILLIPS, Derek Edward
    41 Shaw Green Lane
    Prestbury
    GL52 3BS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    41 Shaw Green Lane
    Prestbury
    GL52 3BS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector6458080001
    RYSTEDT, Carl Fredrik Stenson
    Lidskjalfsvagen 3 Se-182 63
    Djursholm
    Sweden
    Administrateur
    Lidskjalfsvagen 3 Se-182 63
    Djursholm
    Sweden
    SwedishChief Financial Officer78253170001
    SIMONSON, Claes Robert Harry
    Brahegatan 29
    11437 Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Brahegatan 29
    11437 Stockholm
    Sweden
    SwedishDirector2691500004
    SISSONS, Nigel Keith
    37 Willow Bank Road
    GL20 8NJ Alderton
    Gloucestershire
    Administrateur
    37 Willow Bank Road
    GL20 8NJ Alderton
    Gloucestershire
    EnglandBritishManaging Director80321870001
    TATE, James Frederick
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    Administrateur
    c/o Sapa Building Systems
    5300 Severn Drive Tewkesbury Business
    Park Tewkesbury
    GL20 8SF Gloucestershire
    5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park
    United KingdomBritishDirector104611420003
    VINCENT, Nicholas John
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Fairview 68 Sandy Lane
    Charlton Kings
    GL53 9DH Cheltenham
    Gloucestershire
    United KingdomBritishFinancial Director4565330001
    WARTON, Paul
    54 Lea Green Lane
    Wythall
    B47 6HN Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    54 Lea Green Lane
    Wythall
    B47 6HN Birmingham
    West Midlands
    BritishGroup Vice President92652840001
    WESTERBERG, Lars
    Storgatan 38
    11455 Stockholm
    Sweden
    Administrateur
    Storgatan 38
    11455 Stockholm
    Sweden
    SwedishChief Executive Officer64513860002
    WETTERBERG, Kare
    Radmansgatan 18
    FOREIGN Stockholm
    Sweden 11425
    Administrateur
    Radmansgatan 18
    FOREIGN Stockholm
    Sweden 11425
    SwedenSwedishCompany Director86611420001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAPA UK LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Sapa Aluminium Holdings Uk Limited
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Tlt Llp
    England
    02 nov. 2016
    One Redcliff Street
    BS1 6TP Bristol
    Tlt Llp
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited
    Autorité légaleUk Law
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    SAPA UK LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of charge over credit balances
    Créé le 28 oct. 1996
    Livré le 06 nov. 1996
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from lords agricultural machinery limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued
    Brèves mentions
    All sums of money paid by the chargor to the bank pursuant to the deposit contract. Bid number 55551266. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    Letter of set off
    Créé le 01 mars 1984
    Livré le 10 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing & the credit of any present and future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 14 mars 1983
    Livré le 30 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Loncoln Interstate Bank Limited
    Transactions
    • 30 mars 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 14 mars 1983
    Livré le 31 mars 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Scandinavian Bank Limited
    Transactions
    • 31 mars 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0