SAPA UK LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SAPA UK LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01469120 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SAPA UK LIMITED ?
Adresse du siège social | c/o SAPA BUILDING SYSTEMS 5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8SF Gloucestershire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SAPA UK LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour SAPA UK LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 23 pages | AA | ||||||||||
État du capital au 13 juil. 2016
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de James Frederick Tate en tant que directeur le 20 juin 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Nicholas Viner en tant qu'administrateur le 16 juin 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 20 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Simon Nicholas Viner en tant que secrétaire le 23 mars 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Peter Ashby en tant que secrétaire le 23 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 23 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * C/O C/O Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury Gloucestershire GL20 8TX United Kingdom* le 24 févr. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de SAPA UK LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINER, Simon Nicholas | Secrétaire | c/o Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8SF Gloucestershire 5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park | 196239130001 | |||||||
DANIELS, Anthony Patrick | Administrateur | Derwent 26 Sydenham Road GL52 6EA Cheltenham Gloucestershire | England | British | Director | 24297480001 | ||||
VINER, Simon Nicholas | Administrateur | c/o Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8SF Gloucestershire 5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park | England | British | Finance Director | 169860470001 | ||||
ASHBY, David Peter | Secrétaire | c/o Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8SF Gloucestershire 5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park | 170761660001 | |||||||
DANIELS, Anthony Patrick | Secrétaire | Derwent 26 Sydenham Road GL52 6EA Cheltenham Gloucestershire | British | 24297480001 | ||||||
VINCENT, Nicholas John | Secrétaire | Fairview 68 Sandy Lane Charlton Kings GL53 9DH Cheltenham Gloucestershire | British | 4565330001 | ||||||
WHITEHORN, Justin Michael | Secrétaire | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | British | 42825970001 | ||||||
ASKVIK, Bo Ingema | Administrateur | Banergatan 49 FOREIGN Stockholm Se-77522 Sweden | Swedish | Chief Financial Officer | 104367720001 | |||||
BERGENHEM, Lars | Administrateur | 9 Headfort Place SW1 7DE London | Swedish | Director | 78626550001 | |||||
BOAST, David John | Administrateur | Greenways Cleeve Hill GL52 3PR Cheltenham Gloucestershire | British | Managing Director | 80530700001 | |||||
BOAST, David John | Administrateur | Greenways Cleeve Hill GL52 3PR Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 80530700001 | |||||
BOHMAN, Staffan | Administrateur | Orevagen 21 167 71 Bromma Sweden | Swedish | Chief Executive Officer | 107002600001 | |||||
BOUVENG, Nils | Administrateur | Hallinge Gard FOREIGN S 57494 Vetlanda Sweden | Swedish | Director | 24520960001 | |||||
COEFFIC, Francois Louis | Administrateur | Rue Tony Neuman 41 Luxembourg 2241 | French | Company Director | 80628910001 | |||||
ELLIOTT, Leslie Charles | Administrateur | 5 Parkside Drive Long Eaton NG10 4AL Nottingham Nottinghamshire | British | Managing Director | 3825910001 | |||||
GREENSLADE, Robin Alastair | Administrateur | Avonscroft Dock Lane Bredon GL20 6LG Tewkesbury Gloucestershire | British | Director | 4565340001 | |||||
GREENSLADE, Robin Alastair | Administrateur | Avonscroft Dock Lane Bredon GL20 6LG Tewkesbury Gloucestershire | British | Director | 4565340001 | |||||
HERRINGTON, Hugh Richard | Administrateur | Touchwood Grimms Hill HP16 9BG Great Missenden Buckinghamshire | United Kingdom | British | Company Director | 6360950001 | ||||
PHILLIPS, Derek Edward | Administrateur | Penquit House Ermington PL21 0LU Ivybridge Devon | United Kingdom | British | Company Director | 80530550001 | ||||
PHILLIPS, Derek Edward | Administrateur | 41 Shaw Green Lane Prestbury GL52 3BS Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 6458080001 | |||||
RYSTEDT, Carl Fredrik Stenson | Administrateur | Lidskjalfsvagen 3 Se-182 63 Djursholm Sweden | Swedish | Chief Financial Officer | 78253170001 | |||||
SIMONSON, Claes Robert Harry | Administrateur | Brahegatan 29 11437 Stockholm Sweden | Swedish | Director | 2691500004 | |||||
SISSONS, Nigel Keith | Administrateur | 37 Willow Bank Road GL20 8NJ Alderton Gloucestershire | England | British | Managing Director | 80321870001 | ||||
TATE, James Frederick | Administrateur | c/o Sapa Building Systems 5300 Severn Drive Tewkesbury Business Park Tewkesbury GL20 8SF Gloucestershire 5300 Severn Drive,Tewkesbury Business Park | United Kingdom | British | Director | 104611420003 | ||||
VINCENT, Nicholas John | Administrateur | Fairview 68 Sandy Lane Charlton Kings GL53 9DH Cheltenham Gloucestershire | United Kingdom | British | Financial Director | 4565330001 | ||||
WARTON, Paul | Administrateur | 54 Lea Green Lane Wythall B47 6HN Birmingham West Midlands | British | Group Vice President | 92652840001 | |||||
WESTERBERG, Lars | Administrateur | Storgatan 38 11455 Stockholm Sweden | Swedish | Chief Executive Officer | 64513860002 | |||||
WETTERBERG, Kare | Administrateur | Radmansgatan 18 FOREIGN Stockholm Sweden 11425 | Sweden | Swedish | Company Director | 86611420001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SAPA UK LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapa Aluminium Holdings Uk Limited | 02 nov. 2016 | One Redcliff Street BS1 6TP Bristol Tlt Llp England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
SAPA UK LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of charge over credit balances | Créé le 28 oct. 1996 Livré le 06 nov. 1996 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from lords agricultural machinery limited to the chargee on any account whatsoever provided that the total sum recoverable under the security shall not exceed the amount of the deposit(s) together with all interest for the time being accrued | |
Brèves mentions All sums of money paid by the chargor to the bank pursuant to the deposit contract. Bid number 55551266. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Letter of set off | Créé le 01 mars 1984 Livré le 10 nov. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing & the credit of any present and future account of the company with the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 14 mars 1983 Livré le 30 mars 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 14 mars 1983 Livré le 31 mars 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0