CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED

CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01469259
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    • (7487) /

    Où se situe CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2004

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 mai 2014

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    3 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2013

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2012

    5 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's certificate of release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state's certificate of release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2012

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2011

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2011

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2010

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 janv. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 30 juil. 2008

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    1 pages287

    Déclaration des affaires

    6 pages4.20

    Qui sont les dirigeants de CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    VICKERS, Philip
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    Secrétaire
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    BritishAccountant39881280001
    SYNETT, Jacob Julian
    The Old Stables
    Pinnacle Place, Green Lane
    HA7 3AA Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    The Old Stables
    Pinnacle Place, Green Lane
    HA7 3AA Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritishCompany Director78716770002
    VICKERS, Philip
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    Administrateur
    37 Rowanswood Drive
    Godley
    SK14 3SA Hyde
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant39881280001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Secrétaire
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    BritishAccountant54644630001
    HULIN, John Frederick
    3 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    Secrétaire
    3 Queens Road
    Ealing
    W5 2SA London
    BritishAccountant11643680001
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Secrétaire
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Canadian3035310003
    TANNER, Brian Charles
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    Secrétaire
    The Gate House
    Corston
    BA2 9AN Bath
    Avon
    BritishCompany Secretary3185630001
    WHITEHEAD, Derek
    4 Peveril Close
    HP21 9UJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    4 Peveril Close
    HP21 9UJ Aylesbury
    Buckinghamshire
    British5666480001
    EBERHARDT, Martin
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    Administrateur
    39 Broad Ha'Penny
    Boundstone Road
    GU10 4TF Farnham
    Surrey
    EnglandBritishAccountant54644630001
    FERRIE, Graham William
    High Street South
    Tiffield
    NN12 8AB Towcester
    16
    Northamptonshire
    Uk
    Administrateur
    High Street South
    Tiffield
    NN12 8AB Towcester
    16
    Northamptonshire
    Uk
    EnglandBritishAccountant134920060001
    GOLBY, Paul, Dr
    Welford Hill House
    Long Marston Road, Welford On Avon
    CV37 8AE Stratford Upon Avon
    Administrateur
    Welford Hill House
    Long Marston Road, Welford On Avon
    CV37 8AE Stratford Upon Avon
    United KingdomBritishExecutive Director155012180001
    HANNA, Michael
    26 Turpins Avenue
    CO15 5HE Holland On Sea
    Essex
    Administrateur
    26 Turpins Avenue
    CO15 5HE Holland On Sea
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director68319570001
    HEYWOOD, John Axson
    21 Walpole Street
    SW3 4QP London
    Administrateur
    21 Walpole Street
    SW3 4QP London
    BritishChairman32442360001
    JONES, John Stephen Major
    The Elms House
    Twyford
    SO21 1FQ Winchester
    Hants
    Administrateur
    The Elms House
    Twyford
    SO21 1FQ Winchester
    Hants
    BritishChairman Clayhithe Plc35554090001
    LOYNES, Alan
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    25 Molivers Lane
    Bromham
    MK43 8JT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishCompany Director7815680001
    ORROCK, Ian Jackson
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    Administrateur
    The Yardhouse
    Edinample
    FK19 8QE Loch Earn
    Perthshire
    United KingdomBritishDirector34054760010
    RYAN, Peter Henry
    Chalet Vent Du Nord
    Rue Des Gentianes 7
    Crans Sur Sierre
    3963
    Switzerland
    Administrateur
    Chalet Vent Du Nord
    Rue Des Gentianes 7
    Crans Sur Sierre
    3963
    Switzerland
    BritishCompany Director25011740005
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Administrateur
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    CanadianFinance Director Clayhithe Plc3035310003
    SEWELL, Dennis John
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    Administrateur
    Sandhill House
    Middle Claydon
    MK18 2LD Buckingham
    CanadianFinance Director Clayhithe Plc3035310003
    STATHAM, James Edward Anthony
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    Administrateur
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    United KingdomBritishCompany Director150614890001

    CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 12 nov. 2003
    Livré le 21 nov. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 21 nov. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 sept. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A supplemental deed created 18 december 1998,except for the equitable charge over real property
    Créé le 30 déc. 1998
    Livré le 31 déc. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies,obligations and liabilities from time to time owing or incurred under or pursuant to the following documents (together,and each as it may be from time to time amended,varied,novated,supplemented or replaced,the "secured documents"),namely:(i) a facility agreement dated 18 february 1998 and made between the parent (as defined) and others as borrowers (as defined) certain banks and financial institutions (as defined) and the security trustee (as defined) (in its capacity as agent and security trustee) pursuant to which facilities in an aggregate principal sum of up to £29,500,000 were made available to the borrowers.(ii) any ancillary facility letters.(iii) any documents entered into pursuant to the facilities agreement.(iv) the counter-indemnity and deposit deed dated 18 february 1998.(v) the inter-creditor agreement dated 18 february 1998.(vi) the debenture.(vii) the deed
    Brèves mentions
    The deed charges all of the present and future assets of the company.fixed charges over all of the present and future assets of the company of land,interests in land and fixtures.plant,machinery and equipment.stocks,shares,bonds and other securities of any kind.debts and claims.floating charge over all other present and future assets of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Investment Bank PLC on Behalf of Itself and the Banks and Financial Institutions from Timeto Time Parties to the Secured Documents
    Transactions
    • 31 déc. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CLAYHITHE INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2006Commencement of winding up
    12 août 2014Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    practitioner
    Smith & Williamson
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    Joanne Elizabeth Milner
    Smith & Williamson Ltd
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    practitioner
    Smith & Williamson Ltd
    Prospect House
    N20 9YU 2 Athenaeum Road
    London
    Panos Papas
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0