SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED

SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01471726
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fourth Floor
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Clayton Lee Breen en tant qu'administrateur le 30 sept. 2013

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2013

    État du capital au 16 sept. 2013

    • Capital: GBP 7,500
    SH01

    Cessation de la nomination de Thomas Edmund Harrison en tant que directeur le 08 janv. 2013

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Barton-Harvey en tant qu'administrateur le 04 déc. 2012

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Denis St John O'regan en tant que directeur le 22 oct. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Denis St John O'regan en tant que secrétaire le 22 oct. 2012

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 75 Farringdon Road Farringdon Road Fourth Floor London EC1M 3JY le 29 août 2012

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 161-165 Farringdon Road London EC1R 3AL le 28 août 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Edmund Harrison le 01 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARTON-HARVEY, Michael James
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    Administrateur
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    United KingdonBritishManaging Director174405330001
    BREEN, Clayton Lee
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    Administrateur
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    EnglandBritishDirector174187000001
    BESWICK, Graham John
    14 The Woods
    WD7 7HF Radlett
    Hertfordshire
    Secrétaire
    14 The Woods
    WD7 7HF Radlett
    Hertfordshire
    British65585200001
    MARTIN, Anthony James
    Sundown
    Castle Hill, Fawkham
    DA3 7BH Dartford
    Kent
    Secrétaire
    Sundown
    Castle Hill, Fawkham
    DA3 7BH Dartford
    Kent
    British77822620001
    O'REGAN, Denis St John
    450 Hatfield Road
    AL4 0XS St Albans
    Hertfordshire
    Secrétaire
    450 Hatfield Road
    AL4 0XS St Albans
    Hertfordshire
    IrishAccountant36758640003
    THOMAS, Ivor Edward
    5 Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    5 Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishAccountant57430220002
    BESWICK, Graham John
    14 The Woods
    WD7 7HF Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    14 The Woods
    WD7 7HF Radlett
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector65585200001
    FENWICK, Peter
    23 Costells Edge
    Scaynes Hill
    RH17 7PY Haywards Heath
    West Sussex
    Administrateur
    23 Costells Edge
    Scaynes Hill
    RH17 7PY Haywards Heath
    West Sussex
    BritishDirector49182670001
    FOY, John Michael
    152 Westbrooke Road
    DA16 1QE Welling
    Kent
    Administrateur
    152 Westbrooke Road
    DA16 1QE Welling
    Kent
    BritishSales Man48882840001
    HARRISON, Thomas Edmund
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    Administrateur
    75 Farringdon Road
    EC1M 3JY London
    Fourth Floor
    EnglandBritishDirector57388720002
    HAWKINS, Raymond Clive
    Little Scudders
    Scudders Hill
    DA3 8PA Fawkham
    Kent
    Administrateur
    Little Scudders
    Scudders Hill
    DA3 8PA Fawkham
    Kent
    United KingdomBritishPrinter82822060001
    HOLDING, Joanne
    3 Meadowfield
    CW6 9XD Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    3 Meadowfield
    CW6 9XD Tarporley
    Cheshire
    EnglandBritishDirector81016550001
    KACHENMEISTER, James R
    33 Hodford Road
    NW11 8NL London
    Administrateur
    33 Hodford Road
    NW11 8NL London
    AmericanChief Executive Officer80884700001
    MARTIN, Anthony James
    Sundown
    Castle Hill, Fawkham
    DA3 7BH Dartford
    Kent
    Administrateur
    Sundown
    Castle Hill, Fawkham
    DA3 7BH Dartford
    Kent
    UkBritishPrinter77822620001
    O'REGAN, Denis St John
    450 Hatfield Road
    AL4 0XS St Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    450 Hatfield Road
    AL4 0XS St Albans
    Hertfordshire
    EnglandIrishAccountant36758640003
    SNELL, Geoffrey
    36 Farnham Road
    Welling
    DA16 1LQ Kent
    Administrateur
    36 Farnham Road
    Welling
    DA16 1LQ Kent
    BritishProduction Manager95816230001
    THOMAS, Ivor Edward
    5 Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    5 Terry Road
    HP13 6QJ High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritishAccountant57430220002
    VINCENT, Roy Stanley
    33 Capelands
    New Ash Green
    DA3 8LG Longfield
    Kent
    Administrateur
    33 Capelands
    New Ash Green
    DA3 8LG Longfield
    Kent
    BritishProduction Man48882930001
    WHEELER, Herbert Lionel
    Boswidden Farm
    Fore Street
    TR14 0QF Penponds
    Cornwall
    Administrateur
    Boswidden Farm
    Fore Street
    TR14 0QF Penponds
    Cornwall
    BritishDirector72154780001
    WRIGHT, Michael John
    Lancers 212 Norsey Road
    CM11 1DB Billericay
    Essex
    Administrateur
    Lancers 212 Norsey Road
    CM11 1DB Billericay
    Essex
    BritishChairman9021760001

    SARKPOINT REPROGRAPHICS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 19TH december 1997
    Créé le 01 juin 1998
    Livré le 06 juin 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any group company (as defined) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC,as Security Trustee for the Security Beneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 06 juin 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 07 janv. 1993
    Livré le 15 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    For full details see form 395 tc ref: M530C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 janv. 1991
    Livré le 31 janv. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as unit 2 gartons way battersea london title no. Tgl 43424.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1991Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 avr. 1985
    Livré le 04 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £42,000
    Brèves mentions
    Unit 3 william road development william road, london NW1.
    Personnes ayant droit
    • C.P. Roberts & Company Limited
    • London Land Investment & Property Limited
    Transactions
    • 04 mai 1985Enregistrement d'une charge
    • 18 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 18 avr. 1985
    Livré le 23 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £125,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Floating charge undertaking and all property and assets present and future fixed charge upon unit 3 william road development william road london. And th e goodwill of the company.
    Personnes ayant droit
    • Allied Irish Finance Co. Limited
    Transactions
    • 23 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 03 juin 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0