CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01471805
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HILLINGS INVESTMENTS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    SLICKBOROUGH LIMITED08 janv. 198008 janv. 1980

    Quels sont les derniers comptes de CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mai 2017 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Timothy Saunders en tant que directeur le 12 août 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mai 2016

    État du capital au 26 mai 2016

    • Capital: GBP 442
    SH01

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré The White House 10 Clifton York YO30 6AE

    1 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à The White House 10 Clifton York YO30 6AE

    1 pagesAD02

    Cessation de la nomination de Christopher Robin Leslie Phillips en tant que directeur le 14 mars 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital18 mai 2015

    État du capital au 18 mai 2015

    • Capital: GBP 442
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Robin Leslie Phillips le 16 mai 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 mai 2014

    État du capital au 21 mai 2014

    • Capital: GBP 442
    SH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Christopher Paul Martin le 16 mai 2014

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées du secrétaire Christopher Paul Martin le 16 mai 2014

    1 pagesCH03

    Changement d'adresse du siège social de , 305 Grays Inn Road, London, WC1X 8QR, United Kingdom le 16 mai 2014

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2013

    7 pagesAA

    Nomination de Christopher Paul Martin en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARTIN, Christopher Paul
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Secrétaire
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    British178775380001
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director108543490005
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    BUSTIN, Desmond John
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    Secrétaire
    Church Farm House
    Stapleford
    SP3 4LN Salisbury
    Wiltshire
    British31260040002
    REID, Christopher
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Whitecrest
    Narrow Path Aspley Heath
    MK17 8TF Woburn Sands
    Buckinghamshire
    BritishCompany Secretary157947720001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Secrétaire
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    British15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    Secrétaire
    Beckets Place
    Marksbury
    BA2 9HP Bath
    Avon
    BritishCompany Director47952140001
    REID & CO PROFESSIONAL SERVICES LIMITED
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Witan Court
    305 Upper Fourth Street
    MK9 1EH Central Milton Keynes
    Buckinghamshire
    41052090008
    ROXBURGH MILKINS LLP
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    Secrétaire
    Merchants House North
    Wapping Road
    BS1 4RW Bristol
    114974370003
    BUSTIN, Desmond John
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Woodacre
    West Goheldon
    SP4 3OG Salisbury
    Wiltshire
    BritishDirector31260040001
    CHAMPION, Mark Alistair
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    Administrateur
    Crescent Office Park
    Clarks Way
    BA2 2AF Bath
    2
    EnglandBritishDirector76512840002
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Administrateur
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishDirector87647990001
    HOLLINGWORTH, Neil Gregory
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    Administrateur
    Bridge House
    Addington
    MK18 2JX Winslow
    Bucks
    United KingdomBritishCompany Director87647990001
    HUNT, Alan Edward
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    37 Main Road
    Drayton Parslow
    MK17 0JR Milton Keynes
    Buckinghamshire
    BritishDirector74704080001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishChairman46176700002
    SAMBROOK, Christiane Marie
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Administrateur
    134 Kensington Drive
    Great Holm
    MK8 9BN Milton Keynes
    Bucks
    Anglo-FrenchProperty Management36197920001
    SANDERS, Karen Lesley
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    Administrateur
    28 High Street
    LU7 Stewkley
    Beds
    BritishDirector15772130001
    SAUNDERS, Timothy
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    Administrateur
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    EnglandBritishCompany Director47952140001
    SELL, Karen Elizabeth
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    2 Osterley Close
    MK16 0EZ Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    BritishAccounts Manager36197970001
    STAPLEFORD MANAGEMENT LIMITED
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    Administrateur
    Witan Court 305 Upper Fourth Street
    Central Milton Keynes
    MK9 1EH Milton Keynes
    48564730001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Touchstone Corporate Property Services Limited
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    06 avr. 2016
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementRegistrar Of Companies For England & Wales
    Numéro d'enregistrement4695692
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CASTLE ESTATES RELOCATION SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 févr. 2008
    Livré le 21 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nvm Private Equity Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 13 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Neil Gregory Hollingworth
    Transactions
    • 13 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 29 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of intellectual property rights
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The company assigned to the bank all the company's right title and interest in and to the intellectual property rights throughout the world excluding the third party rights and all applications and all the company's rights title and interest in and to the applications. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H - castle estates dawson road mount farm milton keynes t/no BM245239. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 11 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 juin 2006
    Livré le 30 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Northern Venture Managers Limited
    Transactions
    • 30 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 18 juin 2009Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 13 sept. 2002
    Livré le 18 sept. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land on the south side of dawson road mount farm industrial estate central milton keynes t/n BM245239. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 18 sept. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 févr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 2002
    Livré le 20 août 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage deed
    Créé le 21 mai 2002
    Livré le 31 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The l/h property 8 aymer house new church rd hove. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 31 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit account agreement
    Créé le 11 juin 1999
    Livré le 17 juin 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to clause 2 of the agreement
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of the rent deposit account including all interest.
    Personnes ayant droit
    • Joy Frances Gooding
    Transactions
    • 17 juin 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 févr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 15 août 1996
    Livré le 27 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 24 juin 1993
    Livré le 14 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or castle estates (milton keynes) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 14 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 21 déc. 1992
    Livré le 05 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The whole or any part of the rents or other money due from the company to the chargee under a lease dated 21/12/92
    Brèves mentions
    A separate designated interest earning account at a clearing bank or recognised building society opened or to be opened in the name of the chargee having an initial balance of £1,482.50 together with all sums subsequently paid into this said account.
    Personnes ayant droit
    • Manteca Limited
    Transactions
    • 05 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of rental deposit
    Créé le 25 mars 1992
    Livré le 08 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The obligations of the company to manteca limited under a lease dated 25/03/92 and this deed
    Brèves mentions
    All the interest of the company in the amount from time to time standing to the credit of a designated interest lending account.
    Personnes ayant droit
    • Manteca Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 août 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 août 1989
    Livré le 17 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 17 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 19 juin 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 02 févr. 1981
    Livré le 04 févr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H premises situate at and known as number 30 bridge street olney. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 févr. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0