RUBY DCO THREE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RUBY DCO THREE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01473085 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RUBY DCO THREE LIMITED ?
Adresse du siège social | Office 5, International House Cray Avenue BR5 3RS Orpington England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RUBY DCO THREE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour RUBY DCO THREE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 août 2023 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Graham Wiseman en tant que directeur le 31 août 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Thorsten Sprank en tant qu'administrateur le 31 août 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Sapphire Court Walsgrave Triangle Coventry CV2 2TX à Office 5, International House Cray Avenue Orpington BR5 3RS le 04 sept. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed added marketing LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
État du capital au 15 août 2023
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 17 oct. 2022 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 33 pages | MA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Wendy Margaret Hall en tant que directeur le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Nichola Louise Legg en tant que secrétaire le 09 sept. 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration des objets de la société | 2 pages | CC04 | ||||||||||||||
Nomination de Graham Wiseman en tant qu'administrateur le 07 sept. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christian Keen en tant que directeur le 18 mai 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 3 pages | AA | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RUBY DCO THREE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPRANK, Thorsten | Administrateur | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | Accountant | 203900280002 | ||||
BRIERLEY, Jennifer Anne | Secrétaire | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
DAVIES, John Richard Bridge | Secrétaire | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
HEATON, Janet Ruth | Secrétaire | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
LEGG, Nichola Louise | Secrétaire | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | 163214890001 | |||||||
MURPHY, Francis Joseph | Secrétaire | Oakmere Murieston Road WA15 9SU Hale Cheshire | British | 32866430003 | ||||||
SMERDON, Peter | Secrétaire | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
BEER, Thorsten | Administrateur | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Cfo | 172030260001 | ||||
GIBSON, Colin | Administrateur | Amos Farmhouse Main Street South Scarle NG23 7JH Newark Nottinghamshire | British | Company Director | 6964010002 | |||||
GREENHALGH, Gary | Administrateur | Washdyke Farm Lincoln Road NG32 3HY Fulbeck Lincolnshire | United Kingdom | British | Company Director | 1192810001 | ||||
HALL, Wendy Margaret | Administrateur | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | Solicitor | 172979860001 | ||||
HILGER, Marcus | Administrateur | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | Germany | German | Finance Director | 238936580003 | ||||
HOOD, John | Administrateur | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | Finance Director | 39644740002 | |||||
KEEN, Christian | Administrateur | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | England | British | Chief Finance Officer | 54544790004 | ||||
KERSHAW, Graham Anthony | Administrateur | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | Director | 8991780003 | ||||
LIPP, Hanns Martin | Administrateur | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry | United Kingdom | German | Finance Director | 220582440001 | ||||
MEISTER, Stefan Mario | Administrateur | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | Company Director | 43550520003 | |||||
MISCHKE, Gerhard Viktor | Administrateur | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | Chief Finance Officer | 62107000001 | |||||
REVELL, Anthony William | Administrateur | 26 Ryland Road Welton LN2 3LU Lincoln | British | Company Director | 980590001 | |||||
SHEPHERD, William | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | Solicitor | 162873980001 | ||||
SMERDON, Peter | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Company Secretary | 16898700002 | ||||
TAYLOR, David Leslie | Administrateur | Woodbank Wilmslow Park SK9 2BA Wilmslow Cheshire | Gb-Eng | British | Pharmacist | 10776940001 | ||||
VIZARD, Ronald Charles, Harold | Administrateur | Fieldfare Pigeon Green, Snitterfield CV37 OLP Stratford-Upon-Avon Warwickshire | British | Chartered Accountant | 122881190001 | |||||
WALLIS, Andrew Leonard | Administrateur | The Old Rectory Church Street South Collingham NG23 7LH Newark Nottinghamshire | British | Chartered Accountant | 681750001 | |||||
WILLETTS, Andrew John | Administrateur | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | Chartered Accountant | 120451550002 | ||||
WISEMAN, Graham | Administrateur | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | British | Business Consultant | 299860960001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RUBY DCO THREE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunamis Mind Accelerator Limited | 31 août 2023 | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Admenta Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
RUBY DCO THREE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Single debenture | Créé le 22 déc. 1986 Livré le 31 déc. 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 25 juil. 1986 Livré le 06 août 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All sums due and owing to the company whether on account of its trading or otherwise any credit or credit balance standing in any bank account of the company. All manufacturing goods and raw materials and all sale stock of the company (for full details see form 395 relevant to this charge). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge | Créé le 01 nov. 1982 Livré le 08 nov. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present andfuture including bookdebts, other debts & uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0