BRANCHAND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRANCHAND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01473669
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRANCHAND LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BRANCHAND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    80 Station Parade
    Harrogate
    HG1 1HQ North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRANCHAND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour BRANCHAND LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour BRANCHAND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    6 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    État du capital au 22 mai 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2009

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    8 pages363s

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    7 pages363s

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Qui sont les dirigeants de BRANCHAND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CALVERT, Mark Richard, Mr.
    High Bond End
    HG5 9BT Knaresborough
    Kirkman Bank
    North Yorkshire
    Secrétaire
    High Bond End
    HG5 9BT Knaresborough
    Kirkman Bank
    North Yorkshire
    British44425360003
    CALVERT, Mark Richard, Mr.
    High Bond End
    HG5 9BT Knaresborough
    Kirkman Bank
    North Yorkshire
    Administrateur
    High Bond End
    HG5 9BT Knaresborough
    Kirkman Bank
    North Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director44425360003
    HARCOURT, Peter James Rolston
    The Garth
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    North Yorkshire
    Administrateur
    The Garth
    North Rigton
    LS17 0DJ Leeds
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector72476310002
    WHISKERD, David Austen
    121 Moffats Lane
    AL9 7RP Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    121 Moffats Lane
    AL9 7RP Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector103890940001
    CALVERT, Hazel Anne
    Quantum
    73 Sheering Road
    CM17 0JN Old Harlow
    Essex
    Secrétaire
    Quantum
    73 Sheering Road
    CM17 0JN Old Harlow
    Essex
    BritishDirector86884430001
    CALVERT, Mark Richard
    Foxwood House 64 Kent Road
    HG1 2NL Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Foxwood House 64 Kent Road
    HG1 2NL Harrogate
    North Yorkshire
    British44425360002
    COOPER, Joan Kyle
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secrétaire
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishCompany Secretary10015030001
    PERKINS, Marion Ann
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    Secrétaire
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    British17300520001
    SZCZEPANSKI, Jan
    16 Durkar Rise
    Crigglestone
    WF4 3QB Wakefield
    West Yorkshire
    Secrétaire
    16 Durkar Rise
    Crigglestone
    WF4 3QB Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector10925740001
    WILTON, David Charles
    27 Kent Road
    HG1 2LJ Harrogate
    North Yorkshire
    Secrétaire
    27 Kent Road
    HG1 2LJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector99414270001
    CALVERT, Hazel Anne
    Quantum
    73 Sheering Road
    CM17 0JN Old Harlow
    Essex
    Administrateur
    Quantum
    73 Sheering Road
    CM17 0JN Old Harlow
    Essex
    BritishDirector86884430001
    COOPER, Joan Kyle
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    BritishCompany Secretary10015030001
    COOPER, Kenneth Owen
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Micawber House White Elm Road
    Woolpit
    IP30 9SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    United KingdomBritishManaging Director10015040001
    PERKINS, Anton Spencer
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    Administrateur
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    BritishOperations Manager48341970001
    PERKINS, Marion Ann
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    Administrateur
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    BritishAdministrative Controller17300520001
    PERKINS, Stuart Melvyn
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    Administrateur
    12 Ketts Close
    NR18 0NB Wymondham
    Norfolk
    BritishIndustrial Cleaner17300530001
    PIRRIE, Michael
    Bosmere Cottage
    Duke Street Haughley
    IP14 3QS Stowmarket
    Suffolk
    Administrateur
    Bosmere Cottage
    Duke Street Haughley
    IP14 3QS Stowmarket
    Suffolk
    EnglandBritishManager124359150001
    SZCZEPANSKI, Jan
    16 Durkar Rise
    Crigglestone
    WF4 3QB Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    16 Durkar Rise
    Crigglestone
    WF4 3QB Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector10925740001
    WILTON, David Charles
    27 Kent Road
    HG1 2LJ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    27 Kent Road
    HG1 2LJ Harrogate
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector99414270001

    BRANCHAND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 janv. 2003
    Livré le 21 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 10 janv. 2003
    Livré le 21 janv. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 19 août 1999
    Livré le 28 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 janv. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 1993
    Livré le 29 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Unit 6 ashwell thorpe industrial estate ashwell thorpe norwich norfolk. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 02 juin 1983
    Livré le 07 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 20 oct. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0