MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED

MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01475098
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Seven Stars House 1 Wheler Road
    Whitley
    CV3 4LB Coventry
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MARRS PROPERTY INVESTMENTS LIMITED27 oct. 199527 oct. 1995
    VENG (UK) LIMITED09 nov. 198809 nov. 1988
    ERIK VENG (U.K.) LIMITED24 janv. 198024 janv. 1980

    Quels sont les derniers comptes de MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de David Marrs en tant que directeur le 25 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de David Marrs en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 déc. 2020

    1 pagesPSC07

    Changement d'adresse du siège social de 15 Queens Road Coventry West Midlands CV1 3DE à Seven Stars House 1 Wheler Road Whitley Coventry CV3 4LB le 24 nov. 2020

    2 pagesAD01

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 12 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital14 août 2015

    État du capital au 14 août 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 août 2014

    État du capital au 12 août 2014

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Marrs le 08 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeanette Elizabeth Marrs le 08 oct. 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Jeanette Elizabeth Marrs le 08 oct. 2013

    2 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 août 2013

    État du capital au 20 août 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    Qui sont les dirigeants de MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRS, Jeanette Elizabeth
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    Secrétaire
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    BritishCompany Director29058270004
    MARRS, Jeanette Elizabeth
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    Administrateur
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishCompany Director29058270005
    BELL, Janice
    100 Monks Road
    Binley Woods
    CV3 2BY Coventry
    West Midlands
    Secrétaire
    100 Monks Road
    Binley Woods
    CV3 2BY Coventry
    West Midlands
    British18163140001
    MARRS, David
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    Administrateur
    7 The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood
    West Midlands
    England
    EnglandBritishCompany Director8633580004
    MARSH, William John
    4 The Elms
    Leek Wootton
    CV35 7RR Warwick
    Warwickshire
    Administrateur
    4 The Elms
    Leek Wootton
    CV35 7RR Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritishAccountant29023780001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr David Marrs
    The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood 7
    West Midlands
    06 avr. 2016
    The Crescent
    Hampton-In-Arden
    B92 0BN Solihull
    Oakwood 7
    West Midlands
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MARRS PROPERTY & INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 01 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 01 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises at whittle road/fleming road harrowbrook harrowbrook industrial estate hinckley. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 01 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises at 169 newton road harrowbrook industrial estate hinckley. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 29 nov. 1993
    Livré le 01 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Premises in newton road harrowbrook industrial estate hinckley. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 01 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 14 juil. 1993
    Livré le 15 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a or being land or buildings on the south side of flemming road hinckley leicestershire t/no LT214980. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Unibank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 06 avr. 1992
    Livré le 16 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 169 newyon road, hinckley, leicestershire, title number LT178113. F/h unit 7 harrowbrook road, hinckley, leicestershire, title number LT182337. See form 395 relevant to this charge.
    Personnes ayant droit
    • Unibank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 avr. 1992
    Livré le 14 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £310,000 due from the company to the chargee pursuant to clause 2.4 of a contract for sale dated 23 march 1992 together with all monies under the terms of the legal charge dated 6 april 1992
    Brèves mentions
    F/H- 169 newton road hinckley t/n-LT178113. F/h- unit 7 harrowbrook road hinckley t/n-LT183337 (see form 395 and contd sheets for full details).
    Personnes ayant droit
    • Lex Service PLC
    Transactions
    • 14 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 mars 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 06 avr. 1992
    Livré le 10 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    See doc ref M752C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Unibank PLC
    Transactions
    • 10 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 oct. 1989
    Livré le 31 oct. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Privatbanker Limited
    Transactions
    • 31 oct. 1989Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 juin 1986
    Livré le 19 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Privatbanken Limited.
    Transactions
    • 19 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 26 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 sept. 1985
    Livré le 11 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    • 04 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 24 juil. 1985
    Livré le 29 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • S.H. Lock & Co. Limited.
    Transactions
    • 29 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 13 juin 1980
    Livré le 19 juin 1980
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges on underaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts and uncalled capital. With all buildings, fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 19 juin 1980Enregistrement d'une charge
    • 04 avr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0