SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED

SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01475221
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Marrons 1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée

    2 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 sept. 2013

    État du capital au 25 sept. 2013

    • Capital: GBP 300,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de John Doris en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur

    1 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Marrons Consultancies Limited le 24 sept. 2010

    1 pagesCH04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    18 pagesAA

    Divers

    Section 519
    1 pagesMISC

    Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 Angel Court, 33 Burley Road, Leeds West Yorkshire LS3 1JT* le 12 déc. 2009

    1 pagesAD01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    14 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    3 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    Qui sont les dirigeants de SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    1 Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    Leicestershire
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement01708508
    65475060002
    LYNCH, Peter Eugene
    Kerrymount Avenue
    Foxrock
    Sanabria
    Dublin 18
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    Kerrymount Avenue
    Foxrock
    Sanabria
    Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant96288470001
    ANGEL, Barry Paul
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    41 Frampton Way
    Totton
    SO40 9AD Southampton
    Hampshire
    BritishBus Exec9549440001
    COX, Ian
    Hoppits 20a Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    Essex
    Secrétaire
    Hoppits 20a Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    Essex
    BritishAccountant84945710001
    CROWSON, Christine
    Highwood Millfield
    Harrogate Road
    LS17 9JB Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Highwood Millfield
    Harrogate Road
    LS17 9JB Leeds
    West Yorkshire
    British30597230003
    CROWSON, John Peter
    Highwood Millfield Harrogate Road
    Alwoodley
    LS17 9JB Leeds
    Secrétaire
    Highwood Millfield Harrogate Road
    Alwoodley
    LS17 9JB Leeds
    British5035320002
    GAUNTLEY, Simon Paul
    Oak House
    Chelmsford Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TH Maldon
    Essex
    Secrétaire
    Oak House
    Chelmsford Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TH Maldon
    Essex
    BritishAccountant96089590001
    PATERSON, Amanda Louise
    52 Berrington Way
    Oakworth
    BD22 7SQ Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    52 Berrington Way
    Oakworth
    BD22 7SQ Keighley
    West Yorkshire
    British68538360001
    CAHN, Nicholas
    158 Elm Road
    New Malden
    KT3 3HT Malden
    Surrey
    Administrateur
    158 Elm Road
    New Malden
    KT3 3HT Malden
    Surrey
    BritishDirector97809500001
    COX, Ian
    Hoppits 20a Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    Essex
    Administrateur
    Hoppits 20a Great Oaks
    Hutton
    CM13 1AZ Brentwood
    Essex
    BritishAccountant84945710001
    CREECHAN, Kevin
    5 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    Administrateur
    5 Regency Court
    ML3 7EA Hamilton
    Lanarkshire
    ScotlandBritishDirector76092340002
    CROWSON, Christine
    Highwood Millfield
    Harrogate Road
    LS17 9JB Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Highwood Millfield
    Harrogate Road
    LS17 9JB Leeds
    West Yorkshire
    BritishSecretary30597230003
    CROWSON, John Peter
    Highwood Millfield Harrogate Road
    Alwoodley
    LS17 9JB Leeds
    Administrateur
    Highwood Millfield Harrogate Road
    Alwoodley
    LS17 9JB Leeds
    EnglandBritishPrinter5035320002
    CROWSON, Peter James
    9 Windermere Drive
    Alwoodley
    LS17 7UL Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    9 Windermere Drive
    Alwoodley
    LS17 7UL Leeds
    West Yorkshire
    BritishPrinter76071210002
    DELANY, Martin
    2 St. Ann's
    Ailesbury Road
    IRISH Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    2 St. Ann's
    Ailesbury Road
    IRISH Dublin 4
    Dublin
    Ireland
    IrishCo Director92904750001
    DELANY, Martin
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    79 Merrion Village
    Merrion Road
    Dublin 4
    Ireland
    IrishCompany Director44130110002
    DORIS, John
    58 Cabinteely Green
    IRISH Dublin 18
    Dublin
    Ireland
    Administrateur
    58 Cabinteely Green
    IRISH Dublin 18
    Dublin
    Ireland
    IrelandIrishCompany Director123364040001
    GANNON, Michael
    86 The Maples
    Clonskeagh
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    Administrateur
    86 The Maples
    Clonskeagh
    IRISH Dublin 14
    Ireland
    IrishAccountant106733370001
    GAUNTLEY, Simon Paul
    Oak House
    Chelmsford Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TH Maldon
    Essex
    Administrateur
    Oak House
    Chelmsford Road, Woodham Mortimer
    CM9 6TH Maldon
    Essex
    EnglandBritishFinance Director96089590001
    HURLEY, Donnacha
    7 Woodlands Park
    Mount Merrion Avenue
    IRISH Blackrock
    Ireland
    Administrateur
    7 Woodlands Park
    Mount Merrion Avenue
    IRISH Blackrock
    Ireland
    IrelandIrishChief Executive126079140002
    JORDAN, Alan James
    Hindhead Brae
    Tilford Road
    GU26 6SJ Hindhead
    Surrey
    Administrateur
    Hindhead Brae
    Tilford Road
    GU26 6SJ Hindhead
    Surrey
    EnglandIrishCo Director150320720001
    KEARNS, Patrick
    Westcott
    Nerano Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Westcott
    Nerano Road
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrishCo Director14300570001
    LILLIS, James Anthony
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    Administrateur
    10 Offington Drive
    Sutton
    13 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director49070590001
    PATERSON, Amanda Louise
    52 Berrington Way
    Oakworth
    BD22 7SQ Keighley
    West Yorkshire
    Administrateur
    52 Berrington Way
    Oakworth
    BD22 7SQ Keighley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant68538360001
    SODEN, Philip
    2 Brennansrown Vale
    Carrickmines
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    Administrateur
    2 Brennansrown Vale
    Carrickmines
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    IrishChartered Accountant41013270001
    WESTMAN, Lawrence
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    Administrateur
    Whitescross
    Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Newpark House
    Ireland
    IrelandIrishChartered Accountant241846320001

    SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 déc. 2003
    Livré le 12 déc. 2003
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 12 déc. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2004Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1998
    Livré le 05 janv. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liabilities of the company to the chargee (the "trustee") and/or the banks under or in connection with the financing documents (as defined)
    Brèves mentions
    All f/h or l/h property owned by the chargor at the date of the debenture including l/h land k/a 94 kirkstall road,leeds LS31LT.t/no.WYK538695 and l/h land k/a unit e barley hill trading estate,burley road,leeds.first equitable mortgage its interest in any f/h or l/h property acquired by the chargor after the date of the debenture.all existing and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property including a komori lithrone L540 five colour offset printing press.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 05 janv. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2002Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 12 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattel mortgage
    Créé le 07 juin 1994
    Livré le 10 juin 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £686,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Komori lithrone L540 ii five colour offset printing press serial no. 565.
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 10 juin 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 févr. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 08 sept. 1993
    Livré le 23 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    94 kirkstall road leeds west yorkshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 juil. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge over book debts
    Créé le 11 janv. 1989
    Livré le 19 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a factoring agreement of even date.
    Brèves mentions
    All book & other debts now and from time to time hereafter due or owing to or purchased or otherwise acquired by the company (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Commercial Services Limited
    Transactions
    • 19 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0