SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01475221 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?
Adresse du siège social | Marrons 1 Meridian South Meridian Business Park LE19 1WY Leicester Leicestershire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2011 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Doris en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur | 1 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2010 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Marrons Consultancies Limited le 24 sept. 2010 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2009 | 18 pages | AA | ||||||||||
Divers Section 519 | 1 pages | MISC | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 Angel Court, 33 Burley Road, Leeds West Yorkshire LS3 1JT* le 12 déc. 2009 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2008 | 11 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2007 | 14 pages | AA | ||||||||||
legacy | 3 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 3 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 2 pages | 288a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b | ||||||||||
legacy | 1 pages | 288b |
Qui sont les dirigeants de SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARRONS CONSULTANCIES LIMITED | Secrétaire | 1 Meridian South Meridian Business Park LE19 1WY Leicester Leicestershire |
| 65475060002 | ||||||||||
LYNCH, Peter Eugene | Administrateur | Kerrymount Avenue Foxrock Sanabria Dublin 18 Republic Of Ireland | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 96288470001 | ||||||||
ANGEL, Barry Paul | Secrétaire | 41 Frampton Way Totton SO40 9AD Southampton Hampshire | British | Bus Exec | 9549440001 | |||||||||
COX, Ian | Secrétaire | Hoppits 20a Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood Essex | British | Accountant | 84945710001 | |||||||||
CROWSON, Christine | Secrétaire | Highwood Millfield Harrogate Road LS17 9JB Leeds West Yorkshire | British | 30597230003 | ||||||||||
CROWSON, John Peter | Secrétaire | Highwood Millfield Harrogate Road Alwoodley LS17 9JB Leeds | British | 5035320002 | ||||||||||
GAUNTLEY, Simon Paul | Secrétaire | Oak House Chelmsford Road, Woodham Mortimer CM9 6TH Maldon Essex | British | Accountant | 96089590001 | |||||||||
PATERSON, Amanda Louise | Secrétaire | 52 Berrington Way Oakworth BD22 7SQ Keighley West Yorkshire | British | 68538360001 | ||||||||||
CAHN, Nicholas | Administrateur | 158 Elm Road New Malden KT3 3HT Malden Surrey | British | Director | 97809500001 | |||||||||
COX, Ian | Administrateur | Hoppits 20a Great Oaks Hutton CM13 1AZ Brentwood Essex | British | Accountant | 84945710001 | |||||||||
CREECHAN, Kevin | Administrateur | 5 Regency Court ML3 7EA Hamilton Lanarkshire | Scotland | British | Director | 76092340002 | ||||||||
CROWSON, Christine | Administrateur | Highwood Millfield Harrogate Road LS17 9JB Leeds West Yorkshire | British | Secretary | 30597230003 | |||||||||
CROWSON, John Peter | Administrateur | Highwood Millfield Harrogate Road Alwoodley LS17 9JB Leeds | England | British | Printer | 5035320002 | ||||||||
CROWSON, Peter James | Administrateur | 9 Windermere Drive Alwoodley LS17 7UL Leeds West Yorkshire | British | Printer | 76071210002 | |||||||||
DELANY, Martin | Administrateur | 2 St. Ann's Ailesbury Road IRISH Dublin 4 Dublin Ireland | Irish | Co Director | 92904750001 | |||||||||
DELANY, Martin | Administrateur | 79 Merrion Village Merrion Road Dublin 4 Ireland | Irish | Company Director | 44130110002 | |||||||||
DORIS, John | Administrateur | 58 Cabinteely Green IRISH Dublin 18 Dublin Ireland | Ireland | Irish | Company Director | 123364040001 | ||||||||
GANNON, Michael | Administrateur | 86 The Maples Clonskeagh IRISH Dublin 14 Ireland | Irish | Accountant | 106733370001 | |||||||||
GAUNTLEY, Simon Paul | Administrateur | Oak House Chelmsford Road, Woodham Mortimer CM9 6TH Maldon Essex | England | British | Finance Director | 96089590001 | ||||||||
HURLEY, Donnacha | Administrateur | 7 Woodlands Park Mount Merrion Avenue IRISH Blackrock Ireland | Ireland | Irish | Chief Executive | 126079140002 | ||||||||
JORDAN, Alan James | Administrateur | Hindhead Brae Tilford Road GU26 6SJ Hindhead Surrey | England | Irish | Co Director | 150320720001 | ||||||||
KEARNS, Patrick | Administrateur | Westcott Nerano Road IRISH Dalkey County Dublin Ireland | Ireland | Irish | Co Director | 14300570001 | ||||||||
LILLIS, James Anthony | Administrateur | 10 Offington Drive Sutton 13 Dublin Ireland | Irish | Company Director | 49070590001 | |||||||||
PATERSON, Amanda Louise | Administrateur | 52 Berrington Way Oakworth BD22 7SQ Keighley West Yorkshire | British | Chartered Accountant | 68538360001 | |||||||||
SODEN, Philip | Administrateur | 2 Brennansrown Vale Carrickmines IRISH Dublin 18 Ireland | Irish | Chartered Accountant | 41013270001 | |||||||||
WESTMAN, Lawrence | Administrateur | Whitescross Foxrock IRISH Dublin 18 Newpark House Ireland | Ireland | Irish | Chartered Accountant | 241846320001 |
SPEEDPRINT (HORSFORTH) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 08 déc. 2003 Livré le 12 déc. 2003 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 déc. 1998 Livré le 05 janv. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All liabilities of the company to the chargee (the "trustee") and/or the banks under or in connection with the financing documents (as defined) | |
Brèves mentions All f/h or l/h property owned by the chargor at the date of the debenture including l/h land k/a 94 kirkstall road,leeds LS31LT.t/no.WYK538695 and l/h land k/a unit e barley hill trading estate,burley road,leeds.first equitable mortgage its interest in any f/h or l/h property acquired by the chargor after the date of the debenture.all existing and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property including a komori lithrone L540 five colour offset printing press.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Chattel mortgage | Créé le 07 juin 1994 Livré le 10 juin 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti £686,400 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions Komori lithrone L540 ii five colour offset printing press serial no. 565. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 08 sept. 1993 Livré le 23 sept. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 94 kirkstall road leeds west yorkshire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Charge over book debts | Créé le 11 janv. 1989 Livré le 19 janv. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a factoring agreement of even date. | |
Brèves mentions All book & other debts now and from time to time hereafter due or owing to or purchased or otherwise acquired by the company (for full details see form 395). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0