WESTEX LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWESTEX LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01475497
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WESTEX LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe WESTEX LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WESTEX LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour WESTEX LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    37 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    34 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    35 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    58 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    68 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Leytonstone House Leytonstone London E11 1GA à Jupiter House Warley Hill Business Park the Drive Brentwood Essex CM13 3BE le 16 oct. 2019

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Robert Anthony Keable en tant que directeur le 30 sept. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ashok Ram en tant que secrétaire le 30 août 2019

    2 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 014754970009 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 014754970010, créée le 22 mai 2019

    37 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 014754970008 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable précédente prolongée du 31 août 2018 au 28 févr. 2019

    1 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 014754970007 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 août 2017

    26 pagesAA

    Inscription de la charge 014754970009, créée le 25 mai 2018

    17 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 30 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Ashok Ram en tant que secrétaire le 30 juin 2017

    3 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Roy Paul Vesey en tant que secrétaire le 30 juin 2017

    2 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 août 2016

    24 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de WESTEX LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MASHRU, Kantilal
    55 Pembroke Road
    IG3 8PQ Ilford
    Essex
    Secrétaire
    55 Pembroke Road
    IG3 8PQ Ilford
    Essex
    BritishAccountant34782060002
    RAM, Ashok
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    Secrétaire
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    236674350001
    ROWAT, Michael Wilson
    6 Goodwood Lodge
    Church Paddock Court
    SM6 7AF Wallington
    Secrétaire
    6 Goodwood Lodge
    Church Paddock Court
    SM6 7AF Wallington
    British13987000002
    VESEY, Roy Paul
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    Secrétaire
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    British100319920003
    FRYER, Andrew Robert
    Black Hall
    SG9 0AU Brent Pelham
    Hertfordshire
    Administrateur
    Black Hall
    SG9 0AU Brent Pelham
    Hertfordshire
    EnglandBritishChairman9255090003
    KEABLE, Robert Anthony
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    Administrateur
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    EnglandBritishManaging Director113142420002
    MACLEAN, Persa
    22 Tile Farm Road
    BR6 9RZ Orpington
    Kent
    Administrateur
    22 Tile Farm Road
    BR6 9RZ Orpington
    Kent
    BritishClient Services Director72750050002
    PEARCE, Howard Charles
    Thatch End Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    Thatch End Stickling Green
    Clavering
    CB11 4QX Saffron Walden
    Essex
    BritishCompany Director9255080001
    ROWAT, Michael Wilson
    6 Goodwood Lodge
    Church Paddock Court
    SM6 7AF Wallington
    Administrateur
    6 Goodwood Lodge
    Church Paddock Court
    SM6 7AF Wallington
    BritishDirector13987000002
    SANDERS, David
    Thrimley House Thrimley Lane
    Farnham
    CM23 1HX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Thrimley House Thrimley Lane
    Farnham
    CM23 1HX Bishops Stortford
    Hertfordshire
    BritishStorage & Distribution9255070002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WESTEX LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    3 Hanbury Drive
    E11 1GA Leytonstone
    Leytonstone House
    London
    England
    06 avr. 2016
    3 Hanbury Drive
    E11 1GA Leytonstone
    Leytonstone House
    London
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07323518
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    WESTEX LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 22 mai 2019
    Livré le 23 mai 2019
    En cours
    Brève description
    All present and future freehold and leasehold land, all present and future intellectual property and all present and future aircraft as defined in, and pursuant to, clause 5.2 of the accompanying copy instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ultimate Finance Limited
    Transactions
    • 23 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 25 mai 2018
    Livré le 25 mai 2018
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All of the freehold and leasehold property now vested in the company including, but not limited to, the properties short particulars of which is or are set out in schedule 1 of the factoring debenture.. All buildings and fixtures (including trade fixtures, tenant's fixtures and fixed plant and equipment) on all freehold and leasehold property or interest of the company in any of the same mortgaged or charged under the factoring debenture and includes any part of it.. Goodwill (which shall include all brand names), licenses, trademarks and service marks, patents, patent applications, designs, copyrights, confidential information, know-how, computer software and all other intellectual or intangible property or rights now and from time to time belonging to the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Paragon Business Finance PLC
    Transactions
    • 25 mai 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 juin 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 30 nov. 2016
    Livré le 05 déc. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 déc. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 10 oct. 2016
    Livré le 11 oct. 2016
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 11 oct. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 26 févr. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Lease
    Créé le 17 mars 2010
    Livré le 27 mars 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    And all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The deposit account and all monies from to time to time withdrawn from the deposit acount.
    Personnes ayant droit
    • Glasthule Properties LLP
    Transactions
    • 27 mars 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 04 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets guarantee and debenture
    Créé le 23 oct. 2009
    Livré le 30 oct. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all assets.
    Personnes ayant droit
    • Eurofactor (UK) Limited
    Transactions
    • 30 oct. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 13 oct. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 30 mars 2009
    Livré le 01 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under the agreement for the purchase of debts between the company and the chargee and includes any discounting allowances, the benefit of all the other provisions of the contract and all securities (if any) for the contract but only in respect of that credit balance, see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 avr. 2009
    • 04 mars 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge (all assets)
    Créé le 16 févr. 2000
    Livré le 19 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brèves mentions
    (I) all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts including associated rights relating thereto and (ii) all amounts of indebtedness due on any account whatsoever and floating charge over such monies as the company may receive in respect of (ii) above by way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 mai 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 11 févr. 2000
    Livré le 16 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 sept. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 nov. 1985
    Livré le 03 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over: goodwill, bookdebts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WESTEX LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 sept. 2019Administration started
    06 sept. 2021Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Atkinson
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    practitioner
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Glyn Mummery
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    practitioner
    Jupiter House Warley Hill Business Park
    The Drive
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0