TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED

TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01478039
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Yorkshire
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RUTHAM LIMITED08 févr. 198008 févr. 1980

    Quels sont les derniers comptes de TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 oct. 2012

    État du capital au 23 oct. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    État du capital au 01 août 2012

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Reduce share prem a/c 04/07/2012
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Période comptable actuelle prolongée du 31 déc. 2011 au 31 mars 2012

    1 pagesAA01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Nomination de Mr Kazushi Ogura en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Kenji Murai en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ian Fraser en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Healy en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Ian Vincent Ellis en tant que secrétaire

    3 pagesAP03

    Déclaration annuelle jusqu'au 24 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 3 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB le 02 août 2010

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées du secrétaire Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Joseph Anthony Healy le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ian Ellis Fraser le 20 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLIS, Ian Vincent
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    British162130430001
    MURAI, Kenji
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese95702340002
    OGURA, Kazushi
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Water Lane
    LS11 5DY Leeds
    Bridgewater Place
    Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandJapanese150485750001
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Secrétaire
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    British99111340001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Secrétaire
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MORRISON, Scott
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    Secrétaire
    24 Gaveston Road
    CV32 6EU Leamington Spa
    Warwickshire
    British99297890001
    SHANKLAND, Ann Elizabeth
    Woodlands Cottage Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley On Thames
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Woodlands Cottage Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley On Thames
    Oxfordshire
    British16669720004
    BISSETT, Graeme
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    Administrateur
    123 Saint Vincent Street
    G2 5EA Glasgow
    British79800380001
    FARMER, Thomas, Sir
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    Administrateur
    192 Queensferry Road
    EH4 6JL Edinburgh
    Maidencraig House
    Midlothian
    ScotlandBritish94804240004
    FRASER, Ian Ellis
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    ScotlandUk28393850006
    HEALY, Michael Joseph Anthony
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish99111340001
    HOUSTON, John Mclellan
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    Administrateur
    The Rock
    3 Douglas Avenue
    PA14 6PE Langbank
    British712840002
    HUTHERSALL, Robert
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    Administrateur
    56 Pentland Drive
    EH10 6PX Edinburgh
    British3204110005
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    MCGILL, Kenneth Andrew
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    Administrateur
    4 Peastonbank Farm Cottages
    By Pencaitland
    EH34 5ET Tranent
    East Lothian
    British41923940001
    OWENS, Stanley Hart
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    Administrateur
    15b Ewerland
    Barnton
    EH4 6DH Edinburgh
    American75755850002
    PARKER, Timothy Charles
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    Administrateur
    East Main Street
    EH52 5AS Broxburn
    216
    West Lothian
    United KingdomBritish126476060001
    SHANKLAND, Ann Elizabeth
    Woodlands Cottage Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodlands Cottage Woodlands Road
    Shiplake
    RG9 4AA Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish16669720004
    SHANKLAND, Christopher Hugh
    Woodlands Cottage
    Woodlands Road Shiplake
    RG9 4AA Henley-On-Thames
    Oxon
    Administrateur
    Woodlands Cottage
    Woodlands Road Shiplake
    RG9 4AA Henley-On-Thames
    Oxon
    British33899220001

    TOWN AND COUNTRY TYRE SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 13 déc. 1993
    Livré le 16 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All assets of the company including l/h properties plant machinery and vehicles book debts stock in trade and every other asset of the company fixed and current.
    Personnes ayant droit
    • Kwick-Fit Holdings PLC
    Transactions
    • 16 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 oct. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 09 déc. 1992
    Livré le 15 déc. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 15 déc. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0