GEOQUEST HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGEOQUEST HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01478324
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Bishop Fleming
    16 Queen Square
    BS1 4NT Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ECL HOLDINGS LIMITED01 nov. 199501 nov. 1995
    INTERA INFORMATION TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED04 nov. 199104 nov. 1991
    E.C.L. HOLDINGS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    BALLHAND LIMITED11 févr. 198011 févr. 1980

    Quels sont les derniers comptes de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    2 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Victory House Manor Royal Crawley West Sussex RH10 9LU United Kingdom le 06 févr. 2010

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 déc. 2009

    LRESSP

    Cessation de la nomination de Rebecca Martin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Goldby en tant que directeur

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pages287

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages287

    legacy

    6 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2006

    5 pagesAA

    Comptes établis au 31 déc. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    6 pages363a

    legacy

    6 pages363a

    Comptes établis au 31 déc. 2004

    5 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de GEOQUEST HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DROY MOORE, Pauline
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    Secrétaire
    Fernleigh
    Wensley Road Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Essex
    British138236320002
    DROY MOORE, Pauline
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    Administrateur
    Wensley Road
    Thundersley
    SS7 3DS Benfleet
    Fernleigh
    Essex
    England
    EnglandBritish138236320002
    SMOKER, Simon
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    Administrateur
    Maslen Mews
    Beggarwood
    RG22 4QP Basingstoke
    15
    Hampshire
    United KingdomBritish134158640001
    DAVISON, Douglas Stewart
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    Secrétaire
    232 Varsity Green Bay Nw
    T3B 3A8 Calgary
    Alberta
    Canada
    British38662990001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    British32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Secrétaire
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    ZIMMER, Harold Rudy
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Secrétaire
    7515/67th Avenue Nw
    Calgary
    Alberta
    T3 4p2
    Canada
    Canadian44656690001
    BULLOCK, Brian Leonard
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Administrateur
    124 Lake Placid
    Gr S E
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2j 5v8
    Canada
    Canadian25257010001
    GOLDBY, Alan John
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    33 Tyne Crescent
    Brickhill
    MK41 7UJ Bedford
    Bedfordshire
    British7619430001
    HODGKINSON, David Percival, Dr
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    10 Peppard Lane
    RG9 1NH Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish25256980001
    JACKMAN, Christopher Holgate
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    Woodstock Bolney Road
    Shiplake
    RG9 3NT Henley On Thames
    Oxfordshire
    British10419170001
    MARTIN, Rebecca Helen
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    Administrateur
    Mount Ash Road
    SE26 6LY London
    28
    United KingdomNew Zealander134158470001
    RAY, Neil
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    Administrateur
    Grafton
    OX18 2RY Bampton
    Poplar Barn
    Oxfordshire
    EnglandBritish32255250004
    ROKOSH, Joseph Norman
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Cobnar
    Chalkhouse Green Road Kidmore End
    RG4 9AU Reading
    Berkshire
    Canadian34259830001
    SECRETI, Salvatore
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Administrateur
    136 Hawkdile Cl Nw
    T36 3A6 Calgary
    Alberta
    Canada
    Canadian46635930001
    WINAND, Michael Martin
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    9 Hids Copse Road
    OX2 9JJ Oxford
    Oxfordshire
    British10419190001
    WOODWARD, Robert Stephen
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    Administrateur
    229 Varsity Estates Mews Nw
    FOREIGN Calgary Ab T3b 3c9
    Canada
    CanadaBritish30307660001

    GEOQUEST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 07 févr. 1994
    Livré le 21 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor (as defined) to the chargee under the terms of the facility documents (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of Nova Scotia(As Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 21 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 mai 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Créé le 29 oct. 1985
    Livré le 31 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hongkong Bank Limited
    Transactions
    • 31 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 02 mai 1985
    Livré le 22 mai 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 30/11/84
    Brèves mentions
    Assignment by way of charge of all right, title & interest of the company in all the inventions represented by letters patent of the united kingdom etc (for full details see doc M36).
    Personnes ayant droit
    • Wardley London Limited
    Transactions
    • 22 mai 1985Enregistrement d'une charge
    Letter of set-off
    Créé le 19 oct. 1984
    Livré le 02 nov. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee
    Brèves mentions
    Any sums stading to the credit of any account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 nov. 1984Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 mai 1983
    Livré le 11 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital, all buildings fixtures plant & machinery all stocks shares & securities.
    Personnes ayant droit
    • T R Trustees Corporation PLC
    • T R North America Investments Turst PLC
    • Wardley Limited
    Transactions
    • 11 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 09 mai 1983
    Livré le 11 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, all buildings fixtures. All plant & machinery all stocks shares & securities.
    Personnes ayant droit
    • Anthony Gibbs & Sons Limited
    Transactions
    • 11 mai 1983Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 16 août 1982
    Livré le 28 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital, buildings fixtures, fixed plant & machinery, all stocks, shares & other securities.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 28 août 1982Enregistrement d'une charge
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    GEOQUEST HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 déc. 2009Commencement of winding up
    23 mars 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Samuel Jonathan Talby
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath
    practitioner
    Lawrence House Lower Bristol Road
    BA2 9ET Bath

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0