SIDINGS NO. 4 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSIDINGS NO. 4 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01479417
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CETRONIC POWER PRODUCTS LIMITED 24 juin 198524 juin 1985
    CETRONIC COMPONENTS LIMITED15 févr. 198015 févr. 1980

    Quels sont les derniers comptes de SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 sept. 2012

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    État du capital après une attribution d'actions au 04 sept. 2012

    • Capital: GBP 93,261
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Cessation de la nomination de Jonathan Charles Richardson en tant que secrétaire le 31 déc. 2011

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Alan Thomas Fletcher en tant que directeur le 15 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Fisher en tant que directeur le 15 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 déc. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Jonathan Charles Richardson le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Thomas Fletcher le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Ian Fisher le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Andrew Olaf Fischer le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jonathan Charles Richardson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2008

    6 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    6 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de SIDINGS NO. 4 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FISCHER, Andrew Olaf
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomGermanCompany Director70312740036
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    EnglandBritishDirector118293300001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Secrétaire
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    BritishDirector569490001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    British272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Secrétaire
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    CARTER, Beryl Ann
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    British6279700001
    MCDONALD, James
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    Secrétaire
    20 Avenue Road
    Walkford
    BH23 5QH Christchurch
    Dorset
    BritishCompany Director66970160001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    Secrétaire
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    BritishChartered Secretary37378570010
    POTTER, Steve
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    Secrétaire
    12 Avon Road
    West Moors
    BH22 0EG Ferndown
    Dorset
    British93150380001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Secrétaire
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    BritishAccountant118293300001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    Secrétaire
    24 Foxcote Way
    Walton
    S42 7NP Chesterfield
    Derbyshire
    BritishAccountant118293300001
    WEARN, Roger Frederick
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    Secrétaire
    Wyngar
    Stakes Hill Road
    PO7 5UB Waterlooville
    Hampshire
    British104899420001
    AMBROSE SMITH, Brian Aubrey
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    Administrateur
    21 Marlowe Way
    Lexden
    CO3 4JP Colchester
    Essex
    BritishDirector569490001
    BRANSON, David Anthony
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    32 Chestnut Drive
    Shenstone
    WS14 0JH Lichfield
    Staffordshire
    BritishCompany Director/Secretary272310001
    BUSHNELL, Adrian John
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    138 Goddard Way
    CB10 2ED Saffron Walden
    Essex
    BritishChartered Secretary43046230002
    CARTER, David Patrick
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    Administrateur
    Knoll Farm Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    BritishElectrical Engineer6279710001
    CURRY, John James
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    Administrateur
    Brett House 2 Mortlocks
    Lavenham
    CO10 9QF Sudbury
    Suffolk
    BritishDirector49740520005
    FISHER, Ian
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    Administrateur
    Rubicon Partners, 2b, Sidings
    Court, Doncaster
    DN4 5NU South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director14669590002
    HIGGINSON, Andrew John
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    Administrateur
    Hawthorn House Long Road West Dedham
    CO7 6ES Colchester
    Essex
    BritishChartered Accountant74501390001
    MONK, Brian
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Wichita Shoppenhangers Road
    SL6 2QE Maidenhead
    Berkshire
    BritishDirector19699310001
    PARKER, Edward Geoffrey
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    Administrateur
    The Maltings 3 Back Lane
    Ramsbury
    SN8 2QH Marlborough
    Wiltshire
    BritishChartered Secretary37378570010
    SMITH, Stephen Anthony
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    Administrateur
    The Tudor House
    Week St Mary
    EX22 6UL Holsworthy
    United KingdomBritishDirector6780200002
    WEBSTER, Stephen Paul
    Rose Cottage
    Haye Lane
    WR9 0EJ Omberseley
    Worcestershire
    Administrateur
    Rose Cottage
    Haye Lane
    WR9 0EJ Omberseley
    Worcestershire
    BritishCompany Director40201730002

    SIDINGS NO. 4 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed equitable charge
    Créé le 01 juil. 1994
    Livré le 08 juil. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed equitable charge over all book debtsm invoice debts, accounts , notes, bills, acceptances and/or other forms of obligation,("receivables") ,the subject of a factoring agreement between the company and the security holder-as defined, and remain vested in the company. Please see doc for further details.
    Personnes ayant droit
    • Grifin Factors Limited
    Transactions
    • 08 juil. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 01 juin 1993
    Livré le 04 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 11 nov. 1986
    Livré le 02 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 02 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    • 13 oct. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    SIDINGS NO. 4 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    16 juil. 2013Dissolved on
    20 sept. 2012Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0