LIQUICO AOL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIQUICO AOL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01485148
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIQUICO AOL LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe LIQUICO AOL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    K House Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIQUICO AOL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ALPHA OFFICE LIMITED11 déc. 199611 déc. 1996
    ALPHA STATIONERS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    QUISMALL LIMITED13 mars 198013 mars 1980

    Quels sont les derniers comptes de LIQUICO AOL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour LIQUICO AOL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    14 pagesLIQ13

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 déc. 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name02 déc. 2016

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 25 nov. 2016

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    6 pagesAA

    Satisfaction de la charge 014851480020 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 014851480021 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 014851480022 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 014851480019 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 014851480017 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 014851480018 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Robert Rolph Baldrey en tant que directeur le 13 avr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephen Haworth en tant qu'administrateur le 13 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 févr. 2016

    État du capital au 02 févr. 2016

    • Capital: GBP 5,000
    SH01

    legacy

    50 pagesPARENT_ACC

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE1

    Résolutions

    Resolutions
    20 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Qui sont les dirigeants de LIQUICO AOL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MENDELSOHN, Lorna
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    Secrétaire
    Sheffield Airport Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    England
    194377240001
    GALE, Andrew Peter
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director155681500001
    HAWORTH, Stephen
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Ceo155690570001
    ALLINSON, Raymond Leonard
    Home Platt
    Sharpthorne
    RH19 4NZ East Grinstead
    19
    West Sussex
    Secrétaire
    Home Platt
    Sharpthorne
    RH19 4NZ East Grinstead
    19
    West Sussex
    British49026830001
    CRUMP, Malika
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Secrétaire
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    French28540340001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    St Georges
    Hospital Road
    Wicklewood
    16
    Norfolk
    England
    Secrétaire
    St Georges
    Hospital Road
    Wicklewood
    16
    Norfolk
    England
    BritishCompany Director130923460001
    LINDSAY, Martin David
    10 The Meads
    RH19 4DF East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    10 The Meads
    RH19 4DF East Grinstead
    West Sussex
    British61946250001
    RODWELL, Debra Jane Clare
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    BritishCompany Secretary125214030001
    ROSSITER, Barry Michael
    5 Pine Way Close
    RH19 4JR East Grinstead
    West Sussex
    Secrétaire
    5 Pine Way Close
    RH19 4JR East Grinstead
    West Sussex
    British10219510001
    SMITHSON, Robert Erald
    14 Lister Avenue
    SG4 9ES Hitchin
    Hertfordshire
    Secrétaire
    14 Lister Avenue
    SG4 9ES Hitchin
    Hertfordshire
    British8854990001
    ALLINSON, Raymond Leonard
    Home Platt
    Sharpthorne
    RH19 4NZ East Grinstead
    19
    West Sussex
    Administrateur
    Home Platt
    Sharpthorne
    RH19 4NZ East Grinstead
    19
    West Sussex
    EnglandBritishSales Executive49026830001
    BALDREY, Robert Rolph
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    Administrateur
    Sheffield Business Park
    Europa Link
    S9 1XU Sheffield
    K House
    United Kingdom
    EnglandBritishCeo78328360005
    CALLEAR, David James
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    Administrateur
    Barningham Hall
    Barningham
    IP31 1DH Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritishChairman41483090001
    CRUMP, Allan Francis
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    BritishContract Stationer10219520001
    CRUMP, Malika
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    Administrateur
    Rustlings Sandhill Lane
    Crawley Down
    RH10 4LB Crawley
    West Sussex
    FrenchCompany Director28540340001
    CUNNINGHAM, Mark Andrew
    St Georges
    Hospital Road
    Wicklewood
    16
    Norfolk
    England
    Administrateur
    St Georges
    Hospital Road
    Wicklewood
    16
    Norfolk
    England
    EnglandBritishCompany Director130923460001
    GODDARD, Mark John
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishFinance Director126182490001
    LINDSAY, Martin David
    10 The Meads
    RH19 4DF East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    10 The Meads
    RH19 4DF East Grinstead
    West Sussex
    BritishAccountant61946250001
    MARSHALL, Geoffrey Ian
    Silvertones New Domewood
    RH10 3HF Copthorne
    West Sussex
    Administrateur
    Silvertones New Domewood
    RH10 3HF Copthorne
    West Sussex
    British32089110002
    MOATE, Simon Richard
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    St Crispins
    Duke Street
    NR3 1PD Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive Officer126182400002
    PECK, Raymond Charles
    Springfield
    Pamber Road, Charter Alley
    RG26 5PZ Basingstoke
    Administrateur
    Springfield
    Pamber Road, Charter Alley
    RG26 5PZ Basingstoke
    BritishCompany Director73966840001
    ROSSITER, Barry Michael
    5 Pine Way Close
    RH19 4JR East Grinstead
    West Sussex
    Administrateur
    5 Pine Way Close
    RH19 4JR East Grinstead
    West Sussex
    BritishAccountant10219510001
    STANTON, Martin
    Chaungside
    Innhams Wood
    TN6 1TE Crowborough
    East Sussex
    Administrateur
    Chaungside
    Innhams Wood
    TN6 1TE Crowborough
    East Sussex
    United KingdomBritishManagement Consultant68246310001

    LIQUICO AOL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 mai 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    L/H property k/a 16A crawfordsburn road newtownards county down.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ares Capital Europe Limited in Its Capacity as Security Agent
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 28 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP in Its Cpapacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 30 avr. 2015
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 30 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 29 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    The property known as 8 trench road, hydepark, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN28700L county antrim and held under indenture of lease dated the 15TH day of march 1991 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate adjacent to 8 trench road, hydepark industrial estate, mallusk, newtownabbey, comprised in folio no AN30433L county antrim and held under indenture of lease dated the 26TH day of august 1993 and made between chessbourne international limited (1) john heath & co limited (2).. the leasehold property situate at 16A crawfordsburn road, newtownards, county down comprised in and demised by indenture of lease dated the 12TH day of august 1994 and made between northern engineering enterprises limited (1) secretary of state for the environment (2) for the term of twenty-five (25) years from the 20TH day of june 1994 subject as therein (as registered in the registry of deeds on the 6TH day of september 1994, serial number 1994-120-033).
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 29 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 avr. 2015
    Livré le 28 avr. 2015
    En cours
    Brève description
    The freehold land known as "software stationery specialists", wheatfield way, hinckley, LE10 1YG. Title number LT244150.. The leasehold land known as lexicon house, midleton road, guildford, GU2 8XP. Title number SY820787.. The leasehold land known as dorcan 300, murdoch road, dorcan, swindon SN3 5HY. Title number WT307925.. For more details please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Pnc Business Credit a Trading Style of Pnc Financial Services UK LTD for Itself and in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 28 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 oct. 2014
    Livré le 29 oct. 2014
    En cours
    Brève description
    Leasehold land known as unit 16 birches industrial estate east grinstead t/n WSX284098.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Endless LLP
    Transactions
    • 29 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    Rent security deposit deed
    Créé le 06 août 2008
    Livré le 08 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the tenants interest in the deposit meaining the sum of £51,808.05 together with any interest credited to the deposit account. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bnp Paribas Securities Services Custody Bank Limited and Bnp Paribas Securities Services Trust Company Limited Together as Trustees of the Blackrock UK Property Fund
    Transactions
    • 08 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 août 2008
    • 28 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 29 avr. 2008
    Livré le 03 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transactions
    • 03 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mai 2006
    Livré le 19 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All assets by way of fixed and floating charge.
    Personnes ayant droit
    • Eurifactor (UK) Limited
    Transactions
    • 19 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent security deposit deed
    Créé le 09 févr. 2000
    Livré le 21 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the deed and the lease of even date defined therein between the company (as tenant) and the chargee (as landlord) relating to unit 24A the birches industrial estate east grinstead
    Brèves mentions
    All the company's right title benefit and interest in and to the deposit account defined in the deed in which the deposit of £42,500 is placed and any addition thereto under the terms of the deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Raglan Securities Limited
    Transactions
    • 21 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 22 oct. 1999
    Livré le 03 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 03 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 24 mai 1995
    Livré le 26 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All bookdebts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement between the company and the security holder. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 26 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 24 mai 1995
    Livré le 26 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the undertaking and all assets whatsoever and wheresoever owned or herefter acquired by the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 26 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 07 janv. 1994
    Livré le 19 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 04 nov. 1982
    Livré le 10 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    • 11 juil. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LIQUICO AOL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 déc. 2016Commencement of winding up
    25 avr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Roland Browne
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    practitioner
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    practitioner
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0