PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED

PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01486914
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    • Activités des agences de travail temporaire (78200) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    41 Great Pulteney Street
    1st Floor
    W1F 9NZ London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020

    3 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019

    10 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 36 Grosvenor Gardens Grosvenor Gardens London SW1W 0EB à 41 Great Pulteney Street 1st Floor London W1F 9NZ le 02 mars 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Cessation de la nomination de Mark Prior en tant que secrétaire le 31 janv. 2016

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Jonathan Stanley Rivlin en tant que secrétaire le 25 sept. 2017

    2 pagesAP03

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    4 pagesAA

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015

    21 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2016 au 31 déc. 2015

    1 pagesAA01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Qui sont les dirigeants de PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RIVLIN, Jonathan Stanley
    Great Pulteney Street
    1st Floor
    W1F 9NZ London
    41
    England
    Secrétaire
    Great Pulteney Street
    1st Floor
    W1F 9NZ London
    41
    England
    238273650001
    ALGUACIL, Michiele
    Residence Du Vertgalant
    13 Rue Pierre Bessolette
    93290 Tremblay En France
    Paris
    France
    Administrateur
    Residence Du Vertgalant
    13 Rue Pierre Bessolette
    93290 Tremblay En France
    Paris
    France
    FranceFrenchCompany Director43772000001
    LYLE, Robert
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36
    United Kingdom
    Administrateur
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36
    United Kingdom
    United Arab EmiratesBritishDirector119523990001
    BERKELEY, Elizabeth Mary
    Tregarthen House
    6 Manor Road
    HP20 1JD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    Tregarthen House
    6 Manor Road
    HP20 1JD Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director180463590004
    CUDLIPP, Nigel Hugh
    62 Dartnell Park Road
    West Byfleet
    KT14 6PX Surrey
    Secrétaire
    62 Dartnell Park Road
    West Byfleet
    KT14 6PX Surrey
    BritishChartered Accountant45305480001
    HAMILTON, Andrew Robert
    26 College Gardens
    Beechcroft Road Tooting
    SW17 7UG London
    Secrétaire
    26 College Gardens
    Beechcroft Road Tooting
    SW17 7UG London
    British60352790001
    PRIOR, Mark
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36
    United Kingdom
    Secrétaire
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36
    United Kingdom
    190681540001
    SCHNEIDER, Elizabeth Ruth Anne
    20 Frognal Way
    SW3 6XE London
    Secrétaire
    20 Frognal Way
    SW3 6XE London
    British32357920001
    STYLES, Ann
    30 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    Secrétaire
    30 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    British43246280001
    BARRINGTON, Douglas John
    East House
    WR12 7AJ Broadway
    Worcestershire
    Administrateur
    East House
    WR12 7AJ Broadway
    Worcestershire
    BritishDirector899760001
    BERKELEY, Elizabeth Mary
    Tregarthen House
    6 Manor Road
    HP20 1JD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Tregarthen House
    6 Manor Road
    HP20 1JD Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director180463590004
    CUDLIPP, Nigel Hugh
    62 Dartnell Park Road
    West Byfleet
    KT14 6PX Surrey
    Administrateur
    62 Dartnell Park Road
    West Byfleet
    KT14 6PX Surrey
    BritishChartered Accountant45305480001
    GOSTELOW, Mary
    1 Clyffe House East
    Tincleton
    DT2 8QP Dorchester
    Dorset
    Administrateur
    1 Clyffe House East
    Tincleton
    DT2 8QP Dorchester
    Dorset
    BritishWriter17482350001
    HAMILTON, Andrew Robert
    26 College Gardens
    Beechcroft Road Tooting
    SW17 7UG London
    Administrateur
    26 College Gardens
    Beechcroft Road Tooting
    SW17 7UG London
    BritishAccountant60352790001
    HEY, James John
    19 Hillrise
    KT10 0AL Hinchley Wood
    Surrey
    Administrateur
    19 Hillrise
    KT10 0AL Hinchley Wood
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director92632090002
    LEO-ANDRIEU, Grace
    18 Rue Murillo
    Paris 75008
    FOREIGN France
    Administrateur
    18 Rue Murillo
    Paris 75008
    FOREIGN France
    AmericanHotel Consultant32357900002
    NORRIS, Mark Thomas
    Hardings Upper Farringdon
    Alton
    GU34 3EQ Hampshire
    Administrateur
    Hardings Upper Farringdon
    Alton
    GU34 3EQ Hampshire
    UaeBritishCompany Director92216500001
    NORRIS, Mark Thomas
    Hardings Upper Farringdon
    Alton
    GU34 3EQ Hampshire
    Administrateur
    Hardings Upper Farringdon
    Alton
    GU34 3EQ Hampshire
    UaeBritishConsultant92216500001
    SCHNEIDER, Elizabeth Ruth Anne
    20 Frognal Way
    SW3 6XE London
    Administrateur
    20 Frognal Way
    SW3 6XE London
    BritishDirector32357920001
    SCHNEIDER, Jacques
    20 Frognal Way
    NW3 6XE London
    Administrateur
    20 Frognal Way
    NW3 6XE London
    BelgianConsultant25051590002
    SELLERS, Rupert Frederic Paul
    Willow House
    Ellington Gardens
    SL6 0AY Taplow
    Berkshire
    Administrateur
    Willow House
    Ellington Gardens
    SL6 0AY Taplow
    Berkshire
    United KingdomBritishRecruitment92216510001
    STYLES, Ann
    30 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    Administrateur
    30 Chancellors Wharf
    Crisp Road
    W6 9RT London
    United KingdomBritishConsultant43246280001
    THURSO, John Archibald, The Right Honourable Viscount
    Orchard Cottage Champneys
    Wigginton
    HP23 6HY Tring
    Hertfordshire
    Administrateur
    Orchard Cottage Champneys
    Wigginton
    HP23 6HY Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director47549670002
    WALKER, Simon Arthur
    64 Cranbury Road
    SW6 2NJ London
    Administrateur
    64 Cranbury Road
    SW6 2NJ London
    BritishConsultant25051600001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Prco Limited
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36 Grosvenor Gardens
    England
    06 avr. 2016
    Grosvenor Gardens
    SW1W 0EB London
    36 Grosvenor Gardens
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Autorité légaleEngland And Wales
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 16 mai 2013
    Livré le 24 mai 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Santander UK PLC (As Security Trustee)
    Transactions
    • 24 mai 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 09 août 2011
    Livré le 12 août 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Norman Edward Bellone
    Transactions
    • 12 août 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage of a ship
    Créé le 13 juil. 2011
    Livré le 16 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The vessel "profile" registered at the registry of shipping and seamen with official number 912925.
    Personnes ayant droit
    • Sgb Finance
    Transactions
    • 16 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of assignment of earnings and insurance
    Créé le 28 juin 2011
    Livré le 16 juil. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the company's rights and interest in the earnibgs and the insurances of the beneteau first 40.7 with hull identification number fr-BEY82697L607.
    Personnes ayant droit
    • Sgb Finance
    Transactions
    • 16 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Mortgage of a ship
    Créé le 04 juil. 2007
    Livré le 18 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    64 shares in the vessel name (profile 912925) and in her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 18 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of mortgage
    Créé le 12 janv. 2007
    Livré le 16 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Sixty four shares in the vessel and in her boats and appurtenances being fr-BEY826976607 beneteau first 40.7.
    Personnes ayant droit
    • Capital Bank PLC
    Transactions
    • 16 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 22 avr. 1992
    Livré le 24 avr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 mai 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 août 1989
    Livré le 08 août 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 août 1989Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 juil. 1986
    Livré le 05 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    2 perrins lane hampstead london NW3 title no 302582 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage
    Créé le 30 mai 1984
    Livré le 16 juin 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    1 heath street hampstead, london NW3 title no ngl 480778 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 1984Enregistrement d'une charge
    • 25 avr. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 11 févr. 1982
    Livré le 25 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    45 agincourt road london NW3 title no:- ln 94400. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 25 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 27 févr. 1981
    Livré le 13 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    139 prince of wales road, camden, london nw 5. title no:- ln 80716. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 mars 1981Enregistrement d'une charge
    • 23 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0