PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01486914 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?
Adresse du siège social | 41 Great Pulteney Street 1st Floor W1F 9NZ London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes de micro-entité établis au 31 déc. 2020 | 3 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019 | 10 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Changement d'adresse du siège social de 36 Grosvenor Gardens Grosvenor Gardens London SW1W 0EB à 41 Great Pulteney Street 1st Floor London W1F 9NZ le 02 mars 2020 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes non audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018 | 12 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 18 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 18 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Mark Prior en tant que secrétaire le 31 janv. 2016 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Mr Jonathan Stanley Rivlin en tant que secrétaire le 25 sept. 2017 | 2 pages | AP03 | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||
Déclaration de confirmation établie le 30 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015 | 4 pages | AA | ||
La procédure de radiation d'office a été suspendue | 1 pages | DISS16(SOAS) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015 | 21 pages | AA | ||
Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2016 au 31 déc. 2015 | 1 pages | AA01 | ||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 |
Qui sont les dirigeants de PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVLIN, Jonathan Stanley | Secrétaire | Great Pulteney Street 1st Floor W1F 9NZ London 41 England | 238273650001 | |||||||
ALGUACIL, Michiele | Administrateur | Residence Du Vertgalant 13 Rue Pierre Bessolette 93290 Tremblay En France Paris France | France | French | Company Director | 43772000001 | ||||
LYLE, Robert | Administrateur | Grosvenor Gardens SW1W 0EB London 36 United Kingdom | United Arab Emirates | British | Director | 119523990001 | ||||
BERKELEY, Elizabeth Mary | Secrétaire | Tregarthen House 6 Manor Road HP20 1JD Aylesbury Buckinghamshire | British | Company Director | 180463590004 | |||||
CUDLIPP, Nigel Hugh | Secrétaire | 62 Dartnell Park Road West Byfleet KT14 6PX Surrey | British | Chartered Accountant | 45305480001 | |||||
HAMILTON, Andrew Robert | Secrétaire | 26 College Gardens Beechcroft Road Tooting SW17 7UG London | British | 60352790001 | ||||||
PRIOR, Mark | Secrétaire | Grosvenor Gardens SW1W 0EB London 36 United Kingdom | 190681540001 | |||||||
SCHNEIDER, Elizabeth Ruth Anne | Secrétaire | 20 Frognal Way SW3 6XE London | British | 32357920001 | ||||||
STYLES, Ann | Secrétaire | 30 Chancellors Wharf Crisp Road W6 9RT London | British | 43246280001 | ||||||
BARRINGTON, Douglas John | Administrateur | East House WR12 7AJ Broadway Worcestershire | British | Director | 899760001 | |||||
BERKELEY, Elizabeth Mary | Administrateur | Tregarthen House 6 Manor Road HP20 1JD Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Company Director | 180463590004 | ||||
CUDLIPP, Nigel Hugh | Administrateur | 62 Dartnell Park Road West Byfleet KT14 6PX Surrey | British | Chartered Accountant | 45305480001 | |||||
GOSTELOW, Mary | Administrateur | 1 Clyffe House East Tincleton DT2 8QP Dorchester Dorset | British | Writer | 17482350001 | |||||
HAMILTON, Andrew Robert | Administrateur | 26 College Gardens Beechcroft Road Tooting SW17 7UG London | British | Accountant | 60352790001 | |||||
HEY, James John | Administrateur | 19 Hillrise KT10 0AL Hinchley Wood Surrey | United Kingdom | British | Company Director | 92632090002 | ||||
LEO-ANDRIEU, Grace | Administrateur | 18 Rue Murillo Paris 75008 FOREIGN France | American | Hotel Consultant | 32357900002 | |||||
NORRIS, Mark Thomas | Administrateur | Hardings Upper Farringdon Alton GU34 3EQ Hampshire | Uae | British | Company Director | 92216500001 | ||||
NORRIS, Mark Thomas | Administrateur | Hardings Upper Farringdon Alton GU34 3EQ Hampshire | Uae | British | Consultant | 92216500001 | ||||
SCHNEIDER, Elizabeth Ruth Anne | Administrateur | 20 Frognal Way SW3 6XE London | British | Director | 32357920001 | |||||
SCHNEIDER, Jacques | Administrateur | 20 Frognal Way NW3 6XE London | Belgian | Consultant | 25051590002 | |||||
SELLERS, Rupert Frederic Paul | Administrateur | Willow House Ellington Gardens SL6 0AY Taplow Berkshire | United Kingdom | British | Recruitment | 92216510001 | ||||
STYLES, Ann | Administrateur | 30 Chancellors Wharf Crisp Road W6 9RT London | United Kingdom | British | Consultant | 43246280001 | ||||
THURSO, John Archibald, The Right Honourable Viscount | Administrateur | Orchard Cottage Champneys Wigginton HP23 6HY Tring Hertfordshire | British | Company Director | 47549670002 | |||||
WALKER, Simon Arthur | Administrateur | 64 Cranbury Road SW6 2NJ London | British | Consultant | 25051600001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prco Limited | 06 avr. 2016 | Grosvenor Gardens SW1W 0EB London 36 Grosvenor Gardens England | Non | ||||
| |||||||
Nature du contrôle
|
PROFILE MANAGEMENT AND SPECIALIST RECRUITMENT LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 16 mai 2013 Livré le 24 mai 2013 | En cours | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 09 août 2011 Livré le 12 août 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage of a ship | Créé le 13 juil. 2011 Livré le 16 juil. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The vessel "profile" registered at the registry of shipping and seamen with official number 912925. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment of earnings and insurance | Créé le 28 juin 2011 Livré le 16 juil. 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All the company's rights and interest in the earnibgs and the insurances of the beneteau first 40.7 with hull identification number fr-BEY82697L607. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage of a ship | Créé le 04 juil. 2007 Livré le 18 juil. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 64 shares in the vessel name (profile 912925) and in her boats and appurtenances. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of mortgage | Créé le 12 janv. 2007 Livré le 16 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Sixty four shares in the vessel and in her boats and appurtenances being fr-BEY826976607 beneteau first 40.7. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 22 avr. 1992 Livré le 24 avr. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 août 1989 Livré le 08 août 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 31 juil. 1986 Livré le 05 août 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 2 perrins lane hampstead london NW3 title no 302582 and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage | Créé le 30 mai 1984 Livré le 16 juin 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 1 heath street hampstead, london NW3 title no ngl 480778 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 11 févr. 1982 Livré le 25 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 45 agincourt road london NW3 title no:- ln 94400. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 27 févr. 1981 Livré le 13 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 139 prince of wales road, camden, london nw 5. title no:- ln 80716. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0