DATATRADE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | DATATRADE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01491136 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe DATATRADE LIMITED ?
Adresse du siège social | Whitwood Lodge Whitwood Lane Whitwood WF10 5QD Wakefield West Yorkshire England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de DATATRADE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour DATATRADE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||
Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019 | 8 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018 | 9 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des détails de Datatrade Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de Lancaster House 70-76 Blackburn Street Radcliffe Manchester M26 2JW England à Whitwood Lodge Whitwood Lane Whitwood Wakefield West Yorkshire WF10 5QD le 23 mars 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Changement d'adresse du siège social de Cornwell Business Park Salthouse Road Brackmills Northampton Northants NN4 7EX à Lancaster House 70-76 Blackburn Street Radcliffe Manchester M26 2JW le 19 mars 2018 | 1 pages | AD01 | ||
Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2018 au 31 déc. 2018 | 1 pages | AA01 | ||
Notification de Datatrade Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 juin 2016 | 2 pages | PSC02 | ||
Cessation de Susan Elizabeth James en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||
Cessation de Mark Compton James en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Mr Richard Gilliard en tant qu'administrateur le 30 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Lance Anthony Bennett en tant qu'administrateur le 30 nov. 2017 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Kevin Thomas Mansworth en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Susan Elizabeth James en tant que secrétaire le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM02 | ||
Cessation de la nomination de Clive John Lacey en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Peter George Laplanche en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Susan Elizabeth James en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Mark Compton James en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Justin Stuart Clubb en tant que directeur le 30 nov. 2017 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2017 | 11 pages | AA | ||
Qui sont les dirigeants de DATATRADE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNETT, Lance Anthony | Administrateur | Whitwood Lane Whitwood WF10 5QD Wakefield Whitwood Lodge West Yorkshire England | United Kingdom | British | Company Director | 56077450002 | ||||
GILLIARD, Richard James | Administrateur | Whitwood Lane Whitwood WF10 5QD Wakefield Whitwood Lodge West Yorkshire England | England | British | Company Director | 64886600004 | ||||
GREGG, Mary Teresa | Secrétaire | 8 Muscott Lane Duston NN5 6HR Northampton Northamptonshire | British | 55338210001 | ||||||
JAMES, Julie | Secrétaire | Wendover House NN7 3EY Gayton Northamptonshire | British | 101550130001 | ||||||
JAMES, Julie Suzanne | Secrétaire | Wendower House Gayton NW7 3HU Northampton Northants | British | 31400860001 | ||||||
JAMES, Susan Elizabeth | Secrétaire | Ivy Bank Mill Lane Grimscote NN12 6LJ Towcester Northamptonshire | British | Company Secretary | 103764740001 | |||||
LAKE, Andrew Stephen | Secrétaire | 32 Connaught Way MK41 7LB Bedford Bedfordshire | British | 15183270001 | ||||||
MCGIBBON, Lewis | Secrétaire | Green Close Golf Lane Church Brampton NN16 8AY Northampton Northamptonshire | British | 10780150001 | ||||||
ADAMS, Neil Edward | Administrateur | 62 Crofters Close East Hunsbury NN4 0BJ Northampton Northamptonshire | British | Director | 116166650001 | |||||
CASTLE, Brian Harvey | Administrateur | 29 Ibstock Close Billing Lane NN3 5DL Northampton Northamptonshire | British | Director | 11830080001 | |||||
CLUBB, Justin Stuart | Administrateur | Salthouse Road Brackmills NN4 7EX Northampton Cornwell Business Park Northants | England | British | Financial Director | 152324770002 | ||||
HICKMOTT, Paul Leslie | Administrateur | Mushroom Cottage 10a Brafield Road NN7 1ND Cogenhoe Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 205801090001 | ||||
JAMES, John Peter Compton | Administrateur | Wendover House Gayton NN7 3HL Northampton Northants | British | Director | 1847790001 | |||||
JAMES, Mark Compton | Administrateur | Ivy Bank Mill Lane, Grimscote NN12 8LJ Towcester Northamptonshire | England | British | Computer Engineer | 63978130001 | ||||
JAMES, Susan Elizabeth | Administrateur | Mill Lane Grimscote NN12 6LJ Towcester Ivy Bank Northamptonshire | United Kingdom | British | Director | 152324430001 | ||||
LACEY, Clive John | Administrateur | Lyndhurst Kettering Road Walgrave NN6 9PH Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | Consultant | 60910250001 | ||||
LAKE, Andrew Stephen | Administrateur | 32 Connaught Way MK41 7LB Bedford Bedfordshire | England | British | Accountant | 15183270001 | ||||
LAPLANCHE, Peter George | Administrateur | Waterhouse Lane Gedling NG4 4BP Nottingham 37a England | United Kingdom | British | Sales Director | 110994210002 | ||||
MANSWORTH, Kevin Thomas | Administrateur | Banks Cottage The Banks NG13 8BT Bingham 44 Nottinghamshire | England | British | Director | 25275050007 | ||||
MCGIBBON, Lewis | Administrateur | Green Close Golf Lane Church Brampton NN16 8AY Northampton Northamptonshire | British | Director | 10780150001 | |||||
RIVETT, Barry Mark | Administrateur | 12 Chantry Close Woburn Sands MK17 8UB Milton Keynes Buckinghamshire | United Kingdom | United Kingdom | Computor Engineer | 101801500001 | ||||
TOMLIN, Ian Christian | Administrateur | 10 Gloucester Close Weedon NN7 4PA Northampton Northamptonshire | British | Sales Director | 55156370001 | |||||
WEIR, Colin Robert Selkirk | Administrateur | John Ratot No 6 Monte Ayboto Alfas Del P1 Alicante 03580 Spain | British | Director | 73972970002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DATATRADE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datatrade Holdings Limited | 15 juin 2016 | Whitwood Lane Whitwood WF10 5QD Wakefield Whitwood Lodge West Yorkshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Mark Compton James | 06 avr. 2016 | Salthouse Road Brackmills NN4 7EX Northampton Cornwell Business Park Northants | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mrs Susan Elizabeth James | 06 avr. 2016 | Salthouse Road Brackmills NN4 7EX Northampton Cornwell Business Park Northants | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
|
DATATRADE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 11 févr. 1993 Livré le 27 févr. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti For securing £59,750.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions All the undertaking and property wheresoever and whatsoever including the uncalled capital of datatrade limited. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 20 oct. 1988 Livré le 31 oct. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H units 1 and 2 sterling business park salthouse road brachmills northampton and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 21 sept. 1988 Livré le 27 sept. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 07 juil. 1981 Livré le 15 juil. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, prepayments and cash, with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0