DATATRADE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDATATRADE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01491136
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DATATRADE LIMITED ?

    • Autres activités de services informatiques (62090) / Information et communication

    Où se situe DATATRADE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Whitwood Lodge Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    West Yorkshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DATATRADE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DATATRADE PLC31 déc. 198131 déc. 1981
    DATASET LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    VIVUS PRODUCTS LIMITED16 avr. 198016 avr. 1980

    Quels sont les derniers comptes de DATATRADE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour DATATRADE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01
    X9WO1PJN

    Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2019

    8 pagesAA
    A9EN9DJV

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X97UPZF4

    Comptes audités abrégés arrêtés au 31 déc. 2018

    9 pagesAA
    A8EBOM09

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X87VTVIZ

    Déclaration de confirmation établie le 15 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01
    X78CMJI3

    Modification des détails de Datatrade Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017

    2 pagesPSC05
    X780KROA

    Changement d'adresse du siège social de Lancaster House 70-76 Blackburn Street Radcliffe Manchester M26 2JW England à Whitwood Lodge Whitwood Lane Whitwood Wakefield West Yorkshire WF10 5QD le 23 mars 2018

    1 pagesAD01
    X728KPIJ

    Changement d'adresse du siège social de Cornwell Business Park Salthouse Road Brackmills Northampton Northants NN4 7EX à Lancaster House 70-76 Blackburn Street Radcliffe Manchester M26 2JW le 19 mars 2018

    1 pagesAD01
    X71VLFOP

    Période comptable actuelle prolongée du 30 sept. 2018 au 31 déc. 2018

    1 pagesAA01
    X71VLY7C

    Notification de Datatrade Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 15 juin 2016

    2 pagesPSC02
    X6YSGPDL

    Cessation de Susan Elizabeth James en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017

    1 pagesPSC07
    X6KNIPM7

    Cessation de Mark Compton James en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 30 nov. 2017

    1 pagesPSC07
    X6KNIKSQ

    Nomination de Mr Richard Gilliard en tant qu'administrateur le 30 nov. 2017

    2 pagesAP01
    X6KNIFZE

    Nomination de Mr Lance Anthony Bennett en tant qu'administrateur le 30 nov. 2017

    2 pagesAP01
    X6KNHNNE

    Cessation de la nomination de Kevin Thomas Mansworth en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNHEG8

    Cessation de la nomination de Susan Elizabeth James en tant que secrétaire le 30 nov. 2017

    1 pagesTM02
    X6KNHFI1

    Cessation de la nomination de Clive John Lacey en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNHBM3

    Cessation de la nomination de Peter George Laplanche en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNH85L

    Cessation de la nomination de Susan Elizabeth James en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNHAXN

    Cessation de la nomination de Mark Compton James en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNH6SO

    Cessation de la nomination de Justin Stuart Clubb en tant que directeur le 30 nov. 2017

    1 pagesTM01
    X6KNH5MM

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2017

    11 pagesAA
    X6K81SVT

    Qui sont les dirigeants de DATATRADE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BENNETT, Lance Anthony
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director56077450002
    GILLIARD, Richard James
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director64886600004
    GREGG, Mary Teresa
    8 Muscott Lane
    Duston
    NN5 6HR Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    8 Muscott Lane
    Duston
    NN5 6HR Northampton
    Northamptonshire
    British55338210001
    JAMES, Julie
    Wendover House
    NN7 3EY Gayton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Wendover House
    NN7 3EY Gayton
    Northamptonshire
    British101550130001
    JAMES, Julie Suzanne
    Wendower House
    Gayton
    NW7 3HU Northampton
    Northants
    Secrétaire
    Wendower House
    Gayton
    NW7 3HU Northampton
    Northants
    British31400860001
    JAMES, Susan Elizabeth
    Ivy Bank
    Mill Lane Grimscote
    NN12 6LJ Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Ivy Bank
    Mill Lane Grimscote
    NN12 6LJ Towcester
    Northamptonshire
    BritishCompany Secretary103764740001
    LAKE, Andrew Stephen
    32 Connaught Way
    MK41 7LB Bedford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    32 Connaught Way
    MK41 7LB Bedford
    Bedfordshire
    British15183270001
    MCGIBBON, Lewis
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    British10780150001
    ADAMS, Neil Edward
    62 Crofters Close
    East Hunsbury
    NN4 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    62 Crofters Close
    East Hunsbury
    NN4 0BJ Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector116166650001
    CASTLE, Brian Harvey
    29 Ibstock Close
    Billing Lane
    NN3 5DL Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    29 Ibstock Close
    Billing Lane
    NN3 5DL Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector11830080001
    CLUBB, Justin Stuart
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    Administrateur
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    EnglandBritishFinancial Director152324770002
    HICKMOTT, Paul Leslie
    Mushroom Cottage
    10a Brafield Road
    NN7 1ND Cogenhoe
    Northamptonshire
    Administrateur
    Mushroom Cottage
    10a Brafield Road
    NN7 1ND Cogenhoe
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector205801090001
    JAMES, John Peter Compton
    Wendover House Gayton
    NN7 3HL Northampton
    Northants
    Administrateur
    Wendover House Gayton
    NN7 3HL Northampton
    Northants
    BritishDirector1847790001
    JAMES, Mark Compton
    Ivy Bank
    Mill Lane, Grimscote
    NN12 8LJ Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    Ivy Bank
    Mill Lane, Grimscote
    NN12 8LJ Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritishComputer Engineer63978130001
    JAMES, Susan Elizabeth
    Mill Lane
    Grimscote
    NN12 6LJ Towcester
    Ivy Bank
    Northamptonshire
    Administrateur
    Mill Lane
    Grimscote
    NN12 6LJ Towcester
    Ivy Bank
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector152324430001
    LACEY, Clive John
    Lyndhurst Kettering Road
    Walgrave
    NN6 9PH Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Lyndhurst Kettering Road
    Walgrave
    NN6 9PH Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritishConsultant60910250001
    LAKE, Andrew Stephen
    32 Connaught Way
    MK41 7LB Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    32 Connaught Way
    MK41 7LB Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishAccountant15183270001
    LAPLANCHE, Peter George
    Waterhouse Lane
    Gedling
    NG4 4BP Nottingham
    37a
    England
    Administrateur
    Waterhouse Lane
    Gedling
    NG4 4BP Nottingham
    37a
    England
    United KingdomBritishSales Director110994210002
    MANSWORTH, Kevin Thomas
    Banks Cottage
    The Banks
    NG13 8BT Bingham
    44
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Banks Cottage
    The Banks
    NG13 8BT Bingham
    44
    Nottinghamshire
    EnglandBritishDirector25275050007
    MCGIBBON, Lewis
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    Green Close Golf Lane
    Church Brampton
    NN16 8AY Northampton
    Northamptonshire
    BritishDirector10780150001
    RIVETT, Barry Mark
    12 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Administrateur
    12 Chantry Close
    Woburn Sands
    MK17 8UB Milton Keynes
    Buckinghamshire
    United KingdomUnited KingdomComputor Engineer101801500001
    TOMLIN, Ian Christian
    10 Gloucester Close
    Weedon
    NN7 4PA Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    10 Gloucester Close
    Weedon
    NN7 4PA Northampton
    Northamptonshire
    BritishSales Director55156370001
    WEIR, Colin Robert Selkirk
    John Ratot No 6
    Monte Ayboto
    Alfas Del P1
    Alicante 03580
    Spain
    Administrateur
    John Ratot No 6
    Monte Ayboto
    Alfas Del P1
    Alicante 03580
    Spain
    BritishDirector73972970002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur DATATRADE LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Datatrade Holdings Limited
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    15 juin 2016
    Whitwood Lane
    Whitwood
    WF10 5QD Wakefield
    Whitwood Lodge
    West Yorkshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House, Cardiff
    Numéro d'enregistrement07203076
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Mark Compton James
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    06 avr. 2016
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.
    Mrs Susan Elizabeth James
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    06 avr. 2016
    Salthouse Road
    Brackmills
    NN4 7EX Northampton
    Cornwell Business Park
    Northants
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    DATATRADE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 11 févr. 1993
    Livré le 27 févr. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £59,750.00 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All the undertaking and property wheresoever and whatsoever including the uncalled capital of datatrade limited.
    Personnes ayant droit
    • Jones Stroud & Company Limited
    Transactions
    • 27 févr. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 oct. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 20 oct. 1988
    Livré le 31 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H units 1 and 2 sterling business park salthouse road brachmills northampton and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 31 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 20 janv. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 21 sept. 1988
    Livré le 27 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 14 nov. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 07 juil. 1981
    Livré le 15 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts, uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, prepayments and cash, with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Jones Stroud and Company Limited
    Transactions
    • 15 juil. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0