PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01494788 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?
| Adresse du siège social | 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Neil Garth Jones en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Rebecca Adele Horne en tant que directeur le 01 juil. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY à 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN le 04 août 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mrs Rebecca Adele Horne en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alison Jane Clarke en tant que directeur le 14 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD à 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY le 03 juil. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Ms Alison Jane Clarke en tant qu'administrateur le 31 déc. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sally-Ann Patricia Withey en tant que directeur le 30 déc. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 4 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Kathryn Lees en tant que secrétaire le 08 août 2014 | 2 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JONES, Neil Garth | Administrateur | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | England | British | 204774750001 | |||||
| MORROW, Andrew Martin | Administrateur | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | 167225950001 | |||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Secrétaire | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | British | 76600500002 | ||||||
| BUTTERWORTH, Tina Gillian | Secrétaire | 33 Augustus Close TW8 8QE Brentford Middlesex | British | 31799060001 | ||||||
| HARIA, Jigna | Secrétaire | 47 Briar Road Kenton HA3 0DP Harrow Middlesex | British | 24063500003 | ||||||
| LEES, Jennifer Kathryn | Secrétaire | 15-17 Huntsworth Mews NW1 6DD London | British | 24587010002 | ||||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Secrétaire | 3a Devonshire Road AL5 4TJ Harpenden Hertfordshire | British | 54128690001 | ||||||
| ADAMS, Colin Raymond | Administrateur | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | 39245820011 | |||||
| ATTERBURY THOMAS, David | Administrateur | 47 St Johns Park Blackheath SE3 7JW London | England | British | 38008820001 | |||||
| BROADHEAD, Tymon Piers | Administrateur | Huntsworth Mews NW1 6DD London 15-17 | England | British | 105342600002 | |||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Administrateur | The Woodman, Howe Street, Great Waltham CM3 1BA Chelmsford | England | British | 76600500002 | |||||
| BUTTERWORTH, Tina Gillian | Administrateur | 33 Augustus Close TW8 8QE Brentford Middlesex | British | 31799060001 | ||||||
| CADMAN, Anthony | Administrateur | 23 Criffel Avenue SW2 4AY London | British | 26272690001 | ||||||
| CARSWELL, Hugh Aidan | Administrateur | Top Flat 39 Beresford Road N5 2HS London | United Kingdom | British | 46017340001 | |||||
| CLARKE, Alison Jane | Administrateur | London Wall Buildings EC2M 5SY London 3 England | United Kingdom | British | 93418210001 | |||||
| DAWSON, Paul Timothy | Administrateur | 28 Greenlands Road TW18 4LR Staines Middlesex | United Kingdom | British | 182444600001 | |||||
| GREEN, Graham James | Administrateur | Kings Mill House South Nutfield RH1 5NG Redhill Surrey | United Kingdom | British | 10528660001 | |||||
| GREENING, Nigel Douglas | Administrateur | Smallbrook Barn Thursley GU8 6QN Godalming Surrey | British | 64673590001 | ||||||
| HARIA, Jigna | Administrateur | 47 Briar Road Kenton HA3 0DP Harrow Middlesex | British | 24063500003 | ||||||
| HORNE, Rebecca Adele | Administrateur | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | United Kingdom | British | 188956200001 | |||||
| NICHOLS, Richard Stephen | Administrateur | 15a Rothamsted Avenue AL5 2DD Harpenden Hertfordshire | England | British | 54128690003 | |||||
| PEPLOW, Henry | Administrateur | The Barn Frieth RG9 6PR Henley On Thames Oxfordshire | United Kingdom | British | 101890460001 | |||||
| PERRY, Ian | Administrateur | 15 Lion Gate Gardens TW9 2DW Richmond Surrey | British | 66616730001 | ||||||
| SELMAN, Roger Malcolm | Administrateur | 5 Vineries Bank Milespit Hill Mill Hill NW7 2RP London | United Kingdom | British | 10691510002 | |||||
| TAPPING, Simon Mark | Administrateur | 43 Archway Street Barnes SW13 0AS London | British | 47935050001 | ||||||
| TUKE-HASTINGS, Derrick Somerville | Administrateur | Perrotts Brook House Perrotts Brook GL7 7BS Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 31799070001 | |||||
| WEST, Paul William | Administrateur | The Barton Neopardy EX17 5EP Crediton Devon | British | 109447350002 | ||||||
| WITHEY, Sally-Ann Patricia | Administrateur | 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD | England | British | 109428260052 | |||||
| WRIGHT, David Ernest | Administrateur | The Priory 23 Matham Road KT8 0SX East Molesey Surrey | British | 14119160001 | ||||||
| WROE, Denise | Administrateur | 3 Avenue Cottages High Street Mill Hill Village NW7 1QY London | British | 80857550001 | ||||||
| YARDLEY, Daniel John | Administrateur | Dingwall Road Earlsfield SW18 3AZ London 21a | United Kingdom | British | 147796180001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I G Communications Limited | 06 avr. 2016 | 26 Southampton Buildings WC2A 1AN London 8th Floor, Holborn Gate England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Créé le 24 avr. 2007 Livré le 15 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Créé le 21 déc. 2006 Livré le 03 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 | Créé le 16 oct. 2006 Livré le 20 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and | Créé le 12 août 2005 Livré le 26 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and | Créé le 27 juil. 2005 Livré le 04 août 2005 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 14 oct. 1987 Livré le 22 oct. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Fixed and floating charge | Créé le 20 mars 1986 Livré le 26 mars 1986 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 16 mars 1981 Livré le 30 mars 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti £10,000 | |
Brèves mentions Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0