PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED

PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01494788
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    8th Floor, Holborn Gate
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PARK AVENUE PRODUCTIONS PUBLIC LIMITED COMPANY31 déc. 198031 déc. 1980
    ENDOWN LIMITED01 mai 198001 mai 1980

    Quels sont les derniers comptes de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 20 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juil. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Neil Garth Jones en tant qu'administrateur le 01 juil. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Rebecca Adele Horne en tant que directeur le 01 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY à 8th Floor, Holborn Gate 26 Southampton Buildings London WC2A 1AN le 04 août 2016

    1 pagesAD01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 août 2015

    État du capital au 17 août 2015

    • Capital: GBP 50,120
    SH01

    Nomination de Mrs Rebecca Adele Horne en tant qu'administrateur le 01 juil. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alison Jane Clarke en tant que directeur le 14 juin 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 15-17 Huntsworth Mews London NW1 6DD à 3 London Wall Buildings London EC2M 5SY le 03 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Ms Alison Jane Clarke en tant qu'administrateur le 31 déc. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sally-Ann Patricia Withey en tant que directeur le 30 déc. 2014

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Jennifer Kathryn Lees en tant que secrétaire le 08 août 2014

    2 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 juil. 2014

    État du capital au 07 juil. 2014

    • Capital: GBP 50,120
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JONES, Neil Garth
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    EnglandBritish204774750001
    MORROW, Andrew Martin
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritish167225950001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Secrétaire
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    British76600500002
    BUTTERWORTH, Tina Gillian
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    Secrétaire
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    British31799060001
    HARIA, Jigna
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    Secrétaire
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    British24063500003
    LEES, Jennifer Kathryn
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    Secrétaire
    15-17 Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    British24587010002
    NICHOLS, Richard Stephen
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    Secrétaire
    3a Devonshire Road
    AL5 4TJ Harpenden
    Hertfordshire
    British54128690001
    ADAMS, Colin Raymond
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritish39245820011
    ATTERBURY THOMAS, David
    47 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JW London
    Administrateur
    47 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JW London
    EnglandBritish38008820001
    BROADHEAD, Tymon Piers
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    Administrateur
    Huntsworth Mews
    NW1 6DD London
    15-17
    EnglandBritish105342600002
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    Administrateur
    The Woodman,
    Howe Street, Great Waltham
    CM3 1BA Chelmsford
    EnglandBritish76600500002
    BUTTERWORTH, Tina Gillian
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    Administrateur
    33 Augustus Close
    TW8 8QE Brentford
    Middlesex
    British31799060001
    CADMAN, Anthony
    23 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    Administrateur
    23 Criffel Avenue
    SW2 4AY London
    British26272690001
    CARSWELL, Hugh Aidan
    Top Flat
    39 Beresford Road
    N5 2HS London
    Administrateur
    Top Flat
    39 Beresford Road
    N5 2HS London
    United KingdomBritish46017340001
    CLARKE, Alison Jane
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    Administrateur
    London Wall Buildings
    EC2M 5SY London
    3
    England
    United KingdomBritish93418210001
    DAWSON, Paul Timothy
    28 Greenlands Road
    TW18 4LR Staines
    Middlesex
    Administrateur
    28 Greenlands Road
    TW18 4LR Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish182444600001
    GREEN, Graham James
    Kings Mill House
    South Nutfield
    RH1 5NG Redhill
    Surrey
    Administrateur
    Kings Mill House
    South Nutfield
    RH1 5NG Redhill
    Surrey
    United KingdomBritish10528660001
    GREENING, Nigel Douglas
    Smallbrook Barn
    Thursley
    GU8 6QN Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Smallbrook Barn
    Thursley
    GU8 6QN Godalming
    Surrey
    British64673590001
    HARIA, Jigna
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    47 Briar Road
    Kenton
    HA3 0DP Harrow
    Middlesex
    British24063500003
    HORNE, Rebecca Adele
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Administrateur
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    United KingdomBritish188956200001
    NICHOLS, Richard Stephen
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    15a Rothamsted Avenue
    AL5 2DD Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish54128690003
    PEPLOW, Henry
    The Barn
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Barn
    Frieth
    RG9 6PR Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish101890460001
    PERRY, Ian
    15 Lion Gate Gardens
    TW9 2DW Richmond
    Surrey
    Administrateur
    15 Lion Gate Gardens
    TW9 2DW Richmond
    Surrey
    British66616730001
    SELMAN, Roger Malcolm
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    Administrateur
    5 Vineries Bank
    Milespit Hill Mill Hill
    NW7 2RP London
    United KingdomBritish10691510002
    TAPPING, Simon Mark
    43 Archway Street
    Barnes
    SW13 0AS London
    Administrateur
    43 Archway Street
    Barnes
    SW13 0AS London
    British47935050001
    TUKE-HASTINGS, Derrick Somerville
    Perrotts Brook House
    Perrotts Brook
    GL7 7BS Cirencester
    Gloucestershire
    Administrateur
    Perrotts Brook House
    Perrotts Brook
    GL7 7BS Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritish31799070001
    WEST, Paul William
    The Barton
    Neopardy
    EX17 5EP Crediton
    Devon
    Administrateur
    The Barton
    Neopardy
    EX17 5EP Crediton
    Devon
    British109447350002
    WITHEY, Sally-Ann Patricia
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    Administrateur
    15-17 Huntsworth Mews
    London
    NW1 6DD
    EnglandBritish109428260052
    WRIGHT, David Ernest
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    Administrateur
    The Priory
    23 Matham Road
    KT8 0SX East Molesey
    Surrey
    British14119160001
    WROE, Denise
    3 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill Village
    NW7 1QY London
    Administrateur
    3 Avenue Cottages
    High Street Mill Hill Village
    NW7 1QY London
    British80857550001
    YARDLEY, Daniel John
    Dingwall Road
    Earlsfield
    SW18 3AZ London
    21a
    Administrateur
    Dingwall Road
    Earlsfield
    SW18 3AZ London
    21a
    United KingdomBritish147796180001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    I G Communications Limited
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    06 avr. 2016
    26 Southampton Buildings
    WC2A 1AN London
    8th Floor, Holborn Gate
    England
    Non
    Forme juridiqueLimitedlliability Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement2005521
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    PARK AVENUE PRODUCTIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Créé le 24 avr. 2007
    Livré le 15 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18TH october 2004 and
    Créé le 12 août 2005
    Livré le 26 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 26 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 18 october 2004 and
    Créé le 27 juil. 2005
    Livré le 04 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of present or future accounts of the companies or any of them with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 14 oct. 1987
    Livré le 22 oct. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 22 oct. 1987Enregistrement d'une charge
    • 14 juil. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 20 mars 1986
    Livré le 26 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 mars 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 16 mars 1981
    Livré le 30 mars 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000
    Brèves mentions
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Sports Sponsorship International LTD
    Transactions
    • 30 mars 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0