RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED

RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01501703
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O SMITH & WILLIAMSON
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VESTOCROWN LIMITED13 juin 198013 juin 1980

    Quels sont les derniers comptes de RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2004

    Quels sont les derniers dépôts pour RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 janv. 2022

    5 pages4.68

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    44 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2021

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2021

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2020

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2020

    5 pages4.68

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    7 pagesNDISC

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    7 pagesNDISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2019

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2019

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2018

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2018

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2017

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2017

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2016

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2016

    5 pages4.68

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:order of court on the matter of replacement liquidators.
    4 pagesLIQ MISC OC

    Démission d'un liquidateur

    1 pages4.33

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2015

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2015

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2014

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 mars 2014

    5 pages4.68

    Qui sont les dirigeants de RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DANIELS, Jacqueline Doris
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    Secrétaire
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    British6186460001
    DANIELS, Jacqueline Doris
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    Administrateur
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    EnglandBritish6186460001
    DANIELS, Martin Gerald
    64 Shefford Road
    Clifton
    SG17 5RQ Shefford
    Bedfordshire
    Administrateur
    64 Shefford Road
    Clifton
    SG17 5RQ Shefford
    Bedfordshire
    EnglandBritish6186480001
    DANIELS, Richard Jack, Mr.
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    Administrateur
    98 New Road
    Clifton
    SG17 5JJ Shefford
    Bedfordshire
    EnglandBritish19034320001
    DANIELS, Richard John
    133 Clophill Road
    Maulden
    MK45 2UT Bedford
    Bedfordshire
    Administrateur
    133 Clophill Road
    Maulden
    MK45 2UT Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritish35118340003
    LEWIS, Nigel
    Warden Street
    Old Warden
    SG18 9LR Biggleswade
    Park Farm
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Warden Street
    Old Warden
    SG18 9LR Biggleswade
    Park Farm
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish137014860001
    SIBLEY, Edward
    Flat 511 36 Shad Thames
    Butlers Wharf Buildings
    SE1 2YE London
    Administrateur
    Flat 511 36 Shad Thames
    Butlers Wharf Buildings
    SE1 2YE London
    EnglandBritish80827610001

    RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 05 mai 1995
    Livré le 17 mai 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at rear of 34 & 36 high street, arlesey, bedfordshire. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 mai 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 21 sept. 1993
    Livré le 29 sept. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Charge over agreement dated 20TH march 1987WHEREBY the owner granted to the company an option to purchase the freehold property being part of stevenagebury farm stevenage hertfordshire and further over all interest of the company in the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 13 févr. 1992
    Livré le 17 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a fixed and floating charge dated 13TH april 1983.
    Brèves mentions
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company;and all patents patent applications inventions trade marks trade names registered designs.please see M416C for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 24 juin 1991
    Livré le 15 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or bond or developments limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Promissory note £1,150,000 by mclean homes north london limited, all rights and monies dated 24/6/91 maturity being 31/1/92 (see doc M610C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Memorandum of deposit and charge
    Créé le 24 juin 1991
    Livré le 15 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or bond or developments limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Promissory note £300,000 by mclean homes north london limited, all rights and monies dated 24/6/91 maturity being 1/7/91 (see doc M624C for full details).
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Sub-mortgage
    Créé le 24 juin 1991
    Livré le 09 juil. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the and/or bondor developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the north side of clifton road, shefford, bedfordshire title no bd 137902.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1991Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 116 shefford rd clifton, bedfordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited.
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at 120 shefford road, clifton bedfordshire formerly used as a restaurant.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 51 pedley lane clifton.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 57 pedley lane clifton bedfordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 110 shefford road clifton bedfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at 137 high street and 2 sish lane stevenage hertfordshire formerly the sale of harpers garage.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 59 pedley lane clifton bedfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear garden of 114 shefford road clifton bedfordshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Second legal charge
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 19 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land forming part of the rear of 63 pedley lane clifton bedfordshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • H. Williams & Sons (Hitchin) Limited
    Transactions
    • 19 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of the rear garden of 51 pedley lane, clifton, bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of 110 shefford rd clifton, bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of 59 pedley lane clifton, bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of 57 pedley lane clifton, bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of 63 pedley lane clifton bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of 116 shefford rd clifton, bedfordshire. And the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 30 janv. 1990
    Livré le 20 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold land forming part of the rear garden of the shefford rd, clifton, bedfordshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 20 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 janv. 1990
    Livré le 15 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £90,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H land forming part of 0.5 2245 at pound farm, london road, st. Ippollitts hitchin, hertford.
    Personnes ayant droit
    • Sheila Ansell
    Transactions
    • 15 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 nov. 1989
    Livré le 30 nov. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands hereditaments and premises being:- land at the rear of 26 grange street clifton bedfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 nov. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 06 sept. 1989
    Livré le 12 sept. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on the southeast side of park drive, baldock, hertfordshire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1989Enregistrement d'une charge
    • 06 nov. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    RICHARD DANIELS DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    22 sept. 2005Administration started
    19 sept. 2006Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Anthony Murphy
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    2
    DateType
    19 sept. 2006Commencement of winding up
    04 mai 2022Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stephen Robert Leslie Cork
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Anthony Murphy
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    Smith & Williamson
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Panos Papas
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Anthony Cliff Spicer
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    Smith & Williamson Limited
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Adam Henry Stephens
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    Henry Anthony Shinners
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London
    practitioner
    25 Moorgate
    EC2R 6AY London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0