RELITE FANS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéRELITE FANS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01505045
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de RELITE FANS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe RELITE FANS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Fernside Place
    179 Queens Road
    KT13 0AH Weybridge
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de RELITE FANS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BENDBILL LIMITED01 juil. 198001 juil. 1980

    Quels sont les derniers comptes de RELITE FANS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour RELITE FANS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Jeremy David Clarkson en tant que directeur le 19 juin 2013

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital25 févr. 2013

    État du capital au 25 févr. 2013

    • Capital: GBP 136,354
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 déc. 2008

    2 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 31 déc. 2007

    2 pagesAA

    legacy

    1 pages287

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    legacy

    2 pages363a

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de RELITE FANS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARRISON, Andrew St Clair
    26 Catlin Crescent
    TW17 8EU Shepperton
    Middlesex
    Secrétaire
    26 Catlin Crescent
    TW17 8EU Shepperton
    Middlesex
    BritishAccountant38313140002
    NEWMAN, John Watson
    Longridge
    St George's Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Longridge
    St George's Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    EnglandBritishDirector3088870002
    ANDERSON, John
    27 Croft Road
    SW19 2NF London
    Secrétaire
    27 Croft Road
    SW19 2NF London
    BritishAccountant53485800001
    ATKINS, Zoe Rachel
    3 Burden Way
    GU2 9RB Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    3 Burden Way
    GU2 9RB Guildford
    Surrey
    British72201740002
    BAGSHAW, Derrick Basil
    Horton House 75 Caverswall Road
    Blythe Bridge
    ST11 9BG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Secrétaire
    Horton House 75 Caverswall Road
    Blythe Bridge
    ST11 9BG Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishFinancial Director7292830001
    DENTON, Mark Edward
    7 Turner Close
    GU4 7JN Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    7 Turner Close
    GU4 7JN Guildford
    Surrey
    British57643460001
    FISHER, Lisa Joanne
    80 The Mount
    GU2 5JB Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    80 The Mount
    GU2 5JB Guildford
    Surrey
    BritishAccountant52428620001
    HOBBS, Wendy Jill
    36 Cater Gardens
    GU3 3BY Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    36 Cater Gardens
    GU3 3BY Guildford
    Surrey
    British35837360001
    LLEWELYN, Rhydian Hedd
    57 New Road
    Chilworth
    GU4 8LP Guildford
    Surrey
    Secrétaire
    57 New Road
    Chilworth
    GU4 8LP Guildford
    Surrey
    BritishAccountant93073060001
    PRICE, Andrew Christopher
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    The Briars
    36 Pilkington Avenue
    B72 1LD Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishAccountant120883400001
    BAGSHAW, Derrick Basil
    Horton House 75 Caverswall Road
    Blythe Bridge
    ST11 9BG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Horton House 75 Caverswall Road
    Blythe Bridge
    ST11 9BG Stoke On Trent
    Staffordshire
    BritishFinancial Director7292830001
    BALE, Andrew Paul
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    Administrateur
    157 York Road
    GU22 7XS Woking
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director76005930001
    CLARKSON, Jeremy David
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    17 Oak Ridge
    LS22 6GT Wetherby
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector29690770001
    COLLINS, Gerald Micheal
    35 Orton Road
    B79 0HX Warton
    Staffordshire
    Administrateur
    35 Orton Road
    B79 0HX Warton
    Staffordshire
    BritishManaging Director86387430001
    COMPSON, Stephen Edwin John
    Blenheim Cottage Elm Corner
    Ockham
    GU23 6PX Woking
    Surrey
    Administrateur
    Blenheim Cottage Elm Corner
    Ockham
    GU23 6PX Woking
    Surrey
    EnglandBritishDirector45307380002
    MOORE, Thomas
    Gransden House
    Cooks Bank Acton Trussell
    ST17 0RF Stafford
    Administrateur
    Gransden House
    Cooks Bank Acton Trussell
    ST17 0RF Stafford
    EnglandBritishDivisional Chief Executive83054600001
    NEWMAN, Amanda Jane
    Longridge
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    Administrateur
    Longridge
    South Road St Georges Hill
    KT13 0NA Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritishAccount Executive56633850001
    SAWFORD, John Nicholl
    38 Aldridge Park
    Winkfield Row
    RG42 7NU Bracknell
    Berkshire
    Administrateur
    38 Aldridge Park
    Winkfield Row
    RG42 7NU Bracknell
    Berkshire
    EnglandBritishDirector117851490001
    VERNON, John Humphrey
    Maybank 36 Glen Brook Road
    TF2 9QY Telford
    Salop
    Administrateur
    Maybank 36 Glen Brook Road
    TF2 9QY Telford
    Salop
    British69699460001

    RELITE FANS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge
    Créé le 26 mars 1992
    Livré le 27 mars 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company and all patents etc.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 27 mars 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed and floating charge
    Créé le 13 avr. 1989
    Livré le 24 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and asse ts present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1989
    Livré le 24 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land, factory and offices on the north side of meeting street, and east side of wednesbury, west midlands title no sf 20288 .
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 24 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 01 août 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 16 févr. 1984
    Livré le 22 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 11 nov. 1983
    Livré le 29 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the north side of meeting street, and the east side of lloyd street, wednesbury sundwell, west midlands title no sf 20288 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 29 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 11 nov. 1983
    Livré le 25 nov. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings on the northside of meeting st and the east side of lloyd st wednesbury west midlands tn sf 20288. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • County Bank Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1983Enregistrement d'une charge
    Mortgage debenture
    Créé le 23 sept. 1983
    Livré le 06 oct. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 oct. 1983Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0