RELITE FANS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | RELITE FANS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01505045 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RELITE FANS LIMITED ?
Adresse du siège social | Fernside Place 179 Queens Road KT13 0AH Weybridge Surrey |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RELITE FANS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2012 |
Quels sont les derniers dépôts pour RELITE FANS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jeremy David Clarkson en tant que directeur le 19 juin 2013 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2009 | 3 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2010 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2008 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 4 pages | 363a | ||||||||||
legacy | 1 pages | 190 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 353 | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Comptes établis au 31 déc. 2007 | 2 pages | AA | ||||||||||
legacy | 1 pages | 287 | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD | ||||||||||
legacy | 2 pages | 363a | ||||||||||
Démission de l'auditeur | 1 pages | AUD |
Qui sont les dirigeants de RELITE FANS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRISON, Andrew St Clair | Secrétaire | 26 Catlin Crescent TW17 8EU Shepperton Middlesex | British | Accountant | 38313140002 | |||||
NEWMAN, John Watson | Administrateur | Longridge St George's Hill KT13 0NA Weybridge Surrey | England | British | Director | 3088870002 | ||||
ANDERSON, John | Secrétaire | 27 Croft Road SW19 2NF London | British | Accountant | 53485800001 | |||||
ATKINS, Zoe Rachel | Secrétaire | 3 Burden Way GU2 9RB Guildford Surrey | British | 72201740002 | ||||||
BAGSHAW, Derrick Basil | Secrétaire | Horton House 75 Caverswall Road Blythe Bridge ST11 9BG Stoke On Trent Staffordshire | British | Financial Director | 7292830001 | |||||
DENTON, Mark Edward | Secrétaire | 7 Turner Close GU4 7JN Guildford Surrey | British | 57643460001 | ||||||
FISHER, Lisa Joanne | Secrétaire | 80 The Mount GU2 5JB Guildford Surrey | British | Accountant | 52428620001 | |||||
HOBBS, Wendy Jill | Secrétaire | 36 Cater Gardens GU3 3BY Guildford Surrey | British | 35837360001 | ||||||
LLEWELYN, Rhydian Hedd | Secrétaire | 57 New Road Chilworth GU4 8LP Guildford Surrey | British | Accountant | 93073060001 | |||||
PRICE, Andrew Christopher | Secrétaire | The Briars 36 Pilkington Avenue B72 1LD Sutton Coldfield West Midlands | British | Accountant | 120883400001 | |||||
BAGSHAW, Derrick Basil | Administrateur | Horton House 75 Caverswall Road Blythe Bridge ST11 9BG Stoke On Trent Staffordshire | British | Financial Director | 7292830001 | |||||
BALE, Andrew Paul | Administrateur | 157 York Road GU22 7XS Woking Surrey | England | British | Company Director | 76005930001 | ||||
CLARKSON, Jeremy David | Administrateur | 17 Oak Ridge LS22 6GT Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 29690770001 | ||||
COLLINS, Gerald Micheal | Administrateur | 35 Orton Road B79 0HX Warton Staffordshire | British | Managing Director | 86387430001 | |||||
COMPSON, Stephen Edwin John | Administrateur | Blenheim Cottage Elm Corner Ockham GU23 6PX Woking Surrey | England | British | Director | 45307380002 | ||||
MOORE, Thomas | Administrateur | Gransden House Cooks Bank Acton Trussell ST17 0RF Stafford | England | British | Divisional Chief Executive | 83054600001 | ||||
NEWMAN, Amanda Jane | Administrateur | Longridge South Road St Georges Hill KT13 0NA Weybridge Surrey | United Kingdom | British | Account Executive | 56633850001 | ||||
SAWFORD, John Nicholl | Administrateur | 38 Aldridge Park Winkfield Row RG42 7NU Bracknell Berkshire | England | British | Director | 117851490001 | ||||
VERNON, John Humphrey | Administrateur | Maybank 36 Glen Brook Road TF2 9QY Telford Salop | British | 69699460001 |
RELITE FANS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Charge | Créé le 26 mars 1992 Livré le 27 mars 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions First fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company and all patents etc. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge | Créé le 13 avr. 1989 Livré le 24 avr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge on all the undertaking and all property and asse ts present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 13 avr. 1989 Livré le 24 avr. 1989 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land, factory and offices on the north side of meeting street, and east side of wednesbury, west midlands title no sf 20288 . | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 16 févr. 1984 Livré le 22 févr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/hold & l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts & the benefit of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 11 nov. 1983 Livré le 29 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the north side of meeting street, and the east side of lloyd street, wednesbury sundwell, west midlands title no sf 20288 and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 11 nov. 1983 Livré le 25 nov. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Land and buildings on the northside of meeting st and the east side of lloyd st wednesbury west midlands tn sf 20288. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 23 sept. 1983 Livré le 06 oct. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all f/hold and l/hold properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefit of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0