HAPPENSTANCE LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | HAPPENSTANCE LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01506482 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HAPPENSTANCE LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Cc Young & Co, 3rd Floor, The Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL Holborn London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HAPPENSTANCE LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2023 |
Quels sont les derniers dépôts pour HAPPENSTANCE LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||
Cessation de la nomination de Michael David Dawson en tant que secrétaire le 26 janv. 2024 | 1 pages | TM02 | ||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2023 | 6 pages | AA | ||
Modification des détails de William a Bong Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 avr. 2023 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de Hythe House 200 Shepherds Bush Road London W6 7NL England à C/O Cc Young & Co, 3rd Floor, the Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way Holborn London WC1A 2SL le 07 avr. 2023 | 1 pages | AD01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 févr. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 6 pages | AA | ||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Déclaration de confirmation établie le 20 févr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Modification des coordonnées du secrétaire Mr Michael David Dawson le 20 févr. 2022 | 1 pages | CH03 | ||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David James Furnish le 16 févr. 2022 | 2 pages | CH01 | ||
Modification des détails de William a Bong Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 16 févr. 2022 | 2 pages | PSC05 | ||
Changement d'adresse du siège social de 1 Blythe Road London W14 0HG à Hythe House 200 Shepherds Bush Road London W6 7NL le 16 févr. 2022 | 1 pages | AD01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 6 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 5 pages | AA | ||
Déclaration de confirmation établie le 14 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Qui sont les dirigeants de HAPPENSTANCE LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURNISH, David James | Administrateur | The Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL Holborn C/O Cc Young & Co, 3rd Floor, London England | United Kingdom | Canadian | Film Producer | 41305180001 | ||||
DAWSON, Michael David | Secrétaire | The Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL Holborn C/O Cc Young & Co, 3rd Floor, London England | British | 46315450003 | ||||||
MOFFAT, Lindsay Ruth | Secrétaire | 98 Devonshire Road W4 2HS London | British | Finance Manager | 66178690001 | |||||
TURNBULL, Nicola Mary | Secrétaire | 42 Gunterstone Road W14 London | British | 1396390003 | ||||||
CHANTRY, Frederick Farebrother | Administrateur | Inglewood Fishery Road SL6 1UN Bray Berkshire | British | Retired | 24560270002 | |||||
FAREBROTHER, Sheila | Administrateur | Inglewood Fishery Road SL6 1UN Bray Berkshire | British | Retired | 24713980003 | |||||
HAYDON, Andrew Mansell | Administrateur | Southwood The Warren East Horsley KT24 5RH Leatherhead Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 3361140001 | ||||
PRESLAND, Frank George | Administrateur | 1 Blythe Road London W14 0HG | England | British | Solicitor | 33675500006 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HAPPENSTANCE LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
William A Bong Ltd | 06 avr. 2016 | The Bloomsbury Building 10 Bloomsbury Way WC1A 2SL Holborn C/O Cc Young & Co, 3rd Floor London England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
HAPPENSTANCE LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under ,pursuant to or by virtue of a development agreement dated 20 march 1992 between the company and mercury records limited or any variation modification or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under ,pursuant to or by virtue of a development agreement dated 20 june 1995 between the company and dreamworks animation llc or any variation modification or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under ,pursuant to or by virtue of a development agreement dated 1 may 1996 between the company and walt disney pictures or any variation modification or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under, pursuant to or by virtue of recording agreement dated 4 january 1999 between the company and crosby films inc. Or any variation modification or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under ,pursuant to or by virtue of a publishing agreement dated 4 november 1992 between the company, william a bong limited and warner /chappell music inc. Or any variation modification or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All income payable by the peforming rights society to sir elton hercules john, the company or william a bong in respect of the compositions listed in the schedule attached to the form 395 subject to and conditional upon the repayment or discharge of a loan from nationsbank na.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 23 sept. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums outstanding from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 12 july 1999 made between the chargee, the company, william a bong limited, j bondi limited and sir elton hercules john. | |
Brèves mentions All and any payments income and money now or hereafter due arising or to become due or payable to the company under, pursuant to or by virtue of a publishing agreement dated 4 november 1992 between the company, william a bong limited and muziekuitgeverij artemis bv or any variation modidifation or amendment of the same. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 12 juil. 1999 Livré le 16 juil. 1999 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 26 août 1981 Livré le 07 sept. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti £200,000 | |
Brèves mentions Floating charge over under. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0