CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED

CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01511847
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    • Crédit-bail (64910) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    KPMG LLP
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    4 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB à 15 Canada Square London E14 5GL le 10 avr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 janv. 2015

    4 pages4.68

    Divers

    Aud res 519
    2 pagesMISC

    Changement d'adresse du siège social de * 23 Great Winchester Street London EC2P 2AX* le 06 févr. 2014

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    4 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 févr. 2013

    État du capital au 22 févr. 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Richard Moody en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Charles Hitchings en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Scott Barkman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Dipesh Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Pamela Smith en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Faraday en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    12 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RUTHERFORD, Adam Paul
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Secrétaire
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British70451850004
    HITCHINGS, Charles
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish175089420001
    MOODY, Richard
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomIrish173822430001
    PATEL, Dipesh
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    United Kingdom
    United KingdomBritish173797130001
    CLARK, Giles Sebastian
    37 Durnsford Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BH London
    Secrétaire
    37 Durnsford Avenue
    Wimbledon Park
    SW19 8BH London
    British38517290002
    FLETCHER, Edward Michael
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    Secrétaire
    3 Aldrich Terrace
    SW18 3PU Earlsfield
    British78572640002
    GREEN, Helen Estelle
    Flat 7 Antilles Bay Apt
    Lawn House Close Isle Of Dogs
    E14 9YG London
    Secrétaire
    Flat 7 Antilles Bay Apt
    Lawn House Close Isle Of Dogs
    E14 9YG London
    British66783210007
    PAGE, Stephen Richard
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    Secrétaire
    21 Davenport Road
    Albany Park
    DA14 4PN Sidcup
    Kent
    British38547590001
    WITHINGTON, Annabel Katherine Goddard
    133 Staines Road
    TW2 5BD Twickenham
    Middlesex
    Secrétaire
    133 Staines Road
    TW2 5BD Twickenham
    Middlesex
    British7117350004
    BARKMAN, Scott Mckay
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    Administrateur
    Walden House Road
    CM9 8PJ Great Totham
    1a
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomNew Zealander91404900001
    BRADFORD, Valerie Ann
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Administrateur
    Canfield Park Cottage
    Canfield Road, Takeley
    CM22 6ST Bishops Stortford
    Hertfordshire
    British74285610001
    DEWDNEY, Andrew David
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    Administrateur
    Cranfield
    Broad Oak
    TN12 7NN Benchley
    Kent
    British88480180001
    FARADAY, Ian Paul
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    Administrateur
    Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House 1
    British117970910002
    HUTTON, Graham Stuart
    Spring Cottage Cranes Road
    RG24 9JG Sherborne St John
    Hampshire
    Administrateur
    Spring Cottage Cranes Road
    RG24 9JG Sherborne St John
    Hampshire
    EnglandBritish142062250001
    LICKLEY, Gavin Alexander Fraser
    6 Westmoreland Road
    SW13 9RY London
    Administrateur
    6 Westmoreland Road
    SW13 9RY London
    EnglandBritish6625070001
    MICHIE, William Guthrie Mcgregor
    57 Charterfield Avenue
    Putney
    SW15 6HW London
    Administrateur
    57 Charterfield Avenue
    Putney
    SW15 6HW London
    EnglandBritish10456220001
    O'SULLIVAN, Lee Scott
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British120275570002
    OSBORNE, David Hase
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Manor House
    Bishops Down Road
    TN4 8XL Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish7602680004
    RICHARDS, Christopher Murray
    3 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0PG London
    Administrateur
    3 Kidbrooke Grove
    Blackheath
    SE3 0PG London
    EnglandBritish92831120001
    ROOS, Nicholas Andrew
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    Administrateur
    2 Claremont Park
    N3 1TH London
    British88479620001
    SHORT, John Mayow
    Northumberland House
    134 New Kings Road
    SW6 4LZ London
    Administrateur
    Northumberland House
    134 New Kings Road
    SW6 4LZ London
    EnglandUnited Kingdom7117360002
    SMITH, Pamela Hindley
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB
    Winchester House
    London
    United Kingdom
    British38994140002
    THOMAS, Duncan Patrick
    Beaumaris Longacre
    High Street
    SG17 5LZ Meppershall
    Bedfordshire
    Administrateur
    Beaumaris Longacre
    High Street
    SG17 5LZ Meppershall
    Bedfordshire
    British27510460001
    TWIDALE, Peter Gordon
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    Administrateur
    12 Baymans Wood
    Shenfield
    CM15 8BT Brentwood
    Essex
    British73077810001
    WILLIAMS, Vaughan
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    Administrateur
    1 Great Winchester Street
    EC2N 2DB London
    Winchester House
    British33495830005

    CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    First priority aircraft mortgage
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 28 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become from the company to the security under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first priority legal mortgage all right, title and interest (present and future) in and to the aircraft. By way of first priority legal assignment, all of its right, title and interest (present and future) in and to the assigned property.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC, as Security Trustee for and on Behalf of Itself, the Beneficiaries and Theother Beneficiaries
    Transactions
    • 28 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority deposit charge
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the original owner and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority deposit charge
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 29 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the original owner and the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of the right title and interest in the account and the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 29 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority aircraft mortgage
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 21 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the original mortgagor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest (present and future) in and to the aircraft and the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 21 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority aircraft mortgage
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 21 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the original mortgagor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest (present and future) in and to the aircraft and the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreditanstalt Fur Wiederaufbau, as Security Trustee for and on Behalf of the Beneficiaries
    Transactions
    • 21 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority aircraft mortgage
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 18 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest in and to the assigned property,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for Itself,the Beneficiaries and Other Beneficiaries
    Transactions
    • 18 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority aircraft mortgage
    Créé le 11 oct. 2002
    Livré le 18 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right,title and interest in and to the assigned property,as defined; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC,as Security Trustee for Itself,the Beneficiaries and Other Beneficiaries
    Transactions
    • 18 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of covenant
    Créé le 25 juil. 1983
    Livré le 27 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing sterling pounds 1,196, 000 and all other monies due or to become due from the company to the chargeon account credit under the terms of theterms of the secerity docs as described in the charge.
    Brèves mentions
    The mortgaged premises being the ship the owners insurances and earnings of the ship as respectively defined in the deed of covenant (see doc M11).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 27 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutory mortgage
    Créé le 25 juil. 1983
    Livré le 27 juil. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on an account current under the terms of a financial agreement dated 31/12/82 an agreement supplemental there to dated 18/2/83 and a deed of covenant dated 25/7/83.
    Brèves mentions
    64/64 shares in M. V. "beamer" registered at the part of leith under official no 398732 and her boats and appurtenances.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 27 juil. 1983Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of covenant
    Créé le 06 juin 1983
    Livré le 08 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing sterling pounds 1,196,00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the financial agreement montioned in the mortgage dated 6/6/83 and this deed.
    Brèves mentions
    The mortgaged premises, being the ship, the owner's insurances and the earnings of the ship as respectively defined in the deed of covenant (see doc M11).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 08 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Statutary mortgage
    Créé le 06 juin 1983
    Livré le 08 juin 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 31/12/82 an agreement supplemental thereto dated 18/2/8O (tog. Known as the financial agreement) and the deed of covenant dated 6/6/83.
    Brèves mentions
    64/64 shares in m v "seal carr" registered at the port of leith under official no:- 398733.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transactions
    • 08 juin 1983Enregistrement d'une charge
    • 18 juil. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    CITY LEASING (SEVERNSIDE) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 juil. 2015Dissolved on
    28 janv. 2014Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    practitioner
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0