ABBEY PRODUCE LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéABBEY PRODUCE LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01516331
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ABBEY PRODUCE LTD ?

    • Commerce de gros de fruits et légumes (46310) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe ABBEY PRODUCE LTD ?

    Adresse du siège social
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ABBEY PRODUCE LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ABBEY PRODUCE (RAMSEY) LIMITED08 sept. 198008 sept. 1980

    Quels sont les derniers comptes de ABBEY PRODUCE LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour ABBEY PRODUCE LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Duncan Negus en tant que directeur le 17 janv. 2023

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2021 au 30 juin 2022

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2020

    13 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    La totalité de la propriété ou de l'entreprise a été libérée de la charge 11

    2 pagesMR05

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2019

    12 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2018

    13 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 24 mai 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl David Sutton le 12 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Robert Sutton le 01 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Clifford Sutton le 01 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Carl David Sutton le 01 août 2017

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Tracey Jayne Salisbury le 01 août 2017

    1 pagesCH03

    Qui sont les dirigeants de ABBEY PRODUCE LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SALISBURY, Tracey Jayne
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    British48823220002
    SUTTON, Carl David
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish150881640025
    SUTTON, David Clifford
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish1427910002
    SUTTON, Nicholas Robert
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish73695340004
    SUTTON, David Clifford
    Wakes Crossing
    Back Lane Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Wakes Crossing
    Back Lane Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British1427910002
    SUTTON, Gwendoline Pearl
    Wakes Crossing
    Back Lane,Holywell
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    Wakes Crossing
    Back Lane,Holywell
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British1427900001
    BOWEN, Simon
    5 St Johns Close
    Woodhurst
    PE28 3BG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    5 St Johns Close
    Woodhurst
    PE28 3BG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British76536380001
    NEGUS, Duncan
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Nene Lodge Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Cambridgeshire
    British9941550002
    SUTTON, Carl David
    Flat 12 New Crane Wharf
    4 New Crane Place
    E1 London
    Administrateur
    Flat 12 New Crane Wharf
    4 New Crane Place
    E1 London
    British73695300001
    SUTTON, David Clifford
    Wakes Crossing
    Back Lane Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Wakes Crossing
    Back Lane Holywell
    PE27 4TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish1427910002
    SUTTON, Gwendoline Pearl
    Wakes Crossing
    Back Lane,Holywell
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    Wakes Crossing
    Back Lane,Holywell
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridgeshire
    British1427900001
    SUTTON, Nicholas Robert
    81 Brookfield Way
    CB3 6EB Lower Cambourne
    Cambridgeshire
    Administrateur
    81 Brookfield Way
    CB3 6EB Lower Cambourne
    Cambridgeshire
    British73695340001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ABBEY PRODUCE LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    The Abbey Group Cambridgeshire Limited
    Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Nene Lodge
    Cambs
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Funthams Lane
    Whittlesey
    PE7 2PB Peterborough
    Nene Lodge
    Cambs
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement02197844
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    ABBEY PRODUCE LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 26 juil. 1999
    Livré le 10 août 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 août 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 11 juin 2021L'ensemble de la propriété ou de l'entreprise a été libéré de la charge (MR05)
    • 15 juin 2021Satisfaction d'une charge (MR04)
    Book debts debenture
    Créé le 18 oct. 1994
    Livré le 26 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A first fixed charge on all the book debts and other debts of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 26 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 nov. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Credit agreement
    Créé le 10 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £16,444.92
    Brèves mentions
    All its right title and interest in all sums payable under the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Credit agreement
    Créé le 15 juin 1993
    Livré le 19 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £25,326.58
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 19 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Credit agreement
    Créé le 15 juin 1992
    Livré le 23 juin 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £19,025.78
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the insurance.
    Personnes ayant droit
    • Close Brothers Limited
    Transactions
    • 23 juin 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 janv. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Confirmatory charge
    Créé le 10 sept. 1991
    Livré le 17 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage dated 05.11.85
    Brèves mentions
    Property k/a warehouse office and yard situate off stocking fen road ramsey as charged by the mortgage and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Confirmatory charge
    Créé le 10 sept. 1991
    Livré le 17 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a legal mortgage dated 08.08.88
    Brèves mentions
    All land and property situate at 7.468 acres land (os no.959) in the bill ramsey cambs as charged in the legal mortgage and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Confirmatory charge
    Créé le 10 sept. 1991
    Livré le 17 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage debenture dated 04.03.85
    Brèves mentions
    The property and assets of the company as charged in the mortgage debenture.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 17 sept. 1991Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 08 août 1988
    Livré le 12 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The f/h known as 7.468 acres of land in the bill ramsey cambridgeshire &/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 nov. 1985
    Livré le 11 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Warehouse offices and yard situate off stocking fen road ramsey in the county of cambridge and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 mars 1985
    Livré le 12 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific & equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 12 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 19 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0