CHESTERFIELDEND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHESTERFIELDEND LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01522119
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Banner Cross Hall
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HENRY BOOT CHESTERFIELD LIMITED14 oct. 198014 oct. 1980

    Quels sont les derniers comptes de CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2012

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed henry boot chesterfield LIMITED\certificate issued on 02/08/13
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name02 août 2013

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name02 août 2013

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2013

    État du capital au 10 juin 2013

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Nomination de Mr Russell Alan Deards en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Eleanor Christmas en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Timothy Washer en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    17 pagesAA

    Cessation de la nomination de Douglas Greaves en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    15 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    3 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    Cessation de la nomination de Jonathan Boot en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Timothy Michael Washer le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr John Trevor Sutcliffe le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Douglas Greaves le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jonathan Hamer Boot le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Edward James Boot le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Robert Anderson le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de CHESTERFIELDEND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DEARDS, Russell Alan
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    178731210001
    ANDERSON, David Robert
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    EnglandBritish106115300001
    BOOT, Edward James
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    United KingdomBritish7568670006
    SUTCLIFFE, John Trevor
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    EnglandBritish81186640002
    CHRISTMAS, Eleanor Sian Siriol
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    British7568660004
    BOOT, Jonathan Hamer
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    United KingdomBritish47616420001
    BRADY, Roger
    Pinewood Lodge
    Gold Hill, Tansley
    DE4 5FG Matlock
    Derbyshire
    Administrateur
    Pinewood Lodge
    Gold Hill, Tansley
    DE4 5FG Matlock
    Derbyshire
    British34029810001
    GLEDHILL, John Kenneth
    10 Meadowfield
    Whaley Bridge
    SK23 7AX High Peak
    Derbyshire
    Administrateur
    10 Meadowfield
    Whaley Bridge
    SK23 7AX High Peak
    Derbyshire
    British106533510001
    GREAVES, Douglas
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    United KingdomBritish4699610002
    WASHER, Timothy Michael
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    United KingdomBritish47616750001

    CHESTERFIELDEND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 06 mai 2009
    Livré le 09 mai 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental charge
    Créé le 25 juil. 1986
    Livré le 15 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent & trustee for the banks as defined and hessische landes bank - gironzen trade supplemental to the principal deed dated 21.2.86.
    Brèves mentions
    All the property undertaking and assets charged by the charges created by the guarantee & debenture dated 21.2.86. (see doc 25 for fuller details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1986Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 févr. 1986
    Livré le 06 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks. On any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details see doc M24). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1986Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0