COMMTECH LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCOMMTECH LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01524025
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de COMMTECH LIMITED ?

    • Activités combinées de soutien aux installations (81100) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe COMMTECH LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1020 Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de COMMTECH LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour COMMTECH LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 14 févr. 2017

    2 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de C/O Ta Hydronics Ltd Unit 3 Nimbus Park Porz Avenue Dunstable Bedfordshire LU5 5WZ à 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 03 janv. 2017

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 déc. 2016

    LRESSP

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Nomination de Mr Ivan Edward Ronald en tant qu'administrateur le 22 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John O'shea en tant qu'administrateur le 22 sept. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mai 2016

    État du capital au 05 mai 2016

    • Capital: GBP 51,100
    SH01

    Cessation de la nomination de David John Dzimitrowicz en tant que directeur le 08 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mai 2015

    État du capital au 06 mai 2015

    • Capital: GBP 51,100
    SH01

    Nomination de Mr Paul Joseph Auchterlounie en tant qu'administrateur le 15 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de David Richard Reading en tant que secrétaire le 15 avr. 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Paul Joseph Auchterlounie en tant que secrétaire le 15 avr. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Richard Reading en tant que directeur le 15 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2014

    État du capital au 26 mars 2014

    • Capital: GBP 51,100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Gunilla Anderson en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr David John Dzimitrowicz en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de COMMTECH LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    AUCHTERLOUNIE, Paul Joseph
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Secrétaire
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    197422430001
    AUCHTERLOUNIE, Paul Joseph
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    Administrateur
    Eskdale Road
    Winnersh
    RG41 5TS Wokingham
    1020
    United KingdomBritishAccountant195511300001
    O'SHEA, John
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7XZ Birmingham
    Lakeside
    England
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7XZ Birmingham
    Lakeside
    England
    EnglandIrishGroup Legal Director50598730002
    RONALD, Ivan Edward
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7XZ Birmingham
    Lakeside
    England
    Administrateur
    Solihull Parkway
    Birmingham Business Park
    B37 7XZ Birmingham
    Lakeside
    England
    EnglandBritishGroup Financial Controller159007200001
    BOWER, Joanne Carol
    4 Riland Road
    Sutton Coldfield
    B75 7AT Birmingham
    West Midlands
    Secrétaire
    4 Riland Road
    Sutton Coldfield
    B75 7AT Birmingham
    West Midlands
    BritishSolicitor69187740003
    BRITNELL, Andrew Nicholas
    Coldharbour Farm Coldharbour Lane
    Hildenborough
    TN11 9JX Tonbridge
    Kent
    Secrétaire
    Coldharbour Farm Coldharbour Lane
    Hildenborough
    TN11 9JX Tonbridge
    Kent
    British11295820005
    JARMAN, Karen
    Woodside Spring Avenue
    Thwaites Brow
    BD21 4TA Keighley
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Woodside Spring Avenue
    Thwaites Brow
    BD21 4TA Keighley
    West Yorkshire
    BritishAccountant95804350001
    LELLIOTT, Paul
    28 The Boulevard
    BN13 1LB Worthing
    West Sussex
    Secrétaire
    28 The Boulevard
    BN13 1LB Worthing
    West Sussex
    BritishAccountant67145900002
    READING, David Richard
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    155073210001
    TUTT, Jeremy Edward
    Middle Village
    RH16 4GH Haywards Heath
    82
    West Sussex
    United Kingdom
    Secrétaire
    Middle Village
    RH16 4GH Haywards Heath
    82
    West Sussex
    United Kingdom
    BritishFinance Director116946530003
    ANDERSON, Gunilla Anna Marie
    3 Tvarasgatan
    Goteborg
    Se-417 28
    Sweden
    Administrateur
    3 Tvarasgatan
    Goteborg
    Se-417 28
    Sweden
    SwedenSwedishChief Financial Officer128740880001
    BORGVALL, Per Olle Hakan
    Hjortgatan 8
    Herrljunga
    Se 52431
    Sweden
    Administrateur
    Hjortgatan 8
    Herrljunga
    Se 52431
    Sweden
    SwedishDirector99218580001
    BRITNELL, Andrew Nicholas
    Coldharbour Farm Coldharbour Lane
    Hildenborough
    TN11 9JX Tonbridge
    Kent
    Administrateur
    Coldharbour Farm Coldharbour Lane
    Hildenborough
    TN11 9JX Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishCompany Director11295820005
    CLARK, Roger
    Mayfield Cottage
    21 Tadorne Road
    KT20 5TD Tadworth
    Surrey
    Administrateur
    Mayfield Cottage
    21 Tadorne Road
    KT20 5TD Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director20239300002
    DINEEN, Kevin John
    5 Suffolk Close
    RG41 3AU Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    5 Suffolk Close
    RG41 3AU Wokingham
    Berkshire
    BritishCommissioning Management75648880002
    DZIMITROWICZ, David John
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector116016860002
    HAWKINS, Stephen John
    11 Longmead
    GU52 7TR Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    11 Longmead
    GU52 7TR Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector103514020001
    JOHANSSON, Nils Olof
    Jutegatan 25
    Bramhult
    Se-507 34
    Sweden
    Administrateur
    Jutegatan 25
    Bramhult
    Se-507 34
    Sweden
    SwedishDirector87491180001
    JOINER, Malcolm Stuart Drummond
    2 Lodgewood Cottages Hever Road
    Hever
    TN8 7NP Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    2 Lodgewood Cottages Hever Road
    Hever
    TN8 7NP Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishManager61891160001
    LELLIOTT, Paul
    28 The Boulevard
    BN13 1LB Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    28 The Boulevard
    BN13 1LB Worthing
    West Sussex
    BritishAccountant67145900002
    MITCHELL, Mark Richard
    The Lilacs Uckfield Lane
    Hever
    TN8 7LJ Edenbridge
    Kent
    Administrateur
    The Lilacs Uckfield Lane
    Hever
    TN8 7LJ Edenbridge
    Kent
    United KingdomBritishManager102033870001
    READING, David Richard
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Ta Hydronics Ltd
    Nimbus Park
    Porz Avenue
    LU5 5WZ Dunstable
    Unit 3
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant2740040002
    SEPULVEDA, Andres
    Calderon De La Barca 34
    FOREIGN Las Rozas
    Madrid 28230
    Spain
    Administrateur
    Calderon De La Barca 34
    FOREIGN Las Rozas
    Madrid 28230
    Spain
    SpanishDirector87596360001
    SJOBLOM, Stig Johan
    Woodlands
    Woodland Way
    KT20 6NU Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Woodlands
    Woodland Way
    KT20 6NU Kingswood
    Surrey
    United KingdomSwedishEngineer38291340001

    COMMTECH LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 07 mai 2002
    Livré le 09 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All deposits now and in the future credited to account designation 9034579 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 19 août 1996
    Livré le 23 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 30 breakfield ullswater crescent coulddon surrey t/no.SGL150422 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 23 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 05 août 1996
    Livré le 09 août 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 août 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juin 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed charge
    Créé le 05 avr. 1995
    Livré le 06 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £10,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    1 x used bmw 535I SE, 4 door saloon. Registration no. J927 ptf, chassis no. W8AHD12070BF01949.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transactions
    • 06 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 janv. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 17 nov. 1993
    Livré le 19 nov. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H-30 breakfield coulsdon surrey and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 17 mai 1988
    Livré le 19 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 19 mai 1988Enregistrement d'une charge
    • 08 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 09 mai 1984
    Livré le 15 mai 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all leasehold & freehold propeties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over: undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill and the benefit of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1984Enregistrement d'une charge

    COMMTECH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 déc. 2016Commencement of winding up
    08 févr. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Sean Kenneth Croston
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire
    practitioner
    1 Dorset Street
    SO15 2DP Southampton
    Hampshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0