COMMTECH LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | COMMTECH LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01524025 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COMMTECH LIMITED ?
Adresse du siège social | 1020 Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COMMTECH LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour COMMTECH LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 5 pages | LIQ13 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP à 1020 Eskdale Road Winnersh Wokingham RG41 5TS le 14 févr. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Ta Hydronics Ltd Unit 3 Nimbus Park Porz Avenue Dunstable Bedfordshire LU5 5WZ à 1 Dorset Street Southampton Hampshire SO15 2DP le 03 janv. 2017 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 3 pages | 4.70 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 2 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||||||
Nomination de Mr Ivan Edward Ronald en tant qu'administrateur le 22 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John O'shea en tant qu'administrateur le 22 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David John Dzimitrowicz en tant que directeur le 08 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 14 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Paul Joseph Auchterlounie en tant qu'administrateur le 15 avr. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Richard Reading en tant que secrétaire le 15 avr. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Paul Joseph Auchterlounie en tant que secrétaire le 15 avr. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Richard Reading en tant que directeur le 15 avr. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2012 | 15 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 mars 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Gunilla Anderson en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David John Dzimitrowicz en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de COMMTECH LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCHTERLOUNIE, Paul Joseph | Secrétaire | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 | 197422430001 | |||||||
AUCHTERLOUNIE, Paul Joseph | Administrateur | Eskdale Road Winnersh RG41 5TS Wokingham 1020 | United Kingdom | British | Accountant | 195511300001 | ||||
O'SHEA, John | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7XZ Birmingham Lakeside England | England | Irish | Group Legal Director | 50598730002 | ||||
RONALD, Ivan Edward | Administrateur | Solihull Parkway Birmingham Business Park B37 7XZ Birmingham Lakeside England | England | British | Group Financial Controller | 159007200001 | ||||
BOWER, Joanne Carol | Secrétaire | 4 Riland Road Sutton Coldfield B75 7AT Birmingham West Midlands | British | Solicitor | 69187740003 | |||||
BRITNELL, Andrew Nicholas | Secrétaire | Coldharbour Farm Coldharbour Lane Hildenborough TN11 9JX Tonbridge Kent | British | 11295820005 | ||||||
JARMAN, Karen | Secrétaire | Woodside Spring Avenue Thwaites Brow BD21 4TA Keighley West Yorkshire | British | Accountant | 95804350001 | |||||
LELLIOTT, Paul | Secrétaire | 28 The Boulevard BN13 1LB Worthing West Sussex | British | Accountant | 67145900002 | |||||
READING, David Richard | Secrétaire | c/o Ta Hydronics Ltd Nimbus Park Porz Avenue LU5 5WZ Dunstable Unit 3 Bedfordshire United Kingdom | 155073210001 | |||||||
TUTT, Jeremy Edward | Secrétaire | Middle Village RH16 4GH Haywards Heath 82 West Sussex United Kingdom | British | Finance Director | 116946530003 | |||||
ANDERSON, Gunilla Anna Marie | Administrateur | 3 Tvarasgatan Goteborg Se-417 28 Sweden | Sweden | Swedish | Chief Financial Officer | 128740880001 | ||||
BORGVALL, Per Olle Hakan | Administrateur | Hjortgatan 8 Herrljunga Se 52431 Sweden | Swedish | Director | 99218580001 | |||||
BRITNELL, Andrew Nicholas | Administrateur | Coldharbour Farm Coldharbour Lane Hildenborough TN11 9JX Tonbridge Kent | England | British | Company Director | 11295820005 | ||||
CLARK, Roger | Administrateur | Mayfield Cottage 21 Tadorne Road KT20 5TD Tadworth Surrey | British | Company Director | 20239300002 | |||||
DINEEN, Kevin John | Administrateur | 5 Suffolk Close RG41 3AU Wokingham Berkshire | British | Commissioning Management | 75648880002 | |||||
DZIMITROWICZ, David John | Administrateur | c/o Ta Hydronics Ltd Nimbus Park Porz Avenue LU5 5WZ Dunstable Unit 3 Bedfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 116016860002 | ||||
HAWKINS, Stephen John | Administrateur | 11 Longmead GU52 7TR Fleet Hampshire | England | British | Director | 103514020001 | ||||
JOHANSSON, Nils Olof | Administrateur | Jutegatan 25 Bramhult Se-507 34 Sweden | Swedish | Director | 87491180001 | |||||
JOINER, Malcolm Stuart Drummond | Administrateur | 2 Lodgewood Cottages Hever Road Hever TN8 7NP Edenbridge Kent | United Kingdom | British | Manager | 61891160001 | ||||
LELLIOTT, Paul | Administrateur | 28 The Boulevard BN13 1LB Worthing West Sussex | British | Accountant | 67145900002 | |||||
MITCHELL, Mark Richard | Administrateur | The Lilacs Uckfield Lane Hever TN8 7LJ Edenbridge Kent | United Kingdom | British | Manager | 102033870001 | ||||
READING, David Richard | Administrateur | c/o Ta Hydronics Ltd Nimbus Park Porz Avenue LU5 5WZ Dunstable Unit 3 Bedfordshire United Kingdom | England | British | Accountant | 2740040002 | ||||
SEPULVEDA, Andres | Administrateur | Calderon De La Barca 34 FOREIGN Las Rozas Madrid 28230 Spain | Spanish | Director | 87596360001 | |||||
SJOBLOM, Stig Johan | Administrateur | Woodlands Woodland Way KT20 6NU Kingswood Surrey | United Kingdom | Swedish | Engineer | 38291340001 |
COMMTECH LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Charge of deposit | Créé le 07 mai 2002 Livré le 09 mai 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All deposits now and in the future credited to account designation 9034579 with the bank and any deposit or account of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 19 août 1996 Livré le 23 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a 30 breakfield ullswater crescent coulddon surrey t/no.SGL150422 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Mortgage debenture | Créé le 05 août 1996 Livré le 09 août 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge | Créé le 05 avr. 1995 Livré le 06 avr. 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti £10,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brèves mentions 1 x used bmw 535I SE, 4 door saloon. Registration no. J927 ptf, chassis no. W8AHD12070BF01949. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 17 nov. 1993 Livré le 19 nov. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H-30 breakfield coulsdon surrey and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Single debenture | Créé le 17 mai 1988 Livré le 19 mai 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 09 mai 1984 Livré le 15 mai 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions A specific equitable charge over all leasehold & freehold propeties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charges over: undertaking and all property and assets present and future including bookdebts, goodwill and the benefit of any licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
COMMTECH LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0