HARCOURT GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHARCOURT GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01524323
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HARCOURT GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    20 Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    THORPAC GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY31 déc. 198131 déc. 1981
    BENSBECK LIMITED24 oct. 198024 oct. 1980

    Quels sont les derniers comptes de HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    9 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    9 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    9 pagesAA

    Nomination de Mrs Julia O'connor en tant que secrétaire le 17 oct. 2016

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Marghub Ahmed Shaikh en tant que secrétaire le 17 oct. 2016

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de John Alexander Young en tant que directeur le 18 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Marghub Ahmed Shaikh en tant que secrétaire le 23 sept. 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Shokat Ali Akbar en tant que secrétaire le 23 sept. 2015

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 sept. 2015

    État du capital au 02 sept. 2015

    • Capital: GBP 13,871,622
    SH01

    Cessation de la nomination de Khosrow Tahmasebi en tant que directeur le 01 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    9 pagesAA

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Julia Helen O'connor en tant que secrétaire le 18 mars 2015

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de Isfryn Industrial Estate Blackmill Bridgend Mid Glamorgan CF35 6EQ à 20 Brickfield Road Birmingham B25 8HE le 20 mars 2015

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Shokat Ali Akbar en tant que secrétaire le 18 mars 2015

    2 pagesAP03

    Nomination de Mr John Alexander Young en tant qu'administrateur le 18 mars 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr David Leslie Smith en tant qu'administrateur le 18 mars 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital19 août 2014

    État du capital au 19 août 2014

    • Capital: GBP 13,871,622
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    9 pagesAA

    Nomination de Mrs Julia Helen O'connor en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    O'CONNOR, Julia
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    Secrétaire
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    216418430001
    SMITH, David Leslie
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Administrateur
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    EnglandBritish189639980001
    AKBAR, Shokat Ali
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Secrétaire
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    196066620001
    BLAKEN, Stephen Graham
    Glyn Terrace
    Blaenclydach
    CF40 2EG Tonypandy
    4
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    Glyn Terrace
    Blaenclydach
    CF40 2EG Tonypandy
    4
    Mid Glamorgan
    British135666100001
    CANN, Andrew John
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    Secrétaire
    Grange House
    Somerford Keynes
    GL7 6EW Cirencester
    Gloucestershire
    British10621040001
    GENTRY, Kenneth Victor
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British22290440001
    HARRIS, Michael James Robert
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    Secrétaire
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    British36974100002
    LOO, Helen Sork Ching
    4 Hollyhock Drive
    Brackla
    CF31 2NS Bridgend
    Mid Glamorgan
    Secrétaire
    4 Hollyhock Drive
    Brackla
    CF31 2NS Bridgend
    Mid Glamorgan
    British74360030001
    MALTHOUSE, James Leonard
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    Secrétaire
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    British37254960002
    MOSS, Nigel Adam
    29 Ossulton Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0DT London
    Secrétaire
    29 Ossulton Way
    Hampstead Garden Suburb
    N2 0DT London
    British34044210003
    MURPHY, Michael Joseph
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    Secrétaire
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    British31259900002
    O'CONNOR, Julia Helen
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Secrétaire
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    181014280001
    SHAIKH, Marghub Ahmed
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    Secrétaire
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    201219580001
    WILLIAMS, David Brian
    48 Victoria Road
    CF64 3HY Penarth
    Vale Of Glamorgan
    Secrétaire
    48 Victoria Road
    CF64 3HY Penarth
    Vale Of Glamorgan
    British6237820001
    BOYD, Stephen David
    30 Dartmoor Drive
    PE18 8XT Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    30 Dartmoor Drive
    PE18 8XT Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritish11136470002
    DOWLING, Christopher Bruce
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    Administrateur
    110 Home Park Road
    Wimbledon
    SW19 7HU London
    United KingdomAustralian28868820003
    DOWLING, Christopher Bruce
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Administrateur
    Rutland House
    Rutland Gardens
    SW7 1BX Knightsbridge
    London
    Australian28868820001
    FRANKLIN, Grant Roger
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    Administrateur
    Perton Court Farm Cottage
    Pattingham Road
    WV6 7HD Wolverhampton
    British4876290002
    FREEDMAN, Michael Anthony
    The Old Vicarage
    OX5 1AG Stanton Harcourt
    Oxfordshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    OX5 1AG Stanton Harcourt
    Oxfordshire
    British53044160001
    GENTRY, Kenneth Victor
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    Administrateur
    1 The Burrows
    Newton
    CF36 5AJ Porthcawl
    Mid Glamorgan
    British22290440001
    HARRIS, Michael James Robert
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    Administrateur
    13 Culmstock Road
    Battersea
    SW11 6LZ London
    United KingdomBritish36974100002
    HIND, John Douglas
    32 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    32 Priory Gardens
    PE9 2EG Stamford
    Lincolnshire
    United KingdomBritish68009780002
    MALTHOUSE, James Leonard
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    Administrateur
    46 Bowerdean Street
    SW6 3TW London
    EnglandBritish37254960002
    MARTIN, John
    Bourne Park
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DG Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Bourne Park
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DG Andover
    Hampshire
    British22730300001
    MORGANS, Amanda Jane
    24 Riverside
    Winchcombe
    GL54 5JP Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    24 Riverside
    Winchcombe
    GL54 5JP Cheltenham
    Gloucestershire
    British42130090004
    MURPHY, Michael Joseph
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    The Gables Chargrove Lane
    Shurdington
    GL51 5XB Cheltenham
    Gloucestershire
    British31259900002
    RHEAD, David Michael
    Cherry Trees 62 Little Sutton Lane
    Four Oaks
    B75 6PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    Cherry Trees 62 Little Sutton Lane
    Four Oaks
    B75 6PE Sutton Coldfield
    West Midlands
    British29783670001
    TAHMASEBI, Khosrow
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    Administrateur
    The Paddocks
    3 Lavender Close
    CR3 5DW Chaldon Common
    Surrey
    United KingdomBritish38518070001
    UNDERHILL, Peter John
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    Administrateur
    Maes Court
    Knighton On Teme
    WR15 8LY Tenbury Wells
    Worcestershire
    British17203000001
    YOUNG, John Alexander
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    Administrateur
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    England
    United KingdomBritish213099570001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARCOURT GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Shabir Majid Alimahomed
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    06 avr. 2016
    Brickfield Road
    B25 8HE Birmingham
    20
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Arab Emirates
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur les activités d'une société de personnes qui, en vertu de la loi qui la régit, n'est pas une personne morale ; et les membres de cette société de personnes (en cette qualité) détiennent, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    HARCOURT GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 08 mars 2002
    Livré le 11 mars 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited in Its Capacity as Security Trustee for the Loan Noteholders (The Trustee)
    Transactions
    • 11 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture deed
    Créé le 08 mars 2002
    Livré le 09 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture deed
    Créé le 08 mars 2002
    Livré le 09 mars 2002
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 09 mars 2002Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 28 avr. 2000
    Livré le 05 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company (formerly known as harcourt group PLC) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Fortis Bank Sa-Nv
    Transactions
    • 05 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mai 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 2000
    Livré le 02 févr. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an offer letter dated 21ST september 1998
    Brèves mentions
    Land and buildings on the south side of isfryn blackmill bridgend.
    Personnes ayant droit
    • The Welsh Development Agency
    Transactions
    • 02 févr. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 22 nov. 2001Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Legal mortgage
    Créé le 04 juil. 1996
    Livré le 09 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from C.I. converters limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/as siston centre kingswood bristol also k/as land on the north east side of station road kingswood bristol avon t/no av 86250 and av 215211 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 déc. 1989
    Livré le 02 janv. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Sctoland PLC
    Transactions
    • 02 janv. 1990Enregistrement d'une charge
    • 12 oct. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 1984
    Livré le 16 oct. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H 1 elliot road love lane industrial estate grencester gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 oct. 1984Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 16 août 1984
    Livré le 21 août 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H. 12 wilkinson rd, cirencester gloucestershire.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 août 1984Enregistrement d'une charge
    Chattels mortgage
    Créé le 17 févr. 1984
    Livré le 18 févr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All and singuler the details plant machinery & items discribed in the schedule (for full details see doc M17).
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited.
    Transactions
    • 18 févr. 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 25 juin 1981
    Livré le 03 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital,.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0