HARCOURT GROUP LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | HARCOURT GROUP LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01524323 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe HARCOURT GROUP LIMITED ?
| Adresse du siège social | 20 Brickfield Road B25 8HE Birmingham |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de HARCOURT GROUP LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour HARCOURT GROUP LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 9 pages | AA | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 9 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Julia O'connor en tant que secrétaire le 17 oct. 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Marghub Ahmed Shaikh en tant que secrétaire le 17 oct. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de John Alexander Young en tant que directeur le 18 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Marghub Ahmed Shaikh en tant que secrétaire le 23 sept. 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shokat Ali Akbar en tant que secrétaire le 23 sept. 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de Khosrow Tahmasebi en tant que directeur le 01 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 11 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Julia Helen O'connor en tant que secrétaire le 18 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Isfryn Industrial Estate Blackmill Bridgend Mid Glamorgan CF35 6EQ à 20 Brickfield Road Birmingham B25 8HE le 20 mars 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Shokat Ali Akbar en tant que secrétaire le 18 mars 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Nomination de Mr John Alexander Young en tant qu'administrateur le 18 mars 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Leslie Smith en tant qu'administrateur le 18 mars 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mrs Julia Helen O'connor en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de HARCOURT GROUP LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O'CONNOR, Julia | Secrétaire | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | 216418430001 | |||||||
| SMITH, David Leslie | Administrateur | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | England | British | 189639980001 | |||||
| AKBAR, Shokat Ali | Secrétaire | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | 196066620001 | |||||||
| BLAKEN, Stephen Graham | Secrétaire | Glyn Terrace Blaenclydach CF40 2EG Tonypandy 4 Mid Glamorgan | British | 135666100001 | ||||||
| CANN, Andrew John | Secrétaire | Grange House Somerford Keynes GL7 6EW Cirencester Gloucestershire | British | 10621040001 | ||||||
| GENTRY, Kenneth Victor | Secrétaire | 1 The Burrows Newton CF36 5AJ Porthcawl Mid Glamorgan | British | 22290440001 | ||||||
| HARRIS, Michael James Robert | Secrétaire | 13 Culmstock Road Battersea SW11 6LZ London | British | 36974100002 | ||||||
| LOO, Helen Sork Ching | Secrétaire | 4 Hollyhock Drive Brackla CF31 2NS Bridgend Mid Glamorgan | British | 74360030001 | ||||||
| MALTHOUSE, James Leonard | Secrétaire | 46 Bowerdean Street SW6 3TW London | British | 37254960002 | ||||||
| MOSS, Nigel Adam | Secrétaire | 29 Ossulton Way Hampstead Garden Suburb N2 0DT London | British | 34044210003 | ||||||
| MURPHY, Michael Joseph | Secrétaire | The Gables Chargrove Lane Shurdington GL51 5XB Cheltenham Gloucestershire | British | 31259900002 | ||||||
| O'CONNOR, Julia Helen | Secrétaire | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | 181014280001 | |||||||
| SHAIKH, Marghub Ahmed | Secrétaire | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | 201219580001 | |||||||
| WILLIAMS, David Brian | Secrétaire | 48 Victoria Road CF64 3HY Penarth Vale Of Glamorgan | British | 6237820001 | ||||||
| BOYD, Stephen David | Administrateur | 30 Dartmoor Drive PE18 8XT Huntingdon Cambridgeshire | England | British | 11136470002 | |||||
| DOWLING, Christopher Bruce | Administrateur | 110 Home Park Road Wimbledon SW19 7HU London | United Kingdom | Australian | 28868820003 | |||||
| DOWLING, Christopher Bruce | Administrateur | Rutland House Rutland Gardens SW7 1BX Knightsbridge London | Australian | 28868820001 | ||||||
| FRANKLIN, Grant Roger | Administrateur | Perton Court Farm Cottage Pattingham Road WV6 7HD Wolverhampton | British | 4876290002 | ||||||
| FREEDMAN, Michael Anthony | Administrateur | The Old Vicarage OX5 1AG Stanton Harcourt Oxfordshire | British | 53044160001 | ||||||
| GENTRY, Kenneth Victor | Administrateur | 1 The Burrows Newton CF36 5AJ Porthcawl Mid Glamorgan | British | 22290440001 | ||||||
| HARRIS, Michael James Robert | Administrateur | 13 Culmstock Road Battersea SW11 6LZ London | United Kingdom | British | 36974100002 | |||||
| HIND, John Douglas | Administrateur | 32 Priory Gardens PE9 2EG Stamford Lincolnshire | United Kingdom | British | 68009780002 | |||||
| MALTHOUSE, James Leonard | Administrateur | 46 Bowerdean Street SW6 3TW London | England | British | 37254960002 | |||||
| MARTIN, John | Administrateur | Bourne Park Hurstbourne Tarrant SP11 0DG Andover Hampshire | British | 22730300001 | ||||||
| MORGANS, Amanda Jane | Administrateur | 24 Riverside Winchcombe GL54 5JP Cheltenham Gloucestershire | British | 42130090004 | ||||||
| MURPHY, Michael Joseph | Administrateur | The Gables Chargrove Lane Shurdington GL51 5XB Cheltenham Gloucestershire | British | 31259900002 | ||||||
| RHEAD, David Michael | Administrateur | Cherry Trees 62 Little Sutton Lane Four Oaks B75 6PE Sutton Coldfield West Midlands | British | 29783670001 | ||||||
| TAHMASEBI, Khosrow | Administrateur | The Paddocks 3 Lavender Close CR3 5DW Chaldon Common Surrey | United Kingdom | British | 38518070001 | |||||
| UNDERHILL, Peter John | Administrateur | Maes Court Knighton On Teme WR15 8LY Tenbury Wells Worcestershire | British | 17203000001 | ||||||
| YOUNG, John Alexander | Administrateur | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 England | United Kingdom | British | 213099570001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HARCOURT GROUP LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé |
|---|---|---|---|
| Mr Shabir Majid Alimahomed | 06 avr. 2016 | Brickfield Road B25 8HE Birmingham 20 | Non |
Nationalité: British Pays de résidence: United Arab Emirates | |||
Nature du contrôle
| |||
HARCOURT GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 08 mars 2002 Livré le 11 mars 2002 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 08 mars 2002 Livré le 09 mars 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture deed | Créé le 08 mars 2002 Livré le 09 mars 2002 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 28 avr. 2000 Livré le 05 mai 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All moneys due or to become due from the company (formerly known as harcourt group PLC) to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 28 janv. 2000 Livré le 02 févr. 2000 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an offer letter dated 21ST september 1998 | |
Brèves mentions Land and buildings on the south side of isfryn blackmill bridgend. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 04 juil. 1996 Livré le 09 juil. 1996 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from C.I. converters limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/as siston centre kingswood bristol also k/as land on the north east side of station road kingswood bristol avon t/no av 86250 and av 215211 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 13 déc. 1989 Livré le 02 janv. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 11 oct. 1984 Livré le 16 oct. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H 1 elliot road love lane industrial estate grencester gloucestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 16 août 1984 Livré le 21 août 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H. 12 wilkinson rd, cirencester gloucestershire. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Chattels mortgage | Créé le 17 févr. 1984 Livré le 18 févr. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All and singuler the details plant machinery & items discribed in the schedule (for full details see doc M17). | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Charge | Créé le 25 juin 1981 Livré le 03 juil. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts & other debts uncalled capital,. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0