IDENTRUST IDENTITIES LIMITED

IDENTRUST IDENTITIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéIDENTRUST IDENTITIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01526540
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dukes Court
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ASSA ABLOY MANAGEMENT SERVICES LIMITED24 oct. 200224 oct. 2002
    GRORUD INTERNATIONAL LIMITED02 févr. 198702 févr. 1987
    GRORUD INTERNATIONAL (SALES) LIMITED27 juin 198427 juin 1984
    GRORUD CODE SALES LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980
    FANBOTTLE LIMITED05 nov. 198005 nov. 1980

    Quels sont les derniers comptes de IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des détails de Assa Abloy Ab en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC05

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 13 juin 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de , 288 Bishopsgate 288 Bishopsgate, 3 Floor, London, EC2M 4QP à Dukes Court Duke Street Woking GU21 5BH le 04 avr. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr. Rodney Glass en tant qu'administrateur le 10 oct. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    2 pagesAA

    Cessation de la nomination de Anthony Michael Ball en tant que directeur le 18 juil. 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2016

    État du capital au 23 juin 2016

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Mr. Anthony Michael Ball en tant qu'administrateur le 04 mars 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Karen Jensen Wendel en tant que directeur le 19 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Nomination de Laura Crumley en tant qu'administrateur le 19 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juil. 2015

    État du capital au 23 juil. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Karen Jensen Wendel en tant qu'administrateur le 05 mars 2015

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de , Assa Abloy Ltd, School Street, Willenhall, West Midlands, WV13 3PW à Dukes Court Duke Street Woking GU21 5BH le 23 juil. 2015

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Graham Penter en tant que secrétaire le 05 mars 2015

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CRUMLEY, Laura Lynn
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    United StatesAmericanCorporate Executive205473010001
    GLASS, Rodney, Mr.
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    Administrateur
    Duke Street
    GU21 5BH Woking
    Dukes Court
    United Kingdom
    United StatesAmericanCorporate Executive214944290001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Secrétaire
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    BritishChartered Accountant57393440002
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Secrétaire
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    British1796200002
    MASON, Philip John
    32 Fallsway
    DH1 1AZ Durham
    Secrétaire
    32 Fallsway
    DH1 1AZ Durham
    BritishManager111990750002
    PENTER, Graham
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    Secrétaire
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    183815180001
    STERN, Alexander Paul
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Secrétaire
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    177777950001
    WAKEMAN, Martyn Gordon David
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    BritishExecutive73175570001
    ANGELL-HANSEN, Tor
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    Administrateur
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036160001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Administrateur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector57393440002
    BALL, Anthony Michael, Mr.
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    Administrateur
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    UsaAmericanN/A206372470001
    BRATZ, Bjor Olaf
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    Administrateur
    Gamleveign 5
    Oslo 10
    Norway
    NorwegianDirector27403290001
    BRATZ, Jens Halvard
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    Administrateur
    Grorudveign 98
    FOREIGN Oslo 10
    Norway
    NorwegianDirector8335430001
    BRATZ, Ragnvald
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    Administrateur
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    NorwegianDirector8886200001
    BROWNING, Christopher David
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Administrateur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector177705260001
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Administrateur
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    BritishFinancial Director1796200002
    JOHANSSON, Hans
    Estbrotevagen 14
    127 41 Skarholmen
    Sweden
    Administrateur
    Estbrotevagen 14
    127 41 Skarholmen
    Sweden
    SwedishExecutive99491810001
    MIDDLETON, John Linley
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Administrateur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandSouth AfricianDirector136763720002
    MONSTER, Bjorn
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    Administrateur
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    NorwegianManaging Director27380790001
    NORCOTT, Geoffrey
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    AustralianExecutice76193090001
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Administrateur
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036280001
    SANDOY, Karl Halvard
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    NorwegianManaging Director41615610001
    SASSE, Justin Andrew
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Administrateur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishOperations Director108040460001
    SODERGREN, Carl Ulf
    Bokvagen 12
    133 35 Saltsjobaden
    Sweden
    Administrateur
    Bokvagen 12
    133 35 Saltsjobaden
    Sweden
    SwedishExecutive103189740001
    VANN, Neil Arthur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Administrateur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector135687720001
    VON SYDOW, Patrik Christian
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    Administrateur
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    EnglandSwedishDirector102016580001
    WAKEMAN, Martyn Gordon David
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director73175570001
    WENDEL, Karen Jensen
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    United Kingdom
    Administrateur
    288 Bishopsgate, 3 Floor
    EC2M 4QP London
    288 Bishopsgate
    United Kingdom
    UsaUnited StatesChief Executive Officer199614690001
    WIESENFELD, Itzhak
    Units 3-4 Zk Park
    23 Commerce Way
    CR0 4ZS Croydon
    Assa Abloy Emea
    England
    England
    Administrateur
    Units 3-4 Zk Park
    23 Commerce Way
    CR0 4ZS Croydon
    Assa Abloy Emea
    England
    England
    United KingdomBritish,IsraeliExecutive113124340002
    ASSA ABLOY LIMITED
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    Administrateur
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    71976250002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur IDENTRUST IDENTITIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Assa Abloy Ab
    107 23 Stockholm
    107 23 PO BOX 7034o
    Sweden
    06 avr. 2016
    107 23 Stockholm
    107 23 PO BOX 7034o
    Sweden
    Non
    Forme juridiqueAb Public Limited Liability Company
    Pays d'enregistrementSweden
    Autorité légaleSweden
    Lieu d'enregistrementStockholm
    Numéro d'enregistrement556059-3575
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    IDENTRUST IDENTITIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental group cross guarantee indemnity and debenture
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 14 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Brèves mentions
    See form 3952 ref M148. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank As
    Transactions
    • 14 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Den norske bank as
    Créé le 27 janv. 1992
    Livré le 28 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of theother companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental debenture
    Brèves mentions
    See form 395 ref M496C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Den Norske Bank As
    Transactions
    • 28 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group cross guarantee indemnity and debenture
    Créé le 28 févr. 1991
    Livré le 08 mars 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge.
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Den Norsen Bank as London Branch.
    Transactions
    • 08 mars 1991Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee & debenture
    Créé le 16 déc. 1988
    Livré le 03 janv. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to a facility letter dated 16/12/88 and this debenture on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bergen Bank a/S
    Transactions
    • 03 janv. 1989Enregistrement d'une charge
    • 17 janv. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Guarantee and debenture
    Créé le 28 avr. 1988
    Livré le 17 mai 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from ground holdings (UK) limited to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital rights and securites.
    Personnes ayant droit
    • Bergen Bank
    Transactions
    • 17 mai 1988Enregistrement d'une charge
    Fixed and floating charge
    Créé le 07 sept. 1981
    Livré le 15 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts due owing to or incurred to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 15 sept. 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0