KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01529162 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?
Adresse du siège social | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Hampshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 07 janv. 2019
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014 | 1 pages | CH03 | ||||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2013 | 7 pages | AA | ||||||||||||||
Nomination de Mr Michael James Flowers en tant qu'administrateur le 24 juil. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLARD, Sarah Louise | Secrétaire | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | Company Secretary | 43855640011 | |||||
ELLARD, Sarah Louise | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Group Legal Director | 43855640013 | ||||
LEWIS, Andrew Gregory | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | Company Director | 222848510001 | ||||
EDGE, Geoffrey | Secrétaire | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | 2055530001 | ||||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Secrétaire | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | Company Secretary | 42841660001 | |||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Secrétaire | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Secretary | 3801050001 | |||||
BILLINGTON, Philip Gordon | Administrateur | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | Chairman | 18247670001 | |||||
BOWERS, Steven John | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Group Finance Director | 176189250001 | ||||
CLEARY, Michael John | Administrateur | 22 Main Road Naphill HP14 4QB High Wycombe Buckinghamshire | British | Director | 1525670001 | |||||
EDGE, Geoffrey | Administrateur | Spindlewood Dog Kennel Hill Kiveton Park Station S26 6NG Sheffield South Yorkshire | British | Accountant | 2055530001 | |||||
FLOWERS, Michael James | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | Company Director | 188873370002 | ||||
GIBBS, Raymond John | Administrateur | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | Finance Director & Company Sec | 85421380001 | |||||
HINCHCLIFFE, Alan | Administrateur | Manor Cottage Tapton S43 1QQ Chesterfield | England | British | Executive | 86931130002 | ||||
LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Administrateur | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | United Kingdom | British | Company Secretary | 42841660001 | ||||
MACDERMOTT, Philip | Administrateur | 179 Sternhold Avenue SW2 4PF London | British | Director | 25679470001 | |||||
PAPWORTH, Mark Harry | Administrateur | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | Chief Executive | 103085690002 | ||||
POLASHEK, Robert Alister | Administrateur | 55 Park View Road B74 4PR Sutton Coldfield West Midlands | British | Executive | 68036570001 | |||||
PRICE, David John | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 75259760004 | ||||
RAYNER, Paul Adrian | Administrateur | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 45628680002 | ||||
VINE, Sylvia Elizabeth Faith | Administrateur | Struan 65 Bell Hill GU32 2EA Petersfield Hampshire | British | Secretary | 3801050001 | |||||
WHITEHORN, Justin Michael | Administrateur | Lower Farm House Upper Milton Milton Under Wychwood OX7 6EX Chipping Norton Oxfordshire | England | British | Director | 42825970001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kembrey Electronics Limited | 30 juin 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Créé le 16 mars 1993 Livré le 31 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 16 mars 1993 Livré le 31 mars 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H land k/a woodthorpe nhouse clapgate lane quinton birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 28 janv. 1993 Livré le 29 janv. 1993 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Factory premises at clapgate lane woodthorpe house woodgate valley birmingham together with all fixtures and fittings now or at any time herafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill of the business to the bank. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed and floating charge, | Créé le 10 sept. 1992 Livré le 11 sept. 1992 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 23 déc. 1987 Livré le 24 déc. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H property k/a woodthorpe house, clapgate lane, woodgate valley, birmingham, west midlands title no wm 247670. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal charge | Créé le 20 déc. 1983 Livré le 10 janv. 1983 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold woodthorpe house, clapgate lane halesowen west midlands title no wm 247670. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental legal charge | Créé le 16 nov. 1982 Livré le 19 nov. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brèves mentions Fixed charge on the book debts and other debts present and future. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 avr. 1982 Livré le 08 avr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Freehold land floating to clapgate road, quinton, birmingham. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Guarantee & debenture | Créé le 17 févr. 1982 Livré le 23 févr. 1982 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company & and/or sirebeck limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed & floating charges undertaing and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0