KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01529162
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Roke Manor
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MEDIPLAN ENGINEERING LIMITED19 nov. 198019 nov. 1980

    Quels sont les derniers comptes de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 oct. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2019 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 07 janv. 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 18/12/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2017

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael James Flowers en tant que directeur le 30 juin 2018

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2016

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Gregory Lewis en tant qu'administrateur le 19 janv. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 01 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 03 janv. 2017

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Steven John Bowers en tant que directeur le 30 sept. 2016

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 janv. 2016

    État du capital au 27 janv. 2016

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2014

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Michael James Flowers le 13 mars 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 janv. 2015

    État du capital au 02 janv. 2015

    • Capital: GBP 20,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Sarah Louise Ellard le 09 déc. 2014

    1 pagesCH03

    Comptes pour une société dormante établis au 31 oct. 2013

    7 pagesAA

    Nomination de Mr Michael James Flowers en tant qu'administrateur le 24 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    BritishCompany Secretary43855640011
    ELLARD, Sarah Louise
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishGroup Legal Director43855640013
    LEWIS, Andrew Gregory
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United KingdomBritishCompany Director222848510001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    British2055530001
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Secrétaire
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    BritishCompany Secretary42841660001
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Secrétaire
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    BritishSecretary3801050001
    BILLINGTON, Philip Gordon
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    Administrateur
    25 Carbis Close
    Port Solent Cosham
    PO6 4TW Portsmouth
    Hampshire
    BritishChairman18247670001
    BOWERS, Steven John
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Finance Director176189250001
    CLEARY, Michael John
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    Administrateur
    22 Main Road
    Naphill
    HP14 4QB High Wycombe
    Buckinghamshire
    BritishDirector1525670001
    EDGE, Geoffrey
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Spindlewood
    Dog Kennel Hill Kiveton Park Station
    S26 6NG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishAccountant2055530001
    FLOWERS, Michael James
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0LZ Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomAustralianCompany Director188873370002
    GIBBS, Raymond John
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    Administrateur
    Bridge House
    7 Uxbridge Close
    SO31 7LP Sarisbury Soton
    Hampshire
    BritishFinance Director & Company Sec85421380001
    HINCHCLIFFE, Alan
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    Administrateur
    Manor Cottage
    Tapton
    S43 1QQ Chesterfield
    EnglandBritishExecutive86931130002
    LEIGHTON, Iain Gordon Kerr
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    Administrateur
    71 Rectory Grove
    Clapham Common
    SW4 0DS London
    United KingdomBritishCompany Secretary42841660001
    MACDERMOTT, Philip
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    Administrateur
    179 Sternhold Avenue
    SW2 4PF London
    BritishDirector25679470001
    PAPWORTH, Mark Harry
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive103085690002
    POLASHEK, Robert Alister
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    55 Park View Road
    B74 4PR Sutton Coldfield
    West Midlands
    BritishExecutive68036570001
    PRICE, David John
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive75259760004
    RAYNER, Paul Adrian
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    Administrateur
    1500 Parkway
    Whiteley
    PO15 7AF Fareham
    Chemring House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director45628680002
    VINE, Sylvia Elizabeth Faith
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    Administrateur
    Struan 65 Bell Hill
    GU32 2EA Petersfield
    Hampshire
    BritishSecretary3801050001
    WHITEHORN, Justin Michael
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    Administrateur
    Lower Farm House
    Upper Milton Milton Under Wychwood
    OX7 6EX Chipping Norton
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector42825970001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    30 juin 2016
    Old Salisbury Lane
    SO51 0ZN Romsey
    Roke Manor
    Hampshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement2244623
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    KARMA INDUSTRIES NO. 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 16 mars 1993
    Livré le 31 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 16 mars 1993
    Livré le 31 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a woodthorpe nhouse clapgate lane quinton birmingham west midlands. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 31 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 28 janv. 1993
    Livré le 29 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Factory premises at clapgate lane woodthorpe house woodgate valley birmingham together with all fixtures and fittings now or at any time herafter on the property and the benefits of all rights licences and the goodwill of the business to the bank.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge,
    Créé le 10 sept. 1992
    Livré le 11 sept. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC.
    Transactions
    • 11 sept. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 23 déc. 1987
    Livré le 24 déc. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a woodthorpe house, clapgate lane, woodgate valley, birmingham, west midlands title no wm 247670.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 24 déc. 1987Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 1983
    Livré le 10 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold woodthorpe house, clapgate lane halesowen west midlands title no wm 247670.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    Supplemental legal charge
    Créé le 16 nov. 1982
    Livré le 19 nov. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed charge on the book debts and other debts present and future.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 19 nov. 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 05 avr. 1982
    Livré le 08 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital stock-in-trade, work in progress, pre-payments stock exchange investments & cash with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. Freehold land floating to clapgate road, quinton, birmingham.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transactions
    • 08 avr. 1982Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 17 févr. 1982
    Livré le 23 févr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company & and/or sirebeck limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaing and all property and assets present and future including goodwill bookdebts & uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 23 févr. 1982Enregistrement d'une charge
    • 17 févr. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0