NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNM LIFE RESIDENTIAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01530074
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    GE LIFE RESIDENTIAL LIMITED18 oct. 199918 oct. 1999
    STALWART RESIDENTIAL LIMITED22 nov. 199422 nov. 1994

    Quels sont les derniers comptes de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Changement d'adresse du siège social de Windsor House Telford Centre Telford Shropshire TF3 4NB à 30 Finsbury Square London EC2P 2YU le 22 août 2014

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à Windsor House Telford Centre Telford TF3 4NB

    2 pagesAD02

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital29 mai 2014

    État du capital au 29 mai 2014

    • Capital: GBP 721,874
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    13 pagesAA

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Résolutions

    Resolutions
    25 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01
    capital

    Résolutions

    Auth to allot shares & duty to avoid conflicts of interest 24/06/2013
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Minimum number of directors is one 24/06/2013
    RES13

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    5 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    5 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Roger Craine en tant que directeur le 04 oct. 2010

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Michael Charles Woodcock en tant qu'administrateur le 04 oct. 2012

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 mai 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Roger Craine le 07 janv. 2010

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHAKESPEARE, Paul
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Secrétaire
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    British135096740002
    WOODCOCK, Michael Charles
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Administrateur
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    EnglandBritish102653720001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Secrétaire
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    British150997870001
    CHAMBERS, Mark Richard
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    Secrétaire
    6 Southern Road
    N2 9LE London
    British69321020002
    DUGGAN, Helen
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    Secrétaire
    115 Elms Crescent
    SW4 8QG London
    British67744330001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Secrétaire
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    HARDING, Barrington Howard
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    Secrétaire
    29 Mayford Road
    SW12 8SE London
    British11466730001
    OPPAL, Abdul Munem
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    Secrétaire
    213 Wauluds Bank Drive
    LU3 3NE Luton
    Bedfordshire
    British116338770001
    PEARSON, Michael Adrian
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    Secrétaire
    34 Lammas Gate
    ME13 7ND Faversham
    Kent
    British59751140001
    TEMPLETON, William James, Dr
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    Secrétaire
    3 Royal Crescent
    W11 4SL London
    New Zealander27024160001
    THOMAS, Derek John
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    Secrétaire
    Woodlands Chapel Lane
    SO43 7FG Lyndhurst
    Hampshire
    British2297010001
    WELCH, Gaynor Jill
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    Secrétaire
    Heronswood
    Eyhurst Close
    KT20 6NR Kingswood
    Surrey
    British87931760001
    ARTHUR, Richard
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    Administrateur
    17d Highgate West Hill
    N6 6NP London
    British71058650001
    BARRETT, Peter
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    Administrateur
    24 Britts Farm Road
    TN22 4LZ Buxted
    East Sussex
    British75515090001
    BARTLETT, John Leonard
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    Administrateur
    Chiphall Cottage Droxford Road
    Wickham
    PO17 5AZ Fareham
    Hampshire
    British14120450001
    BASARAN, Sandra Judith
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Silveroaks 101 Copsewood Way
    HA6 2TU Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish150997870001
    BOUSFIELD, Clare Jane
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritish106900580001
    CARROLL, Timothy Joseph
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkIrish63716360005
    COWDERY, Clive Adam
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    Administrateur
    38 Bradbourne Street
    SW6 3TE London
    British88183990001
    CRAINE, Roger
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    Administrateur
    Telford Centre
    TF3 4NB Telford
    Windsor House
    Shropshire
    United KingdomBritish89585440001
    DAVIES, Roger William
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    Administrateur
    The Hollies 42 High Street
    Tarring
    BN14 7NR Worthing
    West Sussex
    British21933520001
    DICKINSON, Stephen
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    Administrateur
    Chaucer Buildings
    57 Grainger Street
    NE1 5LE Newcastle Upon Tyne
    British14120430001
    DOLFI, Douglas Scott
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    Administrateur
    5 Ladbroke Walk
    W11 3PW London
    American78292660001
    DOWNEY, Paul Martin
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    Administrateur
    18 Rowan Grove
    St Ippolyts
    SG4 7SP Hitchin
    Hertfordshire
    British10360260002
    EVANS, David Thomas James
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    Administrateur
    Sandrock, Lower Street
    Fittleworth
    RH20 1JE Pulborough
    West Sussex
    United KingdomBritish62761080001
    FULLER, Michael John
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    Tudor Lodge
    Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    British14453100001
    GIRLING, Michael
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    Administrateur
    Collingwood Mount Cottage
    Loddon Close
    GU15 1LJ Camberley
    Surrey
    British63304110001
    HAMMOND, Anthony
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    Administrateur
    Berkeley Lodge
    Ashley Park Avenue
    KT12 1EU Walton On Thames
    Surrey
    British52752380001
    HAYNES, Stephen Robert
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    Administrateur
    27 West Road
    CB11 3DS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish79961770002
    HOWE, Robert William Albert
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    UkBritish13105310003
    HUGHFF, Victor William
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    18 Hilly Plantation
    NR7 0JN Norwich
    Norfolk
    British6622110001
    MCLAY, William Morrison
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    Administrateur
    26 Sheppey Walk
    BN27 3BR Hailsham
    East Sussex
    British54996780001
    MORGAN, Christopher
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    Administrateur
    13 Laurel Road
    Barnes
    SW13 0EE London
    United KingdomBritish33875890001
    NARRAWAY, Nicholas William
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Waverley Cottage Birtley Road
    Bramley
    GU5 0JA Guildford
    Surrey
    British72113010001
    RAAB, Dennis Lynn
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Glendale House
    Woodlands Ride
    SL5 9HN South Ascot
    Berkshire
    American48186120003

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 mars 1997
    Livré le 09 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 24TH march 1995
    Brèves mentions
    L/H property k/a 5 wantage road, reading berkshire; f/h property k/a 3 wantage road, reading, berkshire t/nos: BK274399 and BK26127 floating charge over the whole of the company's undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch
    Transactions
    • 09 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 mai 1996
    Livré le 30 mai 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the finance documents (including this debenture)
    Brèves mentions
    2 richard avenue brightlingsea essex including fixtures and fittings and f/h or l/h property all right title & interest in the real property the benefit of all rights and claims the insurance policies all book & other debts and a floating charge over .. undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transactions
    • 30 mai 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 1995
    Livré le 30 nov. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a 3 madeley drive west kirby wirral merseyside t/no MS155589 with all fixtures thereon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft (London Branch)
    Transactions
    • 30 nov. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 juin 1995
    Livré le 05 juil. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the terms of the finance documents (including this debenture)
    Brèves mentions
    8 wellesley court west parade worthing t/n-WSX26301. Flat 3 castle court river park marlborough wiltshire west kennett t/n-WT101180. Gathorne 24 walmers avenue higham nr rochester kent t/n-K133345.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transactions
    • 05 juil. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1995
    Livré le 06 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of the finance documents (as defined) and/or this debenture
    Brèves mentions
    The company as beneficial owner hereby charges by fixed charge in favour of the trustee with the payment and discharge of the secured obligations by way of (a) first legal mortgage over the real property; and (b) first equitable charge over its right title and interest in the real property. And by way of first floating charge the whole of the company's undertaking and assets present and future other than any assets for the time being effectively charged to the trustee by way of fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft as Agent and Trustee for Itself and the Banks (As Defined)
    Transactions
    • 06 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security account agreement
    Créé le 24 mars 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All the companys interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence od the security account agreement standing to the credit of (a) the security account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the security account agreement.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Faciltiy Agreement))
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Collection account agreement
    Créé le 24 mars 1995
    Livré le 04 avr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to and in accordance with the terms of the facility agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All the company's interest in the monies now or at any time hereafter during the subsistence of the collection account agreement standing to the credit of (a) the collection account, and (b) any account opened by the agent pursuant to clause 9 of the collection account agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Commerzbank Aktiengesellschaft, London Branch (As Agent and Trustee for Itself and on Behalf Ofthe Banks (as Defined in the Facility Agreement))
    Transactions
    • 04 avr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 avr. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage debenture
    Créé le 07 juil. 1981
    Livré le 13 juil. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold & leasehold property fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including & goodwill bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 juil. 1981Enregistrement d'une charge

    NM LIFE RESIDENTIAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 août 2014Commencement of winding up
    26 déc. 2014Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Graham White
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0