NABCREST LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | NABCREST LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01533612 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe NABCREST LIMITED ?
Adresse du siège social | 10 Victoria Road South PO5 2DA Southsea England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de NABCREST LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 oct. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour NABCREST LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 7 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 oct. 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 août 2017 au 31 oct. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 1 London Road Hindhead Surrey GU26 6AB à 10 Victoria Road South Southsea PO5 2DA le 30 nov. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Keith John Watkins en tant qu'administrateur le 05 sept. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Philip Alan Lye en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shirley Dorothy Lye en tant que directeur le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Shirley Dorothy Lye en tant que secrétaire le 30 sept. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2016 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2015 | 10 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2014 | 9 pages | AA | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2013 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2012 | 9 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2011 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 août 2010 | 6 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 30 déc. 2010 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de NABCREST LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WATKINS, Keith John | Administrateur | 1 London Road Hindhead GU26 6AB Surrey | England | English | Chartered Accountant | 54371490001 | ||||
ELIOT, George Michael | Secrétaire | Caradean Marlborough Road TW12 3RX Hampton Middlesex | British | Solicitor | 7751890001 | |||||
KING, Arthur Frederick Ernest | Secrétaire | Town Green Farm Kings Lane TW20 0UD Englefield Green Surrey | British | 23609280001 | ||||||
LYE, Shirley Dorothy | Secrétaire | Barnfield Road GU31 4DQ Petersfield 28 Hampshire | British | 47667130001 | ||||||
KING, Arthur Frederick Ernest | Administrateur | Town Green Farm Kings Lane TW20 0UD Englefield Green Surrey | British | Company Director | 23609280001 | |||||
KING, Doreen Ann | Administrateur | 12 Hollycombe TW20 0LQ Englefield Green Surrey | British | Catering Executive | 11139770003 | |||||
LYE, Philip Alan | Administrateur | 28 Barnfield Road GU31 4DQ Petersfield Hampshire | England | British | Company Director | 13674210001 | ||||
LYE, Shirley Dorothy | Administrateur | Barnfield Road GU31 4DQ Petersfield 28 Hampshire | England | British | Caterer | 47667130001 |
NABCREST LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Créé le 11 juin 2010 Livré le 01 juil. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 66 magnolia way costessey norwich t/n NK368937 any other interests in the property all rents and proceeds of any insurance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 10 déc. 1998 Livré le 11 déc. 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Sinclairs 2 corndale 138 high street cranleigh surrey and the goodwill and connection of any business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 16 mars 1998 Livré le 27 mars 1998 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions L/H property k/a 7-8 bridge street godalming surrey. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 14 mars 1995 Livré le 17 mars 1995 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H premises known as the tango cafe, high street, bordon, hants and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 13 sept. 1994 Livré le 20 sept. 1994 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/H premises 143 worplesdon road,guildford surrey and/or proceeds of sale thereof by way of assignment subject to redemption of the goodwill and connection of any business or businesses from time to time carried on in or upon the above f/h property or any part or parts thereof and the full benefit of all licences (which expression shall also include any registrations) held in connection with such business (es). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 16 août 1990 Livré le 30 août 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 83 stoke road, guildford surrey and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal mortgage | Créé le 21 déc. 1989 Livré le 11 janv. 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 147 worplesdon road guildford surrey title no:- sy 600163 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0