RANK NEMO (DMS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | RANK NEMO (DMS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01534277 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe RANK NEMO (DMS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | Tor Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Berkshire United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de RANK NEMO (DMS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour RANK NEMO (DMS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Nomination de Mr James Christopher Pizey en tant qu'administrateur le 18 août 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Clive Adrian Roynon Jennings en tant que directeur le 17 août 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Patrick O'reilly en tant qu'administrateur le 07 mai 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr John Patrick O'reilly en tant qu'administrateur le 07 mai 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Henry Benedict Birch en tant que directeur le 07 mai 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Clive Adrian Roynon Jennings le 22 mars 2018 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2017 au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Modification des détails de Rank (Dms) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 12 juin 2017 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Henry Benedict Birch le 12 juin 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire The Rank Organisation Limited le 12 juin 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Statesman House Stafferton Way Maidenhead Berkshire SL6 1AY à Tor Saint-Cloud Way Maidenhead Berkshire SL6 8BN le 12 juin 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2016 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2015 | 4 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 30 juin 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Clive Adrian Roynon Jennings le 04 juin 2014 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Nomination de Henry Benedict Birch en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Burke en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Qui sont les dirigeants de RANK NEMO (DMS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THE RANK ORGANISATION LIMITED | Secrétaire | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire England | 116576210002 | |||||||
| O'REILLY, John Patrick | Administrateur | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | England | British | 246366720001 | |||||
| O'REILLY, John Patrick | Administrateur | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor England | England | British | 246366720001 | |||||
| PIZEY, James Christopher | Administrateur | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | England | British | 249867130001 | |||||
| ADAMS, Charlotte | Secrétaire | 10 Park Way HA4 8NY Ruislip Middlesex | British | 52017000001 | ||||||
| COLES, Pamela Mary | Secrétaire | 36 London End HP9 2JH Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980002 | ||||||
| DE MIGUEL, Fiona Margaret | Secrétaire | 10 Lime Tree Walk EN2 0TJ Enfield Middlesex | British | 42996540001 | ||||||
| DUFFILL, Clare Marianne | Secrétaire | 25 Landells Road SE22 9PG London | British | 71005690005 | ||||||
| WATKINS, Simon Andrew | Secrétaire | 26 Pleasant Drive CM12 0JL London | British | 34048840002 | ||||||
| WATKINS, Simon Andrew | Secrétaire | 6 Errington Close Chadwell St Mary RM16 4TA Grays Essex | British | 34048840001 | ||||||
| BAYNES, Christopher | Administrateur | 21 Bolton Road W4 3TE London | British | 41621480001 | ||||||
| BIGGINS, Kenneth Walter | Administrateur | 34 Richmond Hill Court TW10 6BD Richmond Surrey | England | British | 46166640002 | |||||
| BIRCH, Henry Benedict | Administrateur | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire England | United Kingdom | British | 51137400001 | |||||
| BOURNE, Andrew Leigh | Administrateur | 2 College Road TW7 5DH Isleworth Middlesex | British | 6838880002 | ||||||
| BRIDGER, Michael Andrew | Administrateur | 12b Meadow View SL7 3PA Marlow Bottom Bucks | British | 78218200002 | ||||||
| BURKE, Michael Ian | Administrateur | Statesman House Stafferton Way SL6 1AY Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 148846850001 | |||||
| BURNS, Andrew Rae | Administrateur | 19 Prairie Street SW8 3PT London | British | 54722740001 | ||||||
| CLEMENT, Philip Alan | Administrateur | 1117 Vista Grande Drive 90272 Pacific Palisades California Usa | American | 36440980001 | ||||||
| COLES, Pamela Mary | Administrateur | 36 London End HP9 2JH Beaconsfield Buckinghamshire | British | 70326980002 | ||||||
| CORMICK, Charles Bruce Arthur | Administrateur | Flat 2 11 Pembridge Crescent W11 3DT London | United Kingdom | British | 17946190001 | |||||
| CORRANCE, Hugh | Administrateur | Hawthorne Cottage 47 Paynesfield Road Tatsfield TN16 2BG Westerham Kent | British | 58356230002 | ||||||
| DALY, James | Administrateur | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | British | 6823350001 | ||||||
| DAVISON, Terrence Richard | Administrateur | 14 Redwood Place HP9 1RP Beaconsfiled Bucks | South African | 101930700001 | ||||||
| GALLAGHER, Patrick James | Administrateur | Thameside RG9 2LJ Henley On Thames 22 Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 77355310003 | |||||
| GREGORY, Matthew | Administrateur | 9 Weyver Court Avenue Road AL1 3QE St Albans Herts | British | 70063900002 | ||||||
| JENNINGS, Clive Adrian Roynon | Administrateur | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 79719890002 | |||||
| PACITTI, Peter Vincent | Administrateur | 345 West Deerpath Lake Forest Illinois 60045 Usa | British | 26807300003 | ||||||
| PANKNIN, Michael | Administrateur | Hagedornstrasse 53 Hamburg 20149 FOREIGN Germany | German | 45708300002 | ||||||
| PLATT, Hamish | Administrateur | 7 St Andrews Mansions 4 Dorset Street W1U 4EQ London | United Kingdom | British | 78205840003 | |||||
| URBANO SANTIAGO, Luis | Administrateur | 26 Magnolia Dene Hazelmere HP15 7QE High Wycombe | Spanish | 68478220001 | ||||||
| VALE, Thomas | Administrateur | 2508 Dunham Woods Court St Charles Illinois 60174 Usa | American | 81257770001 | ||||||
| VANHOWE, Greg | Administrateur | 8c Gloucester Park Apartments Ashburn Place SW7 4LL London | American | 109278090001 | ||||||
| VEYS, Christopher Charles | Administrateur | Elcot Temple Way Farnham Common SL2 3HE Slough Buckinghamshire | British | 26807310002 | ||||||
| WILLIAMS, Paul Anthony | Administrateur | 191 Moss Lane HA5 3BE Pinner Middlesex | United Kingdom | British | 60121310002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur RANK NEMO (DMS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank (Dms) Limited | 06 avr. 2016 | Saint-Cloud Way SL6 8BN Maidenhead Tor United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
RANK NEMO (DMS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of charge | Créé le 14 juil. 2006 Livré le 26 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All of the chargor's right,title and interest in and to the lease surrender account and the deposit standing to the credit of the lease surrender account. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Guarantee & debenture | Créé le 25 mars 1981 Livré le 02 avr. 1981 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the comapny and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever. | |
Brèves mentions Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0