MORGAM HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMORGAM HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01536782
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MORGAM NEWS HOLDINGS LIMITED31 déc. 198031 déc. 1980

    Quels sont les derniers comptes de MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au25 févr. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    10 pagesLIQ13

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagesAD03

    Changement d'adresse du siège social de Apex Road Brownhills Walsall West Midlands WS8 7HU United Kingdom à 1 More London Place London SE1 2AF le 24 janv. 2018

    2 pagesAD01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA United Kingdom à Tesco House Shire Park Kestrel Way Welwyn Garden City AL7 1GA

    2 pagesAD02

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 05 janv. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    7 pagesLIQ01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 19 déc. 2017

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of share premium account 11/12/2017
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Cessation de la nomination de Steven Blair en tant que directeur le 08 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Robert John Welch en tant qu'administrateur le 08 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Tesco Services Limited en tant que directeur le 08 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Tracey Clements en tant que directeur le 08 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonny Mcquarrie en tant que directeur le 08 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 25 févr. 2017

    4 pagesAA

    Nomination de Jonny Mcquarrie en tant qu'administrateur le 17 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Steven Blair en tant qu'administrateur le 17 oct. 2017

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 12 oct. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Tesco Services Limited en tant qu'administrateur le 31 août 2017

    2 pagesAP02

    Nomination de Mrs Tracey Clements en tant qu'administrateur le 31 août 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Mark Benjamin Williams en tant que directeur le 22 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew Paul King en tant que directeur le 22 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Secrétaire
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    160914200001
    EVERITT, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish107529830027
    WELCH, Robert John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Administrateur
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritish212146700001
    MCAULEY, Ann
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    Secrétaire
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    British3954600002
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British1537420008
    BARTON, Tracy Jayne
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160642760001
    BLAIR, Steven
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167430001
    BRADBEER, Jeremy
    The Croft Hillcrest Cottage
    Preston Bagot Henley In Arden
    B95 5DR Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    The Croft Hillcrest Cottage
    Preston Bagot Henley In Arden
    B95 5DR Solihull
    West Midlands
    British60121580001
    BYTHEWAY, Neil Trevor
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160637140001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    CLEMENTS, Tracey
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish198102550001
    GILES, Anthony Edward
    Home Farm Cottage
    Pepper Street Inkberrow
    WR7 4EJ Worcester
    Administrateur
    Home Farm Cottage
    Pepper Street Inkberrow
    WR7 4EJ Worcester
    British3555100002
    KING, Andrew Paul
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    EnglandBritish200246970001
    LINSELL, Richard Charles
    6 Aubrey Close
    West Town
    PO11 0SU Hayling Island
    Hampshire
    Administrateur
    6 Aubrey Close
    West Town
    PO11 0SU Hayling Island
    Hampshire
    EnglandBritish1595570002
    LLOYD, Jonathan Mark
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish160028560001
    MCAULEY, Ann
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    14 Oakhall Drive
    Dorridge
    B93 8UA Solihull
    West Midlands
    British3954600002
    MCQUARRIE, Jonny
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish239167420001
    MILLS, Nigel John
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Fairfield Lodge
    Fencer Hill Park Gosforth
    NE3 2EA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish1537420008
    MOORE, Andrew William
    24 Ashwell Drive
    Shirley
    B90 3LR Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    24 Ashwell Drive
    Shirley
    B90 3LR Solihull
    West Midlands
    British78389210001
    MOORE, Martin Stephen
    Hollington Lodge
    Whitley Hill
    B95 5DL Henley In Arden
    West Midlands
    Administrateur
    Hollington Lodge
    Whitley Hill
    B95 5DL Henley In Arden
    West Midlands
    British3238160002
    MOORE, Robert Philip
    The Old Vicarage
    Lower Quinton
    CV37 8SH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Administrateur
    The Old Vicarage
    Lower Quinton
    CV37 8SH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritish3238150001
    NEVILLE-ROLFE, Lucy Jeanne, Ms.
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Delamare Road
    EN8 9SL Cheshunt
    Tesco House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish148079740001
    REED, Anthony William
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish160544960001
    SAFFERY, John Robert
    46 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    Administrateur
    46 Amesbury Road
    Moseley
    B13 8LE Birmingham
    West Midlands
    British2013700001
    STOKOE, Martin Geoffrey
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    Administrateur
    1 Exelby Close
    Whitebridge Park
    NE3 5LG Gosforth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish49671990001
    WILLIAMS, Mark Benjamin
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Administrateur
    Brownhills
    WS8 7HU Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish208244710001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Administrateur
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7600956
    175259630001
    TESCO SERVICES LIMITED
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Administrateur
    Shire Park
    Kestrel Way
    AL7 1GA Welwyn Garden City
    Tesco House
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement7600956
    175259630001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORGAM HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Brownhills
    WS8 7TS Walsall
    Apex Road
    West Midlands
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement3381179
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    MORGAM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 24 mai 2004
    Livré le 05 juin 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property k/a 52 ledwell, dickens heath, west midlands. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 05 juin 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 sept. 2003
    Livré le 19 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 16 sept. 2003
    Livré le 19 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    276 vicarage road kings heath birmingham B14 7NH title absolute t/n WM24877 (for details of further properties charged please refer to form 395). with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 19 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 févr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    • 07 avr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 janv. 2001
    Livré le 13 janv. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Girobank PLC
    Transactions
    • 13 janv. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 oct. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 sept. 1995
    Livré le 22 sept. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unis 20-24, 31 & 32 bidavon industrial estate waterloo road bidford on avon warwickshire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 août 1999Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 15 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land & buildings on the north west side of stanhope street highgate 55 stanhope street birmingham W. mids t/no wk 72766 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 09 oct. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 07 mai 1991
    Livré le 15 mai 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land on north east side of emily street 8/10 emily street birmingham west mids t/no. Wk 216186 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 15 mai 1991Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 05 déc. 1990
    Livré le 06 déc. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Freehold property k/a 128 lea village yardley, birmingham t/no wk 93736. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 06 déc. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 26 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H old property k/as land to the east of percy road birmingham west midlands title no. Wm 147167. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 24 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as 46 queen street cubbington leamington spa title no. Wk 270684. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 24 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as 5 hockley birmingham title no. Wk 64287. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 24 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as 38 kenpas highway coventry title no. Wk 98544. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 sept. 1990
    Livré le 24 sept. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold property k/as 276 vicarage road kings heath birmingham title no wm 24877. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 févr. 1990
    Livré le 01 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/as 349 warwick road, solihull, west midlands. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 févr. 1990
    Livré le 01 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/as 355 haslucks green road birmingham title number wk 228927. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 14 févr. 1990
    Livré le 01 mars 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/as 114 blenehim road, birmingham title number wm 30554. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 31 janv. 1990
    Livré le 08 févr. 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    272/274 cranmore boulevard, shirley, solihull west midlands or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1990Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 27 juil. 1982
    Livré le 05 août 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over the companys estate or interest in all f/h or l/h properties fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 août 1982Enregistrement d'une charge
    • 13 mai 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 avr. 1982
    Livré le 22 avr. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • County Bank Limited
    Transactions
    • 22 avr. 1982Enregistrement d'une charge

    MORGAM HOLDINGS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 janv. 2018Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0