SOHO GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSOHO GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01545409
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SOHO GROUP LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe SOHO GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SOHO GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOHO IMAGE GROUP LIMITED15 déc. 199215 déc. 1992
    SFV COMMUNICATIONS LIMITED08 déc. 198708 déc. 1987
    S.F.V. HOLDINGS LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    PENNYLANE LIMITED13 févr. 198113 févr. 1981

    Quels sont les derniers comptes de SOHO GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour SOHO GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pagesLIQ13

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Changement d'adresse du siège social de C/O 7Side Secretarial Limited 14 - 18 City Road Cardiff CF24 3DL à 15 Canada Square London E14 5GL le 12 févr. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 31 janv. 2018

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 25 janv. 2018

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Cancellation of the share premium account 23/01/2018
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 31 mai 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Notification de Ascent Capital Group, Inc. en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 janv. 2017

    1 pagesPSC02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 juin 2016

    État du capital au 28 juin 2016

    • Capital: GBP 2,499,999.95
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 juin 2015

    État du capital au 23 juin 2015

    • Capital: GBP 2,499,999.95
    SH01

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Latham & Watkins 99 Bishopsgate London EC2M 3XF à C/O 7Side Secretarial Limited 14-18 City Road Cardiff CF24 3DL

    1 pagesAD02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital24 juin 2014

    État du capital au 24 juin 2014

    • Capital: GBP 2,499,999.95
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    10 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de , 1 Stephen Street, London, W1T 1AT, England le 21 nov. 2012

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 mai 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de SOHO GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NILES, William
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    Administrateur
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    United StatesAmericanGeneral Cousel65159400001
    BURNETT, Robert Kenneth
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    Secrétaire
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    British23134210001
    BURNETT, Robert Kenneth
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    Secrétaire
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    British23134210001
    CREEDON, Michael John
    503 Oundle Road
    Orton Longueville
    PE2 7DQ Peterborough
    Cambridgeshire
    Secrétaire
    503 Oundle Road
    Orton Longueville
    PE2 7DQ Peterborough
    Cambridgeshire
    British71649190001
    DEWAR, Gordon Duthie
    19 Gilpin Avenue
    SW14 8QX London
    Secrétaire
    19 Gilpin Avenue
    SW14 8QX London
    BritishDirector50726160001
    EASTMAN, Emma Nicole
    Flat 3
    111 Clarendon Road
    W11 4JG London
    Secrétaire
    Flat 3
    111 Clarendon Road
    W11 4JG London
    BritishSolicitor76154110001
    HEWITT, Mark Andrew
    104a Queens Drive
    Finsbury Park
    N4 2HW London
    Secrétaire
    104a Queens Drive
    Finsbury Park
    N4 2HW London
    BritishCompany Director34542120001
    NILES, William
    34405 Pacific Coast Highway
    Malibu
    California Ca 90265
    Usa
    Secrétaire
    34405 Pacific Coast Highway
    Malibu
    California Ca 90265
    Usa
    AmericanGeneral Counsel65159400001
    PAINE, Nicholas
    47 Chaucer Road
    RG45 7QN Crowthorne
    Berks
    Secrétaire
    47 Chaucer Road
    RG45 7QN Crowthorne
    Berks
    BritishDirector32418620002
    WATSON, James Neil
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    Secrétaire
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    BritishSolicitor71254060003
    ADAMS, Raymond Dennis
    14 Sefton Paddock
    Stoke Poges
    SL2 4PT Slough
    Berkshire
    Administrateur
    14 Sefton Paddock
    Stoke Poges
    SL2 4PT Slough
    Berkshire
    BritishCompany Director9941480001
    BURNETT, Robert Kenneth
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    Administrateur
    Flat 5
    86 Addison Road
    W14 8ED London
    United KingdomBritishCompany Director23134210001
    CAMINER, John Jacob
    Chalet Lane Maisonette
    3780 Gstaad
    FOREIGN
    Switzerland
    Administrateur
    Chalet Lane Maisonette
    3780 Gstaad
    FOREIGN
    Switzerland
    AmericanCompany Director20732920001
    CLARKE, Nicholas
    The Old Manor House Church Road
    Buckworth
    PE28 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    Administrateur
    The Old Manor House Church Road
    Buckworth
    PE28 5AL Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector35102020002
    DEWAR, Gordon Duthie
    19 Gilpin Avenue
    SW14 8QX London
    Administrateur
    19 Gilpin Avenue
    SW14 8QX London
    BritishDirector50726160001
    DOWNING, Terry William
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    Administrateur
    52 Streathbourne Road
    SW17 8QX London
    EnglandBritishChief Financial Officer109287950001
    GWYN, Philip Hammond Rhys
    Dean House
    Kilmeston
    SO24 0NL Alresford
    Hampshire
    Administrateur
    Dean House
    Kilmeston
    SO24 0NL Alresford
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director30155970001
    HEWITT, Mark Andrew
    104a Queens Drive
    Finsbury Park
    N4 2HW London
    Administrateur
    104a Queens Drive
    Finsbury Park
    N4 2HW London
    United KingdomBritishCompany Director34542120001
    HUSAIN, Saleem
    60 Raleigh Drive
    N20 0UU London
    Administrateur
    60 Raleigh Drive
    N20 0UU London
    EnglandBritishManaging Director21881910002
    PAINE, Nicholas
    47 Chaucer Road
    RG45 7QN Crowthorne
    Berks
    Administrateur
    47 Chaucer Road
    RG45 7QN Crowthorne
    Berks
    EnglandBritishDirector32418620002
    PLATISA, George Charles
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    Administrateur
    Stephen Street
    W1T 1AT London
    1
    England
    United StatesAmericanCfo135566630001
    WALSTON, Robert Thomas
    9010 Briarcrest Lane
    Beverly Hills
    Ca 90210
    Usa
    Administrateur
    9010 Briarcrest Lane
    Beverly Hills
    Ca 90210
    Usa
    UsaAmericanCompany Director116636570001
    WILLIAMS, Keith
    30 Church Road
    Earley
    RG6 1HS Reading
    Berkshire
    Administrateur
    30 Church Road
    Earley
    RG6 1HS Reading
    Berkshire
    BritishCompany Director52115140001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur SOHO GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ascent Capital Group, Inc.
    5251 Dtc Parkway
    Suite 1000
    80111
    Greenwood Village
    5251 Dtc Parkway
    Co
    United States
    01 janv. 2017
    5251 Dtc Parkway
    Suite 1000
    80111
    Greenwood Village
    5251 Dtc Parkway
    Co
    United States
    Non
    Forme juridiqueUs Corporation
    Autorité légaleState Of Delaware Corporation Laws
    Nature du contrôle
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    SOHO GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 sept. 1996
    Livré le 19 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Spread Trustee Company Limited
    Transactions
    • 19 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 août 1995
    Livré le 30 août 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company (formerly known as soho image group limited) to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Spread Trustee Company Limited
    Transactions
    • 30 août 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 11 mai 1994
    Livré le 13 mai 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to spread trustee company limited (as trustee for the stockholders under the trust deed) oursuant to the trust deed dated 21 march 1994
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Spread Truste Company Limited
    Transactions
    • 13 mai 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 20 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Building contract dated 3 december 1991 made between the company (1) and overbury and sons limited (2).
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 14 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Project management agreement and conditions of engagement dated 9/9/91 made between the company and silk and frazier bridgeman.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 31 déc. 1993
    Livré le 14 janv. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Building contract dated 11/2/92 mad between the company and phoenix electrical company limited.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 janv. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 29 juil. 1993
    Livré le 30 juil. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Soho 601 Digital Productions Limited
    Transactions
    • 30 juil. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 02 juin 1993
    Livré le 05 juin 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Philip Hammond Rhys Gwyn
    Transactions
    • 05 juin 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 janv. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 mars 1993
    Livré le 11 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Spread Trustee Company Limited(As Trustee for the Stockholders Under the Trust Deed Dated 22/10/92)
    Transactions
    • 11 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 1992
    Livré le 28 janv. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 28 janv. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 déc. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 mars 1985
    Livré le 22 mars 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and proceeds of sale thereof fixed & floating chare over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 1985Enregistrement d'une charge
    • 12 sept. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 31 mars 1981
    Livré le 08 avr. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 avr. 1981Enregistrement d'une charge

    SOHO GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    31 janv. 2018Commencement of winding up
    24 oct. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0