MISYS KBS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéMISYS KBS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01545543
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de MISYS KBS LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication

    Où se situe MISYS KBS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    One Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de MISYS KBS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    KINDLE BANKING SYSTEMS LIMITED17 oct. 199517 oct. 1995
    ACT BANKING SYSTEMS (U.K.) LIMITED14 avr. 199414 avr. 1994
    ACT KINDLE (U.K.) LIMITED04 juin 199204 juin 1992
    KINDLE LIMITED29 nov. 198529 nov. 1985
    TRIPLE A SYSTEMS LIMITED25 avr. 198325 avr. 1983
    M.A. SOFTWARE LIMITED17 mars 198217 mars 1982
    M.A. SYSTEMS (LONDON) LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    PEACEPAR LIMITED13 févr. 198113 févr. 1981

    Quels sont les derniers comptes de MISYS KBS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour MISYS KBS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mai 2016

    28 pages4.68

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mai 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital23 janv. 2015

    État du capital au 23 janv. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Andrew Paul Woodward en tant qu'administrateur le 05 sept. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Sanjay Patel en tant que directeur le 28 août 2014

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr John Van Harken en tant qu'administrateur le 31 juil. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Elizabeth Mary Collins en tant que directeur le 31 juil. 2014

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 févr. 2014

    État du capital au 06 févr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes établis au 31 mai 2013

    12 pagesAA

    Nomination de Mrs Elizabeth Mary Collins en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Director Limited en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Joanna Hawkes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Misys Corporate Secretary Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Sanjay Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Joanna Marageret Hawkes en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Bijal Patel en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Thomas Edward Timothy Homer le 20 mai 2013

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 janv. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes établis au 31 mai 2012

    12 pagesAA

    Nomination de Mr Bijal Mahendra Patel en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de MISYS KBS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HARKEN, John Van
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomAmerican183654340001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    WOODWARD, Andrew Paul
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish100885620001
    BRAIN, Sarah Elizabeth Highton
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    Secrétaire
    Portwood Cottage
    The Street Warninglid Haywards Heath
    RH17 5SZ West Sussex
    No 1
    England
    England
    146638700001
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secrétaire
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secrétaire
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secrétaire
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secrétaire
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secrétaire
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    WILSON, Kevin Michael
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Secrétaire
    Strauss Road
    Chiswick
    W4 1DL London
    10
    Other138835080001
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Secrétaire
    Kingdom Street
    Paddington
    W2 6BL London
    One
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement07036299
    170449080001
    CLANCY, Conall Patrick
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    3 Homelee
    IRISH Ballsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish37703500001
    COLLINS, Elizabeth Mary
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish180406780001
    COLWELL, John
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    Administrateur
    37 Linden Grove
    KT12 1EY Walton-On-Thames
    Surrey
    British98195430003
    DERRER, Andrew Jan
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    Administrateur
    South Lodge
    Caversfield
    OX27 8TH Bicester
    Oxon
    EnglandBritish121601200001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Administrateur
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish75357260001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Administrateur
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAWKES, Joanna Marageret
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    EnglandBritish136214800001
    HUGHES, Kevin Gerard
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    Administrateur
    31 Cromwell Avenue
    Billericay
    CM12 OAG Essex
    United KingdomBritish173214140001
    KILDUFF, Martin Anthony
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    21 Ailesbury Drive
    Bailsbridge
    Dublin 4
    Ireland
    Irish32778090001
    MEANY, Patrick Declan
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Administrateur
    23 Calderwood Road
    Drumcondra
    Dublin 9
    Ireland
    Irish82121570001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NAGLE, Kieran Matthew
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Administrateur
    Rustic Lodge
    Carrick Hill
    Portmarnock
    Co Dublin
    Ireland
    Irish43947240001
    NOCTOR, Desmond James
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    37 Bourne Avenue
    SL4 3JP Windsor
    Berkshire
    Irish32778100001
    PATEL, Bijal Mahendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish161424380001
    PATEL, Sanjay Surendra
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    United KingdomBritish147221810001
    STOKES, Mark
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Administrateur
    28 Gilford Park
    Sandymount
    Dublin 4
    Ireland
    Ireland
    Irish82121580001
    SUSSENS, John Gilbert
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    Administrateur
    Blythe House 10 Grange Road
    Bidford On Avon
    B50 4BY Alcester
    Warwickshire
    EnglandBritish1442450002
    SUSSENS, John Gilbert
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    25 Jordan Road
    B75 5AB Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1442450001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Administrateur
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Administrateur
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement04217573
    158141250001

    MISYS KBS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off (olso) dated 3RD july 1995
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995
    Créé le 17 sept. 2003
    Livré le 01 oct. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3 july 1995
    Créé le 11 sept. 2003
    Livré le 24 sept. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 24 sept. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995 and
    Créé le 29 juil. 2003
    Livré le 12 août 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 12 août 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set off dated 3RD july 1995 (the letter)
    Créé le 23 oct. 2002
    Livré le 13 nov. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 3RD july 1995
    Créé le 09 mai 2002
    Livré le 25 mai 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 25 mai 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 23 janv. 1987
    Livré le 28 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All the company's book debts and other receivables present and future.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 28 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 nov. 1986
    Livré le 18 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transactions
    • 18 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of collateral debenture
    Créé le 26 mai 1986
    Livré le 16 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from kindle group limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    By way of floating security all the company's undertaking and assets present and future including uncalled capital for the time being & goodwill.
    Personnes ayant droit
    • Industrial Credit Corporation PLC
    Transactions
    • 16 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of chattel mortgage
    Créé le 26 mai 1986
    Livré le 16 juin 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    First fixed charge on all the property & assets listed in doc M29. (See doc M29 for details).
    Personnes ayant droit
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transactions
    • 16 juin 1986Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 19 juin 1985
    Livré le 03 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the M. A. bereau services LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoerver both present and future including its uncalled capital for the time being and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral debenture
    Créé le 19 juin 1985
    Livré le 03 juil. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the M. A. systems LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    All the borrower's undertaking and assets wheresoever and whatsoever both present and future including its uncalled capital fot the time being and goodwill.
    Personnes ayant droit
    • The Industrial Credit Corporation PLC
    Transactions
    • 03 juil. 1985Enregistrement d'une charge
    • 05 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    MISYS KBS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 oct. 2017Dissolved on
    27 mai 2015Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Hugh Francis Jesseman
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London
    practitioner
    3 Field Court
    Grays Inn
    WC1R 5EF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0