UBS REORGANISATION 2021-03 LTD

UBS REORGANISATION 2021-03 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUBS REORGANISATION 2021-03 LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01546399
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    • Activités de négociation de valeurs mobilières et de contrats sur marchandises (66120) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Adresse du siège social
    5 Broadgate
    EC2M 2QS London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    UBS (2003) LIMITED14 févr. 200314 févr. 2003
    UBS LIMITED05 avr. 199305 avr. 1993
    UBS PHILLIPS & DREW SECURITIES LIMITED01 avr. 198901 avr. 1989
    PHILLIPS & DREW SECURITIES LIMITED22 oct. 198622 oct. 1986
    PHILLIPS & DREW (NUMBER 1) LIMITED17 juin 198517 juin 1985
    PHILLIPS & DREW LIMITED19 févr. 198119 févr. 1981

    Quels sont les derniers comptes de UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 06 déc. 2022

    7 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 07 déc. 2021

    LRESSP

    Statuts

    23 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    État du capital au 19 nov. 2021

    • Capital: GBP 75,000
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesSH20

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re-deed/co business 12/10/2021
    RES13

    Certificat de changement de nom

    Company name changed ubs (2003) LIMITED\certificate issued on 13/10/21
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name13 oct. 2021

    Changement de nom" par résolution

    NM01
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Cessation de la nomination de John Quarmby en tant que directeur le 13 oct. 2021

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2020

    15 pagesAA

    Nomination de Mr Simon Robert Sedgwick en tant qu'administrateur le 01 sept. 2021

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Ian David Marriott en tant que directeur le 31 août 2021

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Barbara Maria Ginet-Kuncewicz en tant que directeur le 03 déc. 2020

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 08 avr. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Matthew James Cartledge en tant que directeur le 08 avr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Ms Fiona Mckinnon en tant qu'administrateur le 07 avr. 2020

    2 pagesAP01

    Nomination de Barbara Maria Ginet-Kuncewicz en tant qu'administrateur le 11 sept. 2019

    3 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHARLES, Harriet Helen Lucinda
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Secrétaire
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    British105737320001
    MCKINNON, Fiona
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish,AustralianAccountant268771580001
    SEDGWICK, Simon Robert
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    EnglandBritishBusiness Manager286841070001
    HARE, Paul Edward
    39 Cloudesley Road
    Barnsbury Islington
    N1 0EL London
    Secrétaire
    39 Cloudesley Road
    Barnsbury Islington
    N1 0EL London
    British23220350004
    MITCHELL HEWSON, John Stuart
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Secrétaire
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    British96354470001
    BAINES, John Duncan
    12 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    12 Hillside Road
    WD7 7BH Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishChartered Accountant55571330005
    BENNETT, Peter Richard
    The Penthouse The Mansion
    Ottershaw Park
    KT16 0QG Chertsey
    Surrey
    Administrateur
    The Penthouse The Mansion
    Ottershaw Park
    KT16 0QG Chertsey
    Surrey
    EnglandBritishHead Of Logistics75171330001
    BLUNDELL, Richard Charles
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    BritishCorporate Tax Accountant103383810001
    BOLIN, Michael Patrick
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    American BritishInvestment Banker112859170001
    BRIANCE, Richard Henry
    The Old House 13 Holland Street
    W8 4NA London
    Administrateur
    The Old House 13 Holland Street
    W8 4NA London
    EnglandBritishVice Chairman Debt Division16636440001
    BRISBY, Stephen James Michael
    20 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    Administrateur
    20 Thurloe Square
    SW7 2SD London
    EnglandBritishVice Chairmanate Finance Divis141686170001
    BURBEDGE, Matthew Ian
    Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritishInvestment Banker115638810001
    CARTLEDGE, Matthew James
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant219376970001
    DALBY, John Steven
    25 Peel Street
    W8 7PA London
    Administrateur
    25 Peel Street
    W8 7PA London
    BritishManaging Director Equities Trading10179530002
    DAY, Eileen Mary
    Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    100
    United Kingdom
    UkBritishAccountant125838730001
    EMLEY, Miles Lovelace Brereton
    Whitehall House
    Ashford Hill
    RG19 8AZ Thatcham
    Berkshire
    Administrateur
    Whitehall House
    Ashford Hill
    RG19 8AZ Thatcham
    Berkshire
    United KingdomBritishManaging Director Uk Corporate Finance56771700001
    EYNON, Richard Mark
    Crest House Shoppenhangers Road
    SL6 2QA Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    Crest House Shoppenhangers Road
    SL6 2QA Maidenhead
    Berkshire
    United KingdomBritishInvestment Banker12687130001
    FINEGOLD, Warren Alan
    13 Willow Road
    NW3 1TJ London
    Administrateur
    13 Willow Road
    NW3 1TJ London
    BritishManaging Director Uk Corp Fina53920770001
    GIANNOTTI, John Bernard
    19 Roebuck Heights
    North End
    IG9 5RF Buckhurst Hill
    Essex
    Administrateur
    19 Roebuck Heights
    North End
    IG9 5RF Buckhurst Hill
    Essex
    United KingdomBritishEuropean Head Of Fixed Income114242680001
    GILLESPIE, Joseph Andrew Robert
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    BritishInvestment Banker98985020001
    GINET-KUNCEWICZ, Barbara Maria
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasurer262783280001
    GOLDBAND, Craig Alan
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    Administrateur
    Broadgate
    EC2M 2QS London
    5
    United Kingdom
    United KingdomAmericanFinancial Analyst224291710001
    GOLDMUNTZ, David
    18 The Little Boltons
    SW10 9LP London
    Administrateur
    18 The Little Boltons
    SW10 9LP London
    AmericanVice Chairman Head Of Sales &56292900001
    HAEMMERLI, Anna Marie Ingeborg
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    United KingdomSwissInvestment Banker125222730001
    HARDIE, Richard William John
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    EnglandBritishInvestment Banker59312650003
    HARDING, Mark Dominic
    Scotts Lodge Main Road
    Knockholt
    TN14 7NX Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Scotts Lodge Main Road
    Knockholt
    TN14 7NX Sevenoaks
    Kent
    BritishGeneral Counsel And Svp56561190001
    HARDING, Robert Lawrence
    The Pines 21 Fairmile Avenue
    KT11 2JA Cobham
    Surrey
    Administrateur
    The Pines 21 Fairmile Avenue
    KT11 2JA Cobham
    Surrey
    AmericanDebt Division Managing Directo39496680002
    HARNIK, Peter Louis
    2 Frank Dixon Close
    SE21 7BD London
    Administrateur
    2 Frank Dixon Close
    SE21 7BD London
    AmericanInvestment Banker64138480001
    HELMER, Gavin Romald Helmerow
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    BritishTax Consultant104052400001
    HUSSEY, Simon James
    27 Hollywood Road
    SW10 9HT London
    Administrateur
    27 Hollywood Road
    SW10 9HT London
    EnglandIrishExecutive Director Ubs Princ51647340003
    JAMES, Sally Ann
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    Administrateur
    100 Liverpool Street
    EC2M 2RH London
    United KingdomBritishEuropean General Counsel62168050004
    KERRISON, Michael Arthur
    Beechbank
    Mount Park Avenue
    HA1 3JN Harrow On The Hill
    Middlesex
    Administrateur
    Beechbank
    Mount Park Avenue
    HA1 3JN Harrow On The Hill
    Middlesex
    United KingdomBritishDirector75385960001
    KRESPI, Kevin
    46 Chelsea Square
    SW3 6LH London
    Administrateur
    46 Chelsea Square
    SW3 6LH London
    BritishHead Of Marketing141415860001
    LE MAY, Malcolm John
    Upham House
    SO32 1JH Upham
    Hampshire
    Administrateur
    Upham House
    SO32 1JH Upham
    Hampshire
    United KingdomBritishHeaed Of Corporate Finance43422720003
    LIM, Thiam Joo
    27 Flood Street
    SW3 5ST London
    Administrateur
    27 Flood Street
    SW3 5ST London
    MalaysianMd Global Head Of Currencies59439830001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur UBS REORGANISATION 2021-03 LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ubs Group Ag
    Bahnhofstrasse 45
    Zurich
    8001
    Switzerland
    06 avr. 2016
    Bahnhofstrasse 45
    Zurich
    8001
    Switzerland
    Non
    Forme juridiqueCorporation Limited By Shares
    Pays d'enregistrementSwitzerland
    Autorité légaleSwiss
    Lieu d'enregistrementCommercial Registrey Office Of The Canton Of Zurich
    Numéro d'enregistrementChe-395.345.924
    Rechercher dans le registre du commerce suisse (Zefix)Ubs Group Ag
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    UBS REORGANISATION 2021-03 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security deed
    Créé le 07 nov. 1997
    Livré le 22 nov. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges all sums and payments in respect of any transfer or debit or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account in the cgo service or any transfer of any right title or interest to and in stock represented by any credit balance on any such eligible stock acount and all right title and interest to an in all monies standing to the credit of the controlled accounts together with all rights relating thereto. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 22 nov. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Supplemental deed
    Créé le 29 sept. 1997
    Livré le 10 oct. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever arising out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as more particularly described in the security deed)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all sums, eligible stock, property rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 10 oct. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 11 sept. 1997
    Livré le 25 sept. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever arising out of or in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed charge all sums receivable in respect of any transfer or debit stock from eligible stock account referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of its interst in and to stock represented by any credit balance on any such eligible account and a floating charge all stock property sums due and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 25 sept. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 16 juil. 1997
    Livré le 04 août 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the provision of crest settlement bank facilities (as more particularly described in the security deed)
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge (a) all sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit or any agreement to transfer or debit stock from any eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the company in crest or any transfer by the company of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account together with all rights and interest in such sums and payaments;. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 août 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security deed
    Créé le 20 sept. 1996
    Livré le 03 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or the crest member to the chargee under or in connection with the provisions of crest settlement bank facilities (as more particularly described in the security deed)
    Brèves mentions
    All sums and payments on the date of the security deed and from time to time thereafter receivable by or for the account of the company by reason or in respect of any transfer or debit of, or any agreement to transfer or debit stock from eligible stock account of or in the name of or otherwise referable to the crest member in crest or any transfer by the company or the crest member of any of its right title or interest to and in stock represented or to be represented by any credit balance on any such eligible account together with all rights and interest in such sums and payments.. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed of charge
    Créé le 13 déc. 1995
    Livré le 30 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the facility agreement dated 13TH december 1995
    Brèves mentions
    All sums from time to time receivable by the company in respect of any transfer or debit of stock first floating charge all right title & interest to & in the stock and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 30 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Custody agreement
    Créé le 27 juin 1995
    Livré le 30 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee in connection with the custody agreement
    Brèves mentions
    All cash from time to time in the cash account described in clause 5 of the custody agreement abd all shares stocks bonds notes debenture or ther securities held from time to time for the account of ubs limited.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 30 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Securities clearing agreement
    Créé le 14 juin 1995
    Livré le 30 juin 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The repayment of loans and all interest thereon and all other amounts due or to become due form the company to the chargee under the agreement together with all expenses
    Brèves mentions
    Any and all definitive and depository securities which may be held in the account and in any and all cash balances deposited in the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Bank of New York
    Transactions
    • 30 juin 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 févr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of charge and assignment
    Créé le 10 févr. 1994
    Livré le 26 févr. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the ap facility agreement or this deed
    Brèves mentions
    All charges as defined on the deed of charge and assignment. The company by way of security for the discharge of the secured amounts,as beneficial owner hereby transfers and assigns to the bank all the company's present and future rights,title and interest and benefits under or pursuant to the eso membership agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Union Bank of Switzerland
    Transactions
    • 26 févr. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 25 mars 1993
    Livré le 30 mars 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due under the charge
    Brèves mentions
    All shares, stocks and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transactions
    • 30 mars 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Custody agreement
    Créé le 06 janv. 1993
    Livré le 20 janv. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this custody agreement (as defined)
    Brèves mentions
    All cash from time to time in the cash account and all shares,stocks,bonds,notes.....etc. See form 395.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 20 janv. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral agreement
    Créé le 04 oct. 1988
    Livré le 20 oct. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The securities callateral being all of the borrower's right title and in terest the cash callateral the pledged recovery rights all other callateral (please see form 395 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 20 oct. 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of guarantee
    Créé le 13 avr. 1988
    Livré le 27 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the letter of guarantee
    Brèves mentions
    All amounts (whether consisting of cash, secuirities or other property) delivered and pledgen (whether now or at any time in the future) to citibank N.A. by the company pursuant to the letter of guarantee.
    Personnes ayant droit
    • Citibank N.A.
    Transactions
    • 27 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    • 05 sept. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed
    Créé le 07 janv. 1988
    Livré le 20 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge over all sums deposited by the company or for the compay's account with the morgan guaranty trust company's of new york.(see doc.for full details).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guarantee Trust Company of New York.
    Transactions
    • 20 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Security agreement
    Créé le 07 janv. 1988
    Livré le 20 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    American deposit receipts (for details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guarnty Trust Company of New York.
    Transactions
    • 20 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    • 25 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Collateral agreement
    Créé le 05 janv. 1988
    Livré le 18 janv. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys due or to become due from the company to the charges under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All "collateral" as defined in the agreement.
    Personnes ayant droit
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York
    Transactions
    • 18 janv. 1988Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 27 oct. 1986
    Livré le 05 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    All shares, stock and other securities of any description which are for the time being designated by the stock exchange as talisman securities (please see document for dull details).
    Personnes ayant droit
    • The International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland Limited
    Transactions
    • 05 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 23 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    UBS REORGANISATION 2021-03 LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    07 déc. 2021Commencement of winding up
    16 avr. 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0