JUPITERIMAGES (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJUPITERIMAGES (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01554847
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    • Activités photographiques n.c.a. (74209) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DYNAMIC GRAPHICS (U.K.) LIMITED 31 déc. 198131 déc. 1981
    CLIP ART (U.K.) LIMITED06 avr. 198106 avr. 1981

    Quels sont les derniers comptes de JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 18 sept. 2019

    11 pagesLIQ03

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 101 Bayham Street London NW1 0AG à 55 Baker Street London W1U 7EU le 29 nov. 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 18 oct. 2018

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2017 au 31 mars 2018

    3 pagesAA01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 16 janv. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    21 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 mars 2016

    État du capital au 22 mars 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de John Joseph Lapham en tant que directeur le 04 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    15 pagesAA

    Cessation de la nomination de Tim Murphy en tant que directeur le 05 juin 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 mars 2015

    État du capital au 06 mars 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    17 pagesAA

    Nomination de Mr Tim Murphy en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Chris Hoel en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Shane Johnson en tant qu'administrateur le 31 mars 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Constance G. Chapman en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Jodi Anne Colligan en tant que directeur le 31 mars 2014

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAPMAN, Constance G.
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave. S.
    United States
    Secrétaire
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave. S.
    United States
    186275610001
    HOEL, Chris
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    Administrateur
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    United StatesAmericanVp, Finance190229180001
    JOHNSON, Shane
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    Administrateur
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    United StatesAmericanVp, Tax190333070001
    LOCKWOOD, Jonathan Simon
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Administrateur
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritishSolicitor106676380005
    BAILEY, Beatrice
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Secrétaire
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    British137128400001
    LANDISMAN, Mark
    99 Wilson Place
    Plainview
    New York
    11803
    Usa
    Secrétaire
    99 Wilson Place
    Plainview
    New York
    11803
    Usa
    Us CitizenPrivate Investor74137380001
    LANE, Mary Theresa Ted
    6000 N Forest Park Drive
    FOREIGN Peoria
    Illinois 61614
    Usa
    Secrétaire
    6000 N Forest Park Drive
    FOREIGN Peoria
    Illinois 61614
    Usa
    British24949710001
    MARGESSON, Francesca Heather
    Cherry Trees Woodhill Road
    Sandon
    CM2 7SE Chelmsford
    Essex
    Secrétaire
    Cherry Trees Woodhill Road
    Sandon
    CM2 7SE Chelmsford
    Essex
    British23051800001
    MOFFLY, David
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    Secrétaire
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    AmericanExecutive74137450001
    O'NEIL, Dwyer
    5 Finch Drive
    Springwood
    CM7 2SF Braintree
    Secrétaire
    5 Finch Drive
    Springwood
    CM7 2SF Braintree
    BritishManaging Director96382980002
    OLSWANG COSEC LIMITED
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    Secrétaire
    90 High Holborn
    WC1V 6XX London
    Seventh Floor
    83864780002
    BARTEL, Milton Homer
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria Il 61614-3592
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria Il 61614-3592
    FOREIGN
    Usa
    AmericanDirector23051810001
    CARDELL, Christoher
    155 Hilltop Circle
    Trumbull
    Connecticut 06611
    Usa
    Administrateur
    155 Hilltop Circle
    Trumbull
    Connecticut 06611
    Usa
    AmericanDirector119385360001
    COLLIGAN, Jodi Anne
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    UsaAmericanCpa147041000001
    DIETRICH, Dennis
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria K
    61614-3592
    Usa
    Administrateur
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria K
    61614-3592
    Usa
    AmericanFinancial Officer94987160002
    DUNN, Jeffrey Joseph
    Ne 94th Street
    WA 98115 Seattle
    2347
    United States Of America
    Administrateur
    Ne 94th Street
    WA 98115 Seattle
    2347
    United States Of America
    UsaUnited StatesVp Finance And Controller130086340003
    GOSLING, Andrea Lyn
    23 Mill Park Drive
    CM7 1XA Braintree
    Essex
    Administrateur
    23 Mill Park Drive
    CM7 1XA Braintree
    Essex
    BritishFinancial Controller104080090001
    HAMMI, Karima
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    Administrateur
    Bayham Street
    NW1 0AG London
    101
    United Kingdom
    EnglandFrenchLawyer119582770001
    KIM, Haeran
    c/o Getty Images, Inc
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    UsaSouth KoreanTax Director151620780001
    LANDISMAN, Mark
    99 Wilson Place
    Plainview
    New York
    11803
    Usa
    Administrateur
    99 Wilson Place
    Plainview
    New York
    11803
    Usa
    Us CitizenPrivate Investor74137380001
    LAPHAM, John Joseph
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    5th Ave S
    98104 Seattle
    605
    Washington
    Usa
    UsaAmericanLawyer174530250001
    LOWRY, Bruce
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    Administrateur
    c/o Getty Images, Inc.
    North 34th Street
    WA 98103 Seattle
    601
    Usa
    UsaAmericanAttorney146410800001
    MECKLER, Alan Marshal
    435 East 52nd Street Apt 16c2
    New York
    10022
    America
    Administrateur
    435 East 52nd Street Apt 16c2
    New York
    10022
    America
    AmericanDirector74676550003
    MOFFLY, David
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    Administrateur
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    AmericanPrivate Investor74137450001
    MOFFLY, David
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    Administrateur
    36 West 10th Street
    New York
    10011
    Usa
    AmericanPrivate Investor74137450001
    MUELLER, Jayne Michelle
    6000 N Forest Park Drive
    Peoria
    Illinois 61614
    Usa
    Administrateur
    6000 N Forest Park Drive
    Peoria
    Illinois 61614
    Usa
    UsaPresident32194010001
    MURPHY, Tim
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    Administrateur
    Suite 400
    WA 98104 Seattle
    605 5th Ave S.
    Usa
    UsaUnited StatesVp, Finance190229440001
    RUSH, John Louis
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria Il 61614-3592
    FOREIGN
    Usa
    Administrateur
    6000 North Forest Park Drive
    Peoria Il 61614-3592
    FOREIGN
    Usa
    AmericanDirector23051820001
    SCHWIMMER, Barry
    16 Cranbury Road
    Connecticut
    06880
    Usa
    Administrateur
    16 Cranbury Road
    Connecticut
    06880
    Usa
    Us CitizenPrivate Investor74137510001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour JUPITERIMAGES (UK) LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    16 janv. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    JUPITERIMAGES (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Rent deposit deed
    Créé le 04 juin 2007
    Livré le 07 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the monies to the credit of the account. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Crown Estate Commissioners
    Transactions
    • 07 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 janv. 2007
    Livré le 26 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in all the monies to the credit of the account including all interest accruing thereto.
    Personnes ayant droit
    • The Crown Estate Commissioners
    Transactions
    • 26 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 22 janv. 2004
    Livré le 10 févr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mcg Capital Corporation
    Transactions
    • 10 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 mars 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 29 mars 1985
    Livré le 09 avr. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any moneys now or hereafter standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC & all interest of the company therein & all interest now due or henceforth to become due in respect thereof.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1985Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage
    Créé le 17 mai 1983
    Livré le 21 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any monies standing to the credit of a designated account with lloyds bank PLC assignated lloyd bank PLC re dynamic graphics (UK) limited and numbered 7087830 and all interest of the company therein.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 mai 1983Enregistrement d'une charge
    • 03 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    JUPITERIMAGES (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 oct. 2018Commencement of winding up
    27 déc. 2019Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Edward Terence Kerr
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    practitioner
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0