BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED

BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01559593
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    • Autres activités de recherche-développement en sciences naturelles et en ingénierie (72190) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RISTON LIMITED05 mai 198105 mai 1981

    Quels sont les derniers comptes de BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2022

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2021

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 26 mars 2020

    11 pagesLIQ03

    Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD03

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de , 3rd Floor, 1 Ashley Road, Altrincham, Cheshire, WA14 2DT à 1 Bridgewater Place Water Lane Leeds West Yorkshire LS11 5QR le 23 avr. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 27 mars 2019

    LRESSP

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 25 mars 2019

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    État du capital après une attribution d'actions au 22 mars 2019

    • Capital: GBP 364,120
    3 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    32 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    État du capital après une attribution d'actions au 14 nov. 2018

    • Capital: GBP 320,100
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2017 au 30 juin 2018

    1 pagesAA01

    Notification de Ge Infrastructure Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 avr. 2016

    2 pagesPSC02

    Retrait d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif le 04 janv. 2018

    2 pagesPSC09

    Déclaration de confirmation établie le 06 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Jeff Wyatt en tant qu'administrateur le 30 juin 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement7038430
    146358090001
    GROULX, Bryan
    1 River Road
    12345 Schenectady
    Building 66
    New York
    United States
    Administrateur
    1 River Road
    12345 Schenectady
    Building 66
    New York
    United States
    United StatesAmerican195023200001
    WYATT, Jeff
    1 Research Circle
    12309 Niskayuna
    Ge Global Research Center
    New York
    United States
    Administrateur
    1 Research Circle
    12309 Niskayuna
    Ge Global Research Center
    New York
    United States
    United StatesAmerican234760430001
    CAUNT, Stephen John
    39 Hillingdon Avenue
    Nuthall
    NG16 1RA Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    39 Hillingdon Avenue
    Nuthall
    NG16 1RA Nottingham
    Nottinghamshire
    British97428090001
    KNAUFF, Pierre Marie Charles Jean
    Hoden Farm Hoden Lane
    Cleeve Prior
    WR11 8LH Evesham
    Secrétaire
    Hoden Farm Hoden Lane
    Cleeve Prior
    WR11 8LH Evesham
    British87761560001
    PACE BONELLO, Alexander Francis
    74 The Common
    Quarndon
    DE22 5JY Derby
    Derbyshire
    Secrétaire
    74 The Common
    Quarndon
    DE22 5JY Derby
    Derbyshire
    British19919940001
    WILKINSON, Geoffrey Allan
    18 The Findings
    GU14 9EG Farnborough
    Hampshire
    Secrétaire
    18 The Findings
    GU14 9EG Farnborough
    Hampshire
    British11118390001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    AVILES GUERRERO, Andres Luis
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomSpanish171255380001
    BARROW, Peter
    16 Colwell Drive
    Boulton Moor
    DE24 5AB Derby
    Administrateur
    16 Colwell Drive
    Boulton Moor
    DE24 5AB Derby
    British37031660002
    BROWN, Herbert Moorcroft
    26 Westminster Avenue
    2021 Bryanston
    Transvaal
    South Africa
    Administrateur
    26 Westminster Avenue
    2021 Bryanston
    Transvaal
    South Africa
    South African37842290001
    BULL, Roger Neil
    Lancaster Court
    Lancaster Park Newborough Road
    DE13 9PD Burton-On-Trent
    Unit 5.3,
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Lancaster Court
    Lancaster Park Newborough Road
    DE13 9PD Burton-On-Trent
    Unit 5.3,
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish80886990002
    DUNCAN, James Hugh
    102 Porlock Avenue
    Weeping Cross
    ST17 0HT Stafford
    Staffordshire
    Administrateur
    102 Porlock Avenue
    Weeping Cross
    ST17 0HT Stafford
    Staffordshire
    British55465950001
    DWYER, Stephen John
    26-28 Market Street
    WA14 1PF Altrincham
    Webber House
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    26-28 Market Street
    WA14 1PF Altrincham
    Webber House
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish57914140001
    GALLOWAY, Robert Christie, Dr
    3 Beech Avenue Cottages
    Park Nook Quarndon
    DE6 4LE Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    3 Beech Avenue Cottages
    Park Nook Quarndon
    DE6 4LE Derby
    Derbyshire
    British19919960001
    HULL, Christopher John
    53 4th Avenue
    2196 Illovo
    South Africa
    Administrateur
    53 4th Avenue
    2196 Illovo
    South Africa
    South African50233720001
    KNAUFF, Pierre Marie Charles Jean
    Hoden Farm Hoden Lane
    Cleeve Prior
    WR11 8LH Evesham
    Administrateur
    Hoden Farm Hoden Lane
    Cleeve Prior
    WR11 8LH Evesham
    EnglandBritish87761560001
    MAIDSTONE, Paul Kenneth
    Unit 5.3 Lancaster Park
    DE13 9PD Burton Upon Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Unit 5.3 Lancaster Park
    DE13 9PD Burton Upon Trent
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish171255000001
    OYETUNDE, Olufemi Kolawole
    Lancaster Park Newborough Road
    DE13 9PD Burton-On-Trent
    Unit 5.3 Lancaster Court
    Staffordshire
    Administrateur
    Lancaster Park Newborough Road
    DE13 9PD Burton-On-Trent
    Unit 5.3 Lancaster Court
    Staffordshire
    United KingdomBritish103301090001
    SUDWORTH, James Lowe
    5 Home Farm
    Geary Lane, Bretby
    DE15 0QE Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Home Farm
    Geary Lane, Bretby
    DE15 0QE Burton Upon Trent
    Staffordshire
    British86497030001
    SUDWORTH, James Lowe
    5 Home Farm
    Geary Lane, Bretby
    DE15 0QE Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    5 Home Farm
    Geary Lane, Bretby
    DE15 0QE Burton Upon Trent
    Staffordshire
    British86497030001
    TILLEY, Alec Roger
    The Smithy
    Mugginton
    DE6 4PL Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    The Smithy
    Mugginton
    DE6 4PL Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish88992360001
    TILLEY, Alec Roger
    The Smithy
    Mugginton
    DE6 4PL Derby
    Derbyshire
    Administrateur
    The Smithy
    Mugginton
    DE6 4PL Derby
    Derbyshire
    EnglandBritish88992360001
    TOOTAL, Christopher Peter
    Fountain Farm
    Ardleigh
    CO7 7RG Colchester
    Essex
    Administrateur
    Fountain Farm
    Ardleigh
    CO7 7RG Colchester
    Essex
    British23338660001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleUnited Kingdom (England)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement607012
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 nov. 201620 déc. 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage debenture
    Créé le 17 janv. 2007
    Livré le 18 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 mars 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 23 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 18 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 50 goodsmoor road industrial estate sinfin derby. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 avr. 2005
    Livré le 22 avr. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 50 goodsmoor road industrial estate sinfin derby. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transactions
    • 22 avr. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 juil. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 25 nov. 2001
    Livré le 07 déc. 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at goodsmoor road sinfin derby t/no: DY247116. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 07 déc. 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2000
    Livré le 13 mai 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 mai 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 mai 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 23 août 1984
    Livré le 11 sept. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Floating charge over undertaking & all other assets present and future fixed charge over company's assets book debts & godwill.
    Personnes ayant droit
    • B. R. D. Properties Limited
    Transactions
    • 11 sept. 1984Enregistrement d'une charge

    BETA RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    27 mars 2019Commencement of winding up
    22 mai 2023Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    Colin Peter Dempster
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5QR Leeds
    West Yorkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0