HDL (CATERING) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHDL (CATERING) LIMITED
    Statut de la sociétéConverti / Fermé
    Forme juridiqueConverti ou fermé
    Numéro de société 01561361
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HDL (CATERING) LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe HDL (CATERING) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HDL (CATERING) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SEDDONS FOODS LIMITED26 févr. 198826 févr. 1988
    SEDDONS-PALATINE LIMITED14 mai 198114 mai 1981

    Quels sont les derniers comptes de HDL (CATERING) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au01 janv. 2011

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HDL (CATERING) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HDL (CATERING) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Certificat d'immatriculation d'une société de secours mutuel

    CERTIPS

    Divers

    Forms b & z to convert to i&ps
    2 pagesMISC

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Convert to i&ps 17/06/2011
    RES13

    Nomination de Mr Steven Clive Bailey en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Stephen Humes en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 juil. 2011

    État du capital au 21 juil. 2011

    • Capital: GBP 1,416
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 01 janv. 2011

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen Humes le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Timothy Hurrell le 01 août 2010

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 02 janv. 2010

    4 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 11 janv. 2010 au 02 janv. 2010

    1 pagesAA01

    Nomination de Mrs Caroline Jane Sellers en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Katherine Eldridge en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    legacy

    3 pages363a

    Comptes pour une société dormante établis au 10 janv. 2009

    4 pagesAA

    Comptes pour une société dormante établis au 12 janv. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages288a

    Qui sont les dirigeants de HDL (CATERING) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    Secrétaire
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150084390001
    BAILEY, Steven Clive
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    United KingdomBritish95753690002
    HURRELL, Timothy
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish99724260001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Secrétaire
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    British10084840001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Secrétaire
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Secrétaire
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Secrétaire
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UNITED CO OPERATIVES SECRETARY LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Secrétaire
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110061750001
    ASPRAY, Rodney George
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    British2637360001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Administrateur
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    FLITCROFT, Kevin
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    Administrateur
    9 Willow Place
    Elswick
    PR4 3ZP Preston
    Lancashire
    British13792010001
    HUMES, Stephen
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    Administrateur
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United KingdomBritish84087790001
    HUNT, Walter Kenneth
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    44 Woolley Avenue
    Poynton
    SK12 1XU Stockport
    Cheshire
    British9318100001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Administrateur
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    United KingdomEnglish43686960001
    KNOWLES, John Keith
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    611 Lytham Road
    FY4 1RG Blackpool
    Lancashire
    British13791990001
    MCCRACKEN, Philip Guy
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    Administrateur
    The Bothy
    Bere Court Farm Pangbourne
    RG8 8HT Reading
    Berkshire
    United KingdomBritish106997230001
    MCGOERN, Alan
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    Administrateur
    5 Meadow Bank
    SK13 9UY Glossop
    Derbyshire
    British28940610001
    PAGE, Jeffrey Thomas
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    12 Alders Road
    Disley
    SK12 2LJ Stockport
    Cheshire
    British8638090001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Administrateur
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    SILVER, Steven Russell
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    Administrateur
    Farr Royd House
    72 Sun Lane
    LS29 7LT Burley In Wharfedale
    West Yorkshire
    EnglandBritish182256460001
    STEVENSON, Brian
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    Administrateur
    Clough Farm Carters Lane
    Gisburn
    BB7 4HZ Clitheroe
    Lancashire
    British13792000001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Administrateur
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    UNITED CO OPERATIVES DIRECTOR 1 LIMITED
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Administrateur
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    110062190001

    HDL (CATERING) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 13 avr. 1989
    Livré le 21 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land and buildings k/a wesley mill, bamber bridge, preston, lancs.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 02 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 13 avr. 1989
    Livré le 21 avr. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transactions
    • 21 avr. 1989Enregistrement d'une charge
    • 02 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 31 août 1988
    Livré le 12 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 août 1988
    Livré le 12 sept. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H lands hereditaments and premises being wesley mill off club street bamber bridge preston.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Chattels mortgage
    Créé le 22 août 1988
    Livré le 23 août 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All & singular the chattels, plant, machinery & terms described on form 395 (for full details see form 395).
    Personnes ayant droit
    • Forward Trust Limited
    Transactions
    • 23 août 1988Enregistrement d'une charge
    • 04 juin 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 mars 1988
    Livré le 11 avr. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way fo legal mortgage:- f/hold land together with the buildings erected thereon situate off club street, bamber bridge south ribble lancs. Together with a right of way over and along the adjoining roadway leading to club st aforesaid fixed charge over plant, machienry implements utensils furniture and equipment fixtures & fittings.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 11 avr. 1988Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 26 févr. 1988
    Livré le 18 mars 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Upk 55,000 one pound 5% second debenture loan stock and all monies due supplemental to a loan stock agreement of even date.
    Brèves mentions
    All freehold & leasehold property, goodwill, book debts, undertaking and all property and assets.
    Personnes ayant droit
    • John Keith Knowles
    Transactions
    • 18 mars 1988Enregistrement d'une charge
    • 02 janv. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 avr. 1984
    Livré le 09 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge and undertaking and all property and assets present and future including godwill book & other debts uncalled capital. Together with all fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transactions
    • 09 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Charge
    Créé le 27 mai 1981
    Livré le 02 juin 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 02 juin 1981Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0