INTERCITY CONSULTANTS LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | INTERCITY CONSULTANTS LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 01563022 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?
| Adresse du siège social | Dawson House 5 Jewry Street EC3N 2EX London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2015 |
Quels sont les derniers dépôts pour INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 août 2016 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR à Dawson House 5 Jewry Street London EC3N 2EX le 15 avr. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Roger Harold Antony en tant que secrétaire le 30 juin 2015 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alastair John Lomond Woolley en tant que secrétaire le 30 juin 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mr Roger Harold Antony en tant qu'administrateur le 30 juin 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alastair John Lomond Woolley en tant que directeur le 30 juin 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014 | 5 pages | AA | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 11 Golden Square London W1F 9JB England à 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR le 09 déc. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Wimbeldon Bridge House C/O Parity Group Plc 1St Floor 1 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3RU à 11 Golden Square London W1F 9JB le 25 sept. 2014 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011 | 5 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010 | 4 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Alastair John Lomond Woolley en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Ketchin en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Ketchin en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONY, Roger Harold | Secrétaire | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | 199307430001 | |||||||
| ANTONY, Roger Harold | Administrateur | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | England | British | 199013040001 | |||||
| FIRTH, David Samuel Peter | Secrétaire | Wood Mill House Shoreham Road BN5 9SD Henfield West Sussex | British | 77398810001 | ||||||
| HARRIS, Christopher John | Secrétaire | 73 Chart Lane RH2 7EA Reigate Surrey | British | 37108360001 | ||||||
| KELLY, Joseph Patrick | Secrétaire | 39 Manor Road AL4 8JG Wheathamsread Herts | British | 61057590001 | ||||||
| KETCHIN, Ian Malcolm | Secrétaire | 118 Goddington Lane BR6 9DZ Orpington Kent | British | 93777900002 | ||||||
| LEYSHON, Alison Jane | Secrétaire | 30 Foster Road Chiswick W4 4NY London | British | 65584930003 | ||||||
| MOSS, Ronald Allen | Secrétaire | Stonechat Frithsden Copse HP4 1NN Berkhamsted Hertfordshire | British | 6787850003 | ||||||
| SIMMONDS, Stephen William | Secrétaire | 15 Hyde Lane Nash Mills HP3 8RY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 28604570001 | ||||||
| WATKINSON, Ed | Secrétaire | Aberue Bridge Street YO51 9LA Boroughbridge North Yorkshire | British | 106937690001 | ||||||
| WOOLLEY, Alastair John Lomond | Secrétaire | Bath Place Rivington Street EC2A 3DR London 2 England | 159204550001 | |||||||
| HUGHES, John Llewellyn Mostyn | Administrateur | Albion Riverside 8 Hester Road SW11 4AR London C77 | Uk | British | 104248860001 | |||||
| KELLY, Joseph Patrick | Administrateur | 39 Manor Road AL4 8JG Wheathamsread Herts | British | 61057590001 | ||||||
| KETCHIN, Ian Malcolm | Administrateur | 118 Goddington Lane BR6 9DZ Orpington Kent | England | British | 93777900002 | |||||
| LEYSHON, Alison Jane | Administrateur | 30 Foster Road Chiswick W4 4NY London | British | 65584930003 | ||||||
| MILLER, Ian Kenneth | Administrateur | 4234 Lomo Alto Court Dallas Tx75219 Usa | United Kingdom | Scottish | 89546660001 | |||||
| MOSS, Ronald Allen | Administrateur | Stonechat Frithsden Copse HP4 1NN Berkhamsted Hertfordshire | England | British | 6787850003 | |||||
| O'DRISCOLL, Ian | Administrateur | Two Goods Farm Moorside DT10 1HQ Marnhull Dorset | British | 68202110001 | ||||||
| SHARPE, William John Ashdown | Administrateur | Leawood Cottage Northchurch Common HP4 1LR Berkhamstead Hertfordshire | British | 10140350001 | ||||||
| SIMMONDS, Stephen William | Administrateur | 15 Hyde Lane Nash Mills HP3 8RY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 28604570001 | ||||||
| TRIGG, Stephen John | Administrateur | 3 The Orchards 72 Oxford Road Stone HP17 8PL Aylesbury Bucks | United Kingdom | British | 31432190006 | |||||
| WELCH, Alwyn Frank | Administrateur | Coniston Farnham Lane GU27 1EZ Haslemere Surrey | England | British | 56811010001 | |||||
| WOOLLEY, Alastair John Lomond | Administrateur | Bath Place Rivington Street EC2A 3DR London 2 England | United Kingdom | British | 89506550002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Css Software Solutions Ltd | 06 avr. 2016 | 5 Jewry Street EC3N 2EX London Dawson House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
INTERCITY CONSULTANTS LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Créé le 19 juin 1990 Livré le 21 juin 1990 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions By way of legal mortgage the l/h property known as on being suite 6, scott house admirals way london E14 9UG including the entites of the property comprisal in land colificate title no egl 178517 together with all buildings and fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 15 déc. 1988 Livré le 23 déc. 1988 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 sept. 1987 Livré le 23 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 80 wapping high street london E1 title no ngl 180934. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 18 sept. 1987 Livré le 23 sept. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 6 scott house waterside marsh wall isle of dogs london title no - egl 178517. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 31 juil. 1987 Livré le 07 août 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions F/Hold 80 wapping high street london E7 assignment of the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal mortgage | Créé le 03 avr. 1987 Livré le 22 avr. 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions 80 wapping high street london E7. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Legal charge | Créé le 09 mars 1987 Livré le 18 mars 1987 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Empire site 6 scott howe, isle of dogs london EC4. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 déc. 1983 Livré le 06 janv. 1984 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0