INTERCITY CONSULTANTS LIMITED

INTERCITY CONSULTANTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéINTERCITY CONSULTANTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01563022
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Dawson House
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    RINGPLACE LIMITED20 mai 198120 mai 1981

    Quels sont les derniers comptes de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 31 août 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2015

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR à Dawson House 5 Jewry Street London EC3N 2EX le 15 avr. 2016

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital22 sept. 2015

    État du capital au 22 sept. 2015

    • Capital: GBP 15,616
    SH01

    Nomination de Mr Roger Harold Antony en tant que secrétaire le 30 juin 2015

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Alastair John Lomond Woolley en tant que secrétaire le 30 juin 2015

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Roger Harold Antony en tant qu'administrateur le 30 juin 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Alastair John Lomond Woolley en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    5 pagesAA

    Changement d'adresse du siège social de 11 Golden Square London W1F 9JB England à 2 Bath Place Rivington Street London EC2A 3DR le 09 déc. 2014

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de Wimbeldon Bridge House C/O Parity Group Plc 1St Floor 1 Hartfield Road Wimbledon London SW19 3RU à 11 Golden Square London W1F 9JB le 25 sept. 2014

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 sept. 2014

    État du capital au 01 sept. 2014

    • Capital: GBP 15,616
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2013

    État du capital au 16 sept. 2013

    • Capital: GBP 15,616
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2010

    4 pagesAA

    Nomination de Mr Alastair John Lomond Woolley en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Ian Ketchin en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Ian Ketchin en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Secrétaire
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    199307430001
    ANTONY, Roger Harold
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Administrateur
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    EnglandBritish199013040001
    FIRTH, David Samuel Peter
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Wood Mill House
    Shoreham Road
    BN5 9SD Henfield
    West Sussex
    British77398810001
    HARRIS, Christopher John
    73 Chart Lane
    RH2 7EA Reigate
    Surrey
    Secrétaire
    73 Chart Lane
    RH2 7EA Reigate
    Surrey
    British37108360001
    KELLY, Joseph Patrick
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    Secrétaire
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    British61057590001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Secrétaire
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    British93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Secrétaire
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    MOSS, Ronald Allen
    Stonechat
    Frithsden Copse
    HP4 1NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Stonechat
    Frithsden Copse
    HP4 1NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    British6787850003
    SIMMONDS, Stephen William
    15 Hyde Lane
    Nash Mills
    HP3 8RY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secrétaire
    15 Hyde Lane
    Nash Mills
    HP3 8RY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British28604570001
    WATKINSON, Ed
    Aberue
    Bridge Street
    YO51 9LA Boroughbridge
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Aberue
    Bridge Street
    YO51 9LA Boroughbridge
    North Yorkshire
    British106937690001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Secrétaire
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    159204550001
    HUGHES, John Llewellyn Mostyn
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    Administrateur
    Albion Riverside
    8 Hester Road
    SW11 4AR London
    C77
    UkBritish104248860001
    KELLY, Joseph Patrick
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    Administrateur
    39 Manor Road
    AL4 8JG Wheathamsread
    Herts
    British61057590001
    KETCHIN, Ian Malcolm
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    Administrateur
    118 Goddington Lane
    BR6 9DZ Orpington
    Kent
    EnglandBritish93777900002
    LEYSHON, Alison Jane
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    Administrateur
    30 Foster Road
    Chiswick
    W4 4NY London
    British65584930003
    MILLER, Ian Kenneth
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    Administrateur
    4234 Lomo Alto Court
    Dallas
    Tx75219
    Usa
    United KingdomScottish89546660001
    MOSS, Ronald Allen
    Stonechat
    Frithsden Copse
    HP4 1NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    Administrateur
    Stonechat
    Frithsden Copse
    HP4 1NN Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish6787850003
    O'DRISCOLL, Ian
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    Administrateur
    Two Goods Farm
    Moorside
    DT10 1HQ Marnhull
    Dorset
    British68202110001
    SHARPE, William John Ashdown
    Leawood Cottage
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    Leawood Cottage
    Northchurch Common
    HP4 1LR Berkhamstead
    Hertfordshire
    British10140350001
    SIMMONDS, Stephen William
    15 Hyde Lane
    Nash Mills
    HP3 8RY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Administrateur
    15 Hyde Lane
    Nash Mills
    HP3 8RY Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British28604570001
    TRIGG, Stephen John
    3 The Orchards
    72 Oxford Road Stone
    HP17 8PL Aylesbury
    Bucks
    Administrateur
    3 The Orchards
    72 Oxford Road Stone
    HP17 8PL Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish31432190006
    WELCH, Alwyn Frank
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    Administrateur
    Coniston Farnham Lane
    GU27 1EZ Haslemere
    Surrey
    EnglandBritish56811010001
    WOOLLEY, Alastair John Lomond
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    Administrateur
    Bath Place
    Rivington Street
    EC2A 3DR London
    2
    England
    United KingdomBritish89506550002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur INTERCITY CONSULTANTS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    06 avr. 2016
    5 Jewry Street
    EC3N 2EX London
    Dawson House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementUk
    Autorité légaleCompanies House Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement1702912
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    INTERCITY CONSULTANTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Mortgage
    Créé le 19 juin 1990
    Livré le 21 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of legal mortgage the l/h property known as on being suite 6, scott house admirals way london E14 9UG including the entites of the property comprisal in land colificate title no egl 178517 together with all buildings and fixtures thereon. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 21 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 1988
    Livré le 23 déc. 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Sevenska Handelsbanten
    Transactions
    • 23 déc. 1988Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 1987
    Livré le 23 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    80 wapping high street london E1 title no ngl 180934. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handlesbaken PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 1987
    Livré le 23 sept. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    6 scott house waterside marsh wall isle of dogs london title no - egl 178517. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Sevnska Handlesbaken PLC
    Transactions
    • 23 sept. 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 juil. 1987
    Livré le 07 août 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold 80 wapping high street london E7 assignment of the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 août 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 03 avr. 1987
    Livré le 22 avr. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    80 wapping high street london E7. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • Svenska Handlsbaken PLC
    Transactions
    • 22 avr. 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 mars 1987
    Livré le 18 mars 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Empire site 6 scott howe, isle of dogs london EC4.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 1987Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 déc. 1983
    Livré le 06 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 06 janv. 1984Enregistrement d'une charge
    • 03 mars 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0