PIMS PUMPS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | PIMS PUMPS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 01564082 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe PIMS PUMPS LIMITED ?
Adresse du siège social | Private Road No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de PIMS PUMPS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 juil. 2013 |
Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PIMS PUMPS LIMITED ?
Bilan annuel |
|
---|
Quels sont les derniers dépôts pour PIMS PUMPS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Karen Linda Pay en tant que directeur le 20 nov. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephane Rousselot en tant qu'administrateur le 28 sept. 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Robert Grund en tant que directeur le 11 sept. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire le 31 mars 2015 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que directeur le 31 mars 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 30 juil. 2014 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr Robert Grund en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Karen Linda Pay en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter John Lewington en tant que directeur le 27 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 03 nov. 2014
| 4 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | RESOLUTIONS | |||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 juil. 2013 | 17 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2013 au 31 juil. 2013 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Charles White en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Simon Ephithite en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hants GU14 8JE* le 29 août 2013 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de PIMS PUMPS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUSSELOT, Stephane | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | French | Finance Director | 202797810001 | ||||
BACKHOUSE, Christopher Mark | Secrétaire | 21 Dettingen Crescent Deepcut GU16 6GN Camberley Surrey | British | Chartered Accountant Company D | 101749180003 | |||||
BELL, Michael Hugh | Secrétaire | 4 Hugh De Port Lane GU51 1HT Fleet Hampshire | British | Director | 90062470004 | |||||
FAY, Sean Ernan | Secrétaire | The Orchard Woodhurst Lane RH8 9HD Oxted Surrey | Irish | Company Director | 84925400001 | |||||
LAWTON, Jeffrey Alan | Secrétaire | Enton Brook Water Lane Enton GU8 5AQ Godalming Surrey | British | 9304150002 | ||||||
SOWTER, Melanie Linda | Secrétaire | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | 179710580001 | |||||||
BACKHOUSE, Christopher Mark | Administrateur | 21 Dettingen Crescent Deepcut GU16 6GN Camberley Surrey | England | British | Chartered Accountant Company D | 101749180003 | ||||
BELL, Michael Hugh | Administrateur | 4 Hugh De Port Lane GU51 1HT Fleet Hampshire | England | British | Director | 90062470004 | ||||
CHALLACOMBE, Stuart Nicholas | Administrateur | Tutts Clump Tutts Clump RG7 6JU Reading The Paddock United Kingdom | England | British | Director | 101990700002 | ||||
EPHITHITE, Simon Ian | Administrateur | 3 Beechwood Close Church Crookham GU51 5PT Fleet Hampshire | England | British | Contracts Director | 43761100003 | ||||
FAY, Sean Ernan | Administrateur | The Orchard Woodhurst Lane RH8 9HD Oxted Surrey | United Kingdom | Irish | Company Director | 84925400001 | ||||
GRUND, Robert | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | Austrian | Finance Director | 182385330001 | ||||
LAWTON, Jeffrey Alan | Administrateur | Enton Brook Water Lane Enton GU8 5AQ Godalming Surrey | England | British | Company Director | 9304150002 | ||||
LAWTON, Leonard Derek | Administrateur | 8 Radcliffe Close Frimley Green Frimley GU16 9FF Camberley Surrey | British | Company Director | 37346650003 | |||||
LAWTON, Phillip John | Administrateur | 17 Glenmount Road Mytchett GU16 6AY Camberley Surrey | British | Company Director | 9304140001 | |||||
LEWINGTON, Peter John | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | England | British | Managing Director | 137420410001 | ||||
NEWMAN, David William | Administrateur | 15 Warborough Avenue Tilehurst RG31 5LB Reading | United Kingdom | British | Operations Director | 99625210001 | ||||
PAY, Karen Linda | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road | England | British | Hr Director | 176337440001 | ||||
SOWTER, Melanie Linda | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | England | British | Financial Director | 113352030002 | ||||
STEPHENSON, Andrew Thomas | Administrateur | 23 Branksome Hill Road College Town GU47 0QE Sandhurst Berkshire | British | Director | 101990660001 | |||||
WARNER, Paul | Administrateur | Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hants Gu14 8je | United Kingdom | British | Director | 101990620002 | ||||
WHITE, Charles Liddell | Administrateur | No 1 Colwick Industrial Estate NG4 2AN Nottingham Private Road United Kingdom | England | British | Director | 54824060002 |
PIMS PUMPS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Security over cash deposits | Créé le 05 févr. 2013 Livré le 08 févr. 2013 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All present and future rights to and interest in all of the amounts from time to time credited to the account being sort code: 40-42-18 account number: 40421842792400 amount: £145,000 including all interest and other benefits arising in connection with those amounts see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A guarantee and security agreement | Créé le 07 avr. 2009 Livré le 17 avr. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever | |
Brèves mentions All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A master guarantee and security agreement | Créé le 11 mars 2008 Livré le 25 mars 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Composite guarantee and debenture | Créé le 03 déc. 2004 Livré le 10 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from pims group limited and the subsidiaries to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 03 déc. 2004 Livré le 10 déc. 2004 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 17 déc. 1985 Livré le 27 déc. 1985 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0