PIMS PUMPS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPIMS PUMPS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01564082
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PIMS PUMPS LIMITED ?

    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières

    Où se situe PIMS PUMPS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Private Road No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PIMS PUMPS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 juil. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour PIMS PUMPS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour PIMS PUMPS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de Karen Linda Pay en tant que directeur le 20 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Stephane Rousselot en tant qu'administrateur le 28 sept. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Grund en tant que directeur le 11 sept. 2015

    1 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire le 31 mars 2015

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Melanie Linda Sowter en tant que directeur le 31 mars 2015

    1 pagesTM01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 juil. 2014 au 30 juil. 2014

    1 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 févr. 2015

    État du capital au 06 févr. 2015

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Nomination de Mr Robert Grund en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Karen Linda Pay en tant qu'administrateur le 27 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Peter John Lewington en tant que directeur le 27 nov. 2014

    1 pagesTM01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 03 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 31 juil. 2013

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 25 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 nov. 2013

    État du capital au 27 nov. 2013

    • Capital: GBP 10,000
    SH01

    Période comptable précédente prolongée du 30 avr. 2013 au 31 juil. 2013

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Charles White en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Simon Ephithite en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Unit 1 106 Hawley Lane Farnborough Hants GU14 8JE* le 29 août 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Michael Bell en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Melanie Linda Sowter en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de PIMS PUMPS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ROUSSELOT, Stephane
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandFrenchFinance Director202797810001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    Secrétaire
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    BritishChartered Accountant Company D101749180003
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Secrétaire
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    BritishDirector90062470004
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    IrishCompany Director84925400001
    LAWTON, Jeffrey Alan
    Enton Brook Water Lane
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    Secrétaire
    Enton Brook Water Lane
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    British9304150002
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Secrétaire
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    179710580001
    BACKHOUSE, Christopher Mark
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    Administrateur
    21 Dettingen Crescent
    Deepcut
    GU16 6GN Camberley
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant Company D101749180003
    BELL, Michael Hugh
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    4 Hugh De Port Lane
    GU51 1HT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishDirector90062470004
    CHALLACOMBE, Stuart Nicholas
    Tutts Clump
    Tutts Clump
    RG7 6JU Reading
    The Paddock
    United Kingdom
    Administrateur
    Tutts Clump
    Tutts Clump
    RG7 6JU Reading
    The Paddock
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector101990700002
    EPHITHITE, Simon Ian
    3 Beechwood Close
    Church Crookham
    GU51 5PT Fleet
    Hampshire
    Administrateur
    3 Beechwood Close
    Church Crookham
    GU51 5PT Fleet
    Hampshire
    EnglandBritishContracts Director43761100003
    FAY, Sean Ernan
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    Administrateur
    The Orchard
    Woodhurst Lane
    RH8 9HD Oxted
    Surrey
    United KingdomIrishCompany Director84925400001
    GRUND, Robert
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandAustrianFinance Director182385330001
    LAWTON, Jeffrey Alan
    Enton Brook Water Lane
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    Administrateur
    Enton Brook Water Lane
    Enton
    GU8 5AQ Godalming
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director9304150002
    LAWTON, Leonard Derek
    8 Radcliffe Close
    Frimley Green Frimley
    GU16 9FF Camberley
    Surrey
    Administrateur
    8 Radcliffe Close
    Frimley Green Frimley
    GU16 9FF Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director37346650003
    LAWTON, Phillip John
    17 Glenmount Road
    Mytchett
    GU16 6AY Camberley
    Surrey
    Administrateur
    17 Glenmount Road
    Mytchett
    GU16 6AY Camberley
    Surrey
    BritishCompany Director9304140001
    LEWINGTON, Peter John
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishManaging Director137420410001
    NEWMAN, David William
    15 Warborough Avenue
    Tilehurst
    RG31 5LB Reading
    Administrateur
    15 Warborough Avenue
    Tilehurst
    RG31 5LB Reading
    United KingdomBritishOperations Director99625210001
    PAY, Karen Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    EnglandBritishHr Director176337440001
    SOWTER, Melanie Linda
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishFinancial Director113352030002
    STEPHENSON, Andrew Thomas
    23 Branksome Hill Road
    College Town
    GU47 0QE Sandhurst
    Berkshire
    Administrateur
    23 Branksome Hill Road
    College Town
    GU47 0QE Sandhurst
    Berkshire
    BritishDirector101990660001
    WARNER, Paul
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    Hants
    Gu14 8je
    Administrateur
    Unit 1 106 Hawley Lane
    Farnborough
    Hants
    Gu14 8je
    United KingdomBritishDirector101990620002
    WHITE, Charles Liddell
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    Administrateur
    No 1
    Colwick Industrial Estate
    NG4 2AN Nottingham
    Private Road
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector54824060002

    PIMS PUMPS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security over cash deposits
    Créé le 05 févr. 2013
    Livré le 08 févr. 2013
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All present and future rights to and interest in all of the amounts from time to time credited to the account being sort code: 40-42-18 account number: 40421842792400 amount: £145,000 including all interest and other benefits arising in connection with those amounts see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    A guarantee and security agreement
    Créé le 07 avr. 2009
    Livré le 17 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the issuer and/or the company to the security trustee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the mortgaged property together with allbuildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transactions
    • 17 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A master guarantee and security agreement
    Créé le 11 mars 2008
    Livré le 25 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in the mortgaged property all buildings and fixtures thereon the proceeds of sale by way of floating charge all its undertaking and assets see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Inflexion Private Equity Partners LLP
    Transactions
    • 25 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from pims group limited and the subsidiaries to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All property assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gresham LLP as Trustee for Itself and the Registered Holders from Time to Time of Notes Issuedunder the Gresham Loan Note Instrument (In Suchcapacity, the Trustee)
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 janv. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 03 déc. 2004
    Livré le 10 déc. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 févr. 2013Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 déc. 1985
    Livré le 27 déc. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 déc. 1985Enregistrement d'une charge
    • 02 juil. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0