WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITEGROVE SUPPLIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01569114
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    • (7487) /
    • (9305) /

    Où se situe WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Unit 6 Goodwood Road
    Boyatt Wood Industrial Estate
    SO50 4NT Eastleigh Southampton
    Hampshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WHITEGROVE GROUP PLC23 févr. 199823 févr. 1998
    WHITEGROVE OFFICE SUPPLIES LIMITED23 juil. 198623 juil. 1986
    YELLOWMEAD LIMITED19 juin 198119 juin 1981

    Quels sont les derniers comptes de WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 18 déc. 2009

    • Capital: GBP 0.61
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Reducing share prem a/c 08/12/2009
    RES13

    Cessation de la nomination de Benjamin Richards en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Michael Ewart Smith le 09 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Benjamin William Richards le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    legacy

    4 pages363a

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2007

    7 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2006

    7 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages403a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    8 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages225

    Comptes annuels établis au 30 juin 2005

    11 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    8 pages155(6)a

    Résolutions

    Resolutions
    pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Appt of auditors 28/07/05
    RES13

    Résolutions

    Resolutions
    8 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    Qui sont les dirigeants de WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    MAYNARD, Philippa Anne
    7 Gilhams Avenue
    SM7 1QL Banstead
    Surrey
    Secrétaire
    7 Gilhams Avenue
    SM7 1QL Banstead
    Surrey
    BritishCompany Secretary44140850002
    EWART SMITH, Michael
    Unit 6 Goodwood Road
    Boyatt Wood Industrial Estate
    SO50 4NT Eastleigh Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Unit 6 Goodwood Road
    Boyatt Wood Industrial Estate
    SO50 4NT Eastleigh Southampton
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director73942450001
    RICHARDS, Benjamin William
    Birch Rise
    Chilworth Road Chilworth
    SO16 7JR Southampton
    Hampshire
    Secrétaire
    Birch Rise
    Chilworth Road Chilworth
    SO16 7JR Southampton
    Hampshire
    BritishDirector73942550003
    WESTWOOD SECRETARIES LIMITED
    Numerica Secretaries Limited
    66 Wigmore Street
    W1U 2HQ London
    Secrétaire
    Numerica Secretaries Limited
    66 Wigmore Street
    W1U 2HQ London
    72462860002
    COPESTAKE, Keith Ross
    12 The Green
    Charlton
    SP10 4AZ Andover
    Hampshire
    Administrateur
    12 The Green
    Charlton
    SP10 4AZ Andover
    Hampshire
    EnglandEnglishSales Director113188850001
    HOLLOWAY, Barrie
    1 Nacklestone Barns
    Leintwardine
    SY7 0NA Craven Arms
    Salop
    Administrateur
    1 Nacklestone Barns
    Leintwardine
    SY7 0NA Craven Arms
    Salop
    United KingdomBritishDirector34791580002
    KENNEDY, Robert Ernest
    Westways Otterbourne Road
    Shawford
    SO21 2DE Winchester
    Hampshire
    Administrateur
    Westways Otterbourne Road
    Shawford
    SO21 2DE Winchester
    Hampshire
    BritishSales Director31314720001
    KERR, Donald Macaulay
    Woolhampton Court Woolhampton Hill
    Woolhampton
    RG7 5ST Reading
    Berkshire
    England
    Administrateur
    Woolhampton Court Woolhampton Hill
    Woolhampton
    RG7 5ST Reading
    Berkshire
    England
    EnglandBritishCompany Director48132270001
    MCLEAN, Iain
    5 Turnstone End
    Yateley
    GU17 7PE Camberley
    Surrey
    Administrateur
    5 Turnstone End
    Yateley
    GU17 7PE Camberley
    Surrey
    BritishSales Director36411970001
    RICHARDS, Benjamin William
    Unit 6 Goodwood Road
    Boyatt Wood Industrial Estate
    SO50 4NT Eastleigh Southampton
    Hampshire
    Administrateur
    Unit 6 Goodwood Road
    Boyatt Wood Industrial Estate
    SO50 4NT Eastleigh Southampton
    Hampshire
    United KingdomBritishDirector157483970001
    RICHARDS, Mark Edward
    The Old Forge
    New Barn Road
    PO32 6AY East Cowes
    Isle Of Wight
    Administrateur
    The Old Forge
    New Barn Road
    PO32 6AY East Cowes
    Isle Of Wight
    BritishOperations Director54989070004
    SHAW, Barbara Anne
    5 Caledonian Close
    BH23 4SY Christchurch
    Dorset
    Administrateur
    5 Caledonian Close
    BH23 4SY Christchurch
    Dorset
    BritishSales Director96473330001
    STANDING, Brian John
    The Manor House
    Great Shefford
    RG17 7DZ Hungerford
    Berkshire
    Administrateur
    The Manor House
    Great Shefford
    RG17 7DZ Hungerford
    Berkshire
    BritishChairman94957120001

    WHITEGROVE SUPPLIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 01 août 2005
    Livré le 03 août 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Wesminster Bank PLC as Security Agent
    Transactions
    • 03 août 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 11 mars 2003
    Livré le 18 mars 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 18 mars 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    All assets debenture
    Créé le 03 déc. 1999
    Livré le 08 déc. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the financing agreement (as defined in the all assets debenture)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 08 déc. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 15 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 03 sept. 1996
    Livré le 13 sept. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under an invoice discounting or factoring agreement
    Brèves mentions
    All book and other debts which fail to vest together with all title property right or interest in the goods to which the debts relate all guarantees indemnities insurances and securities. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Commercial Services Limited
    Transactions
    • 13 sept. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mars 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 20 sept. 1994
    Livré le 29 sept. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 sept. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 oct. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 03 févr. 1992
    Livré le 08 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Spicers Limited
    Transactions
    • 08 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 juil. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 24 sept. 1991
    Livré le 26 sept. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 26 sept. 1981
    Livré le 26 sept. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital & all buildings fixtures (inc. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 26 sept. 1981Enregistrement d'une charge
    • 18 mai 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0