CIVICA INSIGHT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCIVICA INSIGHT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01569298
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SANDERSON INSIGHT LIMITED17 sept. 199217 sept. 1992
    INSIGHT TERMINALS LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981

    Quels sont les derniers comptes de CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 01 juin 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 nov. 2014

    État du capital au 12 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 04 juil. 2014

    • Capital: GBP 1
    4 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 03/07/2014
    RES13

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2013

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Richard Downing le 04 juil. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2010

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2009

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Phillip David Rowland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Michael Stoddard en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 nov. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de CIVICA INSIGHT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Secrétaire
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    British72002400004
    DOWNING, Simon Richard
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    Administrateur
    2 Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    EnglandBritish95005230002
    ROWLAND, Phillip David
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    United Kingdom
    Administrateur
    Burston Road
    Putney
    SW15 6AR London
    2
    United Kingdom
    United KingdomBritish147804670001
    BRIDLE, Deborah
    Clock Cottage
    Cleves Lane, Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Clock Cottage
    Cleves Lane, Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    British75032970001
    FROST, Adrian David
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    Secrétaire
    2 Edwards Road
    B75 5NG Sutton Coldfield
    West Midlands
    British74874640001
    WILKINSON, Jane Allison
    15a Low Way
    LS23 6LB Clifford
    West Yorkshire
    Secrétaire
    15a Low Way
    LS23 6LB Clifford
    West Yorkshire
    British96725700001
    BRIDLE, Deborah
    Clock Cottage
    Cleves Lane, Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Clock Cottage
    Cleves Lane, Upton Grey
    RG25 2RG Basingstoke
    Hampshire
    United KingdomBritish75032970001
    CARROLL, Peter James
    1 Crosslands
    Prestwich
    M25 9QT Manchester
    Lancashire
    Administrateur
    1 Crosslands
    Prestwich
    M25 9QT Manchester
    Lancashire
    British21645790001
    NODEN, Philip Thomas
    Little Mill Cottage
    Colemere
    SY12 0QR Ellesmere
    Shropshire
    Administrateur
    Little Mill Cottage
    Colemere
    SY12 0QR Ellesmere
    Shropshire
    British141537860001
    O'BYRNE, David Andrew
    Daisy Cottage Chapel Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DA York
    Administrateur
    Daisy Cottage Chapel Street
    Kirk Hammerton
    YO26 8DA York
    EnglandBritish61632450001
    STODDARD, Michael
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    Administrateur
    Walnut Cottage
    Main Street Hanwell
    OX17 1HN Banbury
    Oxfordshire
    EnglandBritish72002400004
    THOMPSON, Paul
    Moorgate Road
    S60 2AD Rotherham
    41
    South Yorkshire
    Administrateur
    Moorgate Road
    S60 2AD Rotherham
    41
    South Yorkshire
    EnglandBritish67791110003
    WATSON, David John
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    Administrateur
    151 High Street
    OX44 7ST Chalgrove
    Oxfordshire
    British45073610001
    WAY, Victor
    32 Church Road
    MK43 9HF Wootton
    Bedfordshire
    Administrateur
    32 Church Road
    MK43 9HF Wootton
    Bedfordshire
    United KingdomBritish75032960001
    WINN, Christopher
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    Administrateur
    Willow Bank Halls Farm Lane
    Trimpley
    DY12 1NP Bewdley
    Worcestershire
    United KingdomBritish15932260001

    CIVICA INSIGHT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Third guarantee & debenture between the chargor company and others and the dresdner bank ag, london branch
    Créé le 11 juil. 2000
    Livré le 12 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All money and liabilities due owing or incurred by the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents on or after the debenture date and under or pursuant to the mezzanine finance documents (all as defined therein)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    Transactions
    • 12 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    A second guarantee and debenture between, amongst others the company (being the chargor) and dresdner bank ag, london branch (as security trustee)
    Créé le 10 mars 2000
    Livré le 21 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to each beneficiary under or pursuant to the senior finance documents and mezzanine finance documents (as therein defined), excluding from the above any liability or sum outstanding under the term facility, the loan note guarantee facility, the revolving credit facility and the mezzanine loan agreement and any other liability or sum which would, but for the proviso, cause such covenants and guarantees or the security which would otherwise be constituted by the debenture for such liability or sum to constitute lawful financial assistance prohibited by section 151 of the act
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dresdner Bank Ag, London Branch (As Security Trustee)
    Transactions
    • 21 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 30 déc. 2003Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 24 mars 1997
    Livré le 04 avr. 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    106A bedford road wootton bedford beds.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 04 avr. 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 21 janv. 1987
    Livré le 29 janv. 1987
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 1987Enregistrement d'une charge
    • 05 mai 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed and floating charge
    Créé le 14 oct. 1981
    Livré le 19 oct. 1981
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank LTD
    Transactions
    • 19 oct. 1981Enregistrement d'une charge

    CIVICA INSIGHT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    01 juin 2015Commencement of winding up
    08 avr. 2016Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0