I.T. POWER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéI.T. POWER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01571786
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de I.T. POWER LIMITED ?

    • Activités de conseil scientifique et technique liées à l'ingénierie (71122) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe I.T. POWER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O KRE CORPORATE RECOVERY LLP
    Unit 8 The Aquarium 1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de I.T. POWER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INTERMEDIATE TECHNOLOGY POWER LIMITED01 juil. 198101 juil. 1981

    Quels sont les derniers comptes de I.T. POWER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2013

    Quels sont les derniers dépôts pour I.T. POWER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    25 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 août 2020

    22 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kre Corporate Recovery Llp 1st Floor, Hedrich House 14-16 Cross Street Reading Berkshire RG1 1SN à Unit 8 the Aquarium 1-7 King Street Reading RG1 2AN le 16 janv. 2020

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 août 2019

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 août 2018

    18 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 août 2017

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 août 2016

    12 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de C/O Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House 23 Duke Street Reading RG1 4SA à C/O Kre Corporate Recovery Llp 1st Floor, Hedrich House 14-16 Cross Street Reading Berkshire RG1 1SN le 12 juil. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 24 août 2015

    15 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 02 avr. 2015

    15 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    2 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    29 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de St Brandon's House 29 Great George Street Bristol BS1 5QT à C/O Kre Corporate Recovery Llp Dukesbridge House 23 Duke Street Reading RG1 4SA le 16 oct. 2014

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    État du capital après une attribution d'actions au 24 mars 2014

    • Capital: GBP 484,516
    3 pagesSH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 15 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    11 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Derrick le 17 mars 2014

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Bernard Mcnelis le 17 mars 2014

    2 pagesCH01

    Statuts

    26 pagesMEM/ARTS

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution des statuts

    RES01

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2013

    10 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de I.T. POWER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    NICKOLS, Adrian David
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    Secrétaire
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    177489500001
    ADRA, Nadine
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    Administrateur
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    FranceFrenchCompany Director171621190001
    AGRAWAL, Rajiv
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    Administrateur
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    IndiaIndianCompany Director174676630001
    DERRICK, Anthony
    Redwood Road
    EX10 9AB Sidmouth
    Fairlea
    Devon
    England
    Administrateur
    Redwood Road
    EX10 9AB Sidmouth
    Fairlea
    Devon
    England
    United KingdomBritishEnergy Consultant19658450003
    HART, Terence John
    2 Derb Sidi
    Ahmed Ben Naceur
    FOREIGN Kaat Ben Ahid
    Marrakech
    Morocco
    Administrateur
    2 Derb Sidi
    Ahmed Ben Naceur
    FOREIGN Kaat Ben Ahid
    Marrakech
    Morocco
    MoroccoBritishEnergy Consultant29461240002
    MCNELIS, Bernard, Professor
    Bratton Clovelly
    EX20 4JF Okehampton
    Eversfield Manor
    Devon
    England
    Administrateur
    Bratton Clovelly
    EX20 4JF Okehampton
    Eversfield Manor
    Devon
    England
    EnglandBritishEnergy Consultant19658430003
    NICKOLS, Adrian David
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    Administrateur
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    EnglandBritishGroup Ceo163967360001
    TANTI, Girish
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    Administrateur
    1-7 King Street
    RG1 2AN Reading
    Unit 8 The Aquarium
    SingaporeIndianCompany Director171498890001
    VAGADIA, Kirtikant
    Kalpataru Regency-Ii
    Kalyaninagar
    411006 Pune
    D302
    Maharashtra
    India
    Administrateur
    Kalpataru Regency-Ii
    Kalyaninagar
    411006 Pune
    D302
    Maharashtra
    India
    IndiaIndianEnergy Business Management137631690001
    DERRICK, Anthony
    Pilcot Farm House
    Dogmersfield
    RG27 8ST Basingstoke
    Hampshire
    Secrétaire
    Pilcot Farm House
    Dogmersfield
    RG27 8ST Basingstoke
    Hampshire
    British19658450001
    WALSH, Andrew John
    Gatcombe House
    Pytchley Road
    SE22 8BU East Dulwich
    15
    London
    Uk
    Secrétaire
    Gatcombe House
    Pytchley Road
    SE22 8BU East Dulwich
    15
    London
    Uk
    BritishChartered Accountant137222800001
    BAKTHAVATSALAM, Venkatrama
    Jasola
    110025 New Delhi
    Pocket I
    New Delhi
    India
    Administrateur
    Jasola
    110025 New Delhi
    Pocket I
    New Delhi
    India
    IndiaIndianEnergy Business Management137631010001
    BATES, Jonathan Richard, Dr
    90 Russell Road
    RG14 5LA Newbury
    Berkshire
    Administrateur
    90 Russell Road
    RG14 5LA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritishConsultant83737660001
    DEO, Neelam
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    Administrateur
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    IndiaIndianConsultant151620720002
    DEO, Neelam
    Grove House
    Lutyens Close Chineham
    RG24 8AG Basingstoke
    Hampshire
    Administrateur
    Grove House
    Lutyens Close Chineham
    RG24 8AG Basingstoke
    Hampshire
    IndaIndianConsultant150208010001
    FRAENKEL, Peter Leonard
    2 Amherst Avenue
    W13 8NQ London
    Administrateur
    2 Amherst Avenue
    W13 8NQ London
    EnglandBritishMechanical Engineer70958740002
    GREEN, John Peter, Dr
    67 Quantock Road
    BS3 4PQ Bristol
    Administrateur
    67 Quantock Road
    BS3 4PQ Bristol
    BritishEnergy Consultant71240040003
    LEONG KEI WEI, Mark
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    Administrateur
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    SingaporeSingaporeanCompany Director174676810001
    MEHTA, Harish
    Pushkar Apartments
    380054 Bodakdev
    402
    Ahmedabad
    India
    Administrateur
    Pushkar Apartments
    380054 Bodakdev
    402
    Ahmedabad
    India
    IndiaIndianEnergy Business Management137632430001
    RAMADURAI, Chandrasekar, Mr.
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    Administrateur
    29 Great George Street
    BS1 5QT Bristol
    St Brandon's House
    United Kingdom
    IndiaIndianGeneral Management171503020002
    RAMADURAI, Chandrasekar, Mr.
    C-1903/4, Lake Lucerne
    Powai
    400076 Mumbai
    Lake Homes
    India
    Administrateur
    C-1903/4, Lake Lucerne
    Powai
    400076 Mumbai
    Lake Homes
    India
    IndiaIndianGeneral Management171503020002
    SHAH, Dipesh Jayantilal
    Chez Les Shah
    Haywood Close
    HA5 3LQ Pinner
    Middlesex
    Administrateur
    Chez Les Shah
    Haywood Close
    HA5 3LQ Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChairman13564990002
    VEYAN, Philippe
    73 Allee Du Vieux Frene
    Craponne
    69290
    France
    Administrateur
    73 Allee Du Vieux Frene
    Craponne
    69290
    France
    FranceFrenchBusiness Dev Manager110642080001

    I.T. POWER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge of deposit
    Créé le 06 avr. 2004
    Livré le 27 avr. 2004
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The deposit initially of euro 99,984 credited to account designation 00/48001996/550 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit deed
    Créé le 15 août 2001
    Livré le 22 août 2001
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a lease of even date
    Brèves mentions
    All the deposit monies.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Custodian of the Diageo Pension Scheme)
    Transactions
    • 22 août 2001Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 21 janv. 1998
    Livré le 10 févr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a the warren bramshill road eversley hampshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 10 févr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 12 févr. 1991
    Livré le 21 févr. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/as the warren bramshill road eversley hampshire the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1991Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An agreement
    Créé le 30 juil. 1990
    Livré le 04 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the indemnity (as defined).
    Brèves mentions
    The company's right, title and interest in the funds held in the security account from time-to-time.
    Personnes ayant droit
    • London & International Mercantile Limited.
    Transactions
    • 04 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Agreement
    Créé le 19 juil. 1990
    Livré le 01 août 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    The performance and discharge of all its obligations and liabilities under the indemnity d/d 19-7-90
    Brèves mentions
    The company's right, title and interest in the funds held in the security account.
    Personnes ayant droit
    • London & International Mercantile Limited
    Transactions
    • 01 août 1990Enregistrement d'une charge
    • 19 avr. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed constituting £30000 variable rate secured loan stock 1991
    Créé le 06 juin 1990
    Livré le 20 juin 1990
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £30,000 variable rate secured loan stock 1991, and all other monies due or to become due under the terms of the charge
    Brèves mentions
    F/Hold property with dwelling house k/as the warren eversley, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Satec (Holdings) Limited
    Transactions
    • 20 juin 1990Enregistrement d'une charge
    • 20 févr. 1992Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 06 déc. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal & floating charge.
    Créé le 06 déc. 1989
    Livré le 13 déc. 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The warren bramshill rd, eversley, hampshire & buildings furniture, equipment now or from time to time. Goodwill of the business and the benefit of all present and future licences.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Bank PLC.
    Transactions
    • 13 déc. 1989Enregistrement d'une charge
    • 29 juin 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Deed:
    Créé le 21 juin 1989
    Livré le 27 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £5,700 variable rate secured loan stock 1990 of the company and all other moneys due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Freehold land and premises known as "the warren" eversley hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Satec Limited
    Transactions
    • 27 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Letter of charge
    Créé le 07 juin 1989
    Livré le 27 juin 1989
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank designated.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 27 juin 1989Enregistrement d'une charge
    Deed registered pursuant to an order of court dated 23/5/88
    Créé le 24 avr. 1987
    Livré le 03 juin 1988
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For securing £52,500 variable rate secured loan stock 1990 of the co. And all other monies due or to become due from the company to the stockholders for the time being as stated in the deed.
    Brèves mentions
    F/H land & premises k/a "the warren" eversley, hants.
    Personnes ayant droit
    • Satec Limited
    Transactions
    • 03 juin 1988Enregistrement d'une charge
    Mortgage
    Créé le 15 nov. 1986
    Livré le 25 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property k/a "the warren" eversley hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Satec Limited
    Transactions
    • 25 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    Legal charge
    Créé le 14 nov. 1986
    Livré le 03 déc. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    'The warren st neots school, eversley, hampshire.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 03 déc. 1986Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 18 janv. 1984
    Livré le 31 janv. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 31 janv. 1984Enregistrement d'une charge

    I.T. POWER LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 août 2015Administration ended
    03 oct. 2014Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gareth Wyn Roberts
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    practitioner
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    Robert Christopher Keyes
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    practitioner
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    2
    DateType
    24 août 2015Commencement of winding up
    02 sept. 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gareth Wyn Roberts
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    proposed liquidator
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    Robert Christopher Keyes
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    proposed liquidator
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    Gareth Wyn Roberts
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    practitioner
    Dukesbridge House
    23 Duke Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    Robert Christopher Keyes
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire
    practitioner
    Dukesbridge House 23 Dukes Street
    RG1 4SA Reading
    Berkshire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0