BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01571833
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    TROLHURST LIMITED01 juil. 198101 juil. 1981

    Quels sont les derniers comptes de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 avr. 2016

    LRESSP
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 29 avr. 2016

    LRESSP

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire des membres

    2 pagesREST-MVL

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    6 pages4.71

    Nomination de Mr Andrew William Hodges en tant qu'administrateur le 30 juin 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicola Margaret Carroll en tant que directeur le 30 juin 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 févr. 2016

    État du capital au 05 févr. 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Nicola Margaret Carroll le 09 oct. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2014

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 févr. 2015

    État du capital au 17 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2013

    2 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2014

    État du capital au 27 févr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cessation de la nomination de Steven Buck en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Centrica Directors Limited en tant qu'administrateur

    2 pagesAP02

    Nomination de Nicola Margaret Carroll en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Matthew Bateman en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 01 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CENTRICA SECRETARIES LIMITED
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Secrétaire
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    71532760003
    HODGES, Andrew William
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary77527910004
    CENTRICA DIRECTORS LIMITED
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Millstream
    Berkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement3844287
    146695600001
    FREUDMANN, Anthony
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    Secrétaire
    15 Lings Coppice
    SE21 8SY London
    British43335320001
    WHEATLEY, Trevor Neil Pearse
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    Secrétaire
    28 St Johns Hill
    SY1 1JJ Shrewsbury
    Shropshire
    BritishCompany Secretary34588420002
    ARIF, Louise
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    Administrateur
    7 Wolfe Crescent
    Surrey Quays
    SE16 1SF London
    BritishDirector36425190002
    BASSIS, Anne Elizabeth
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    Administrateur
    Harcourt Terrace
    SW10 9JP London
    75
    Greater London
    United Kingdom
    United KingdomAmerican/BritishCompany Director112345920001
    BATEMAN, Matthew James
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director138280510002
    BOWTELL, John Paul Maurice
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    Administrateur
    Hallam
    Sampford Road
    CB10 2TL Radwinter
    Essex
    BritishAccountant82969690001
    BUCK, Steven John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishFinance Director96292880001
    CARROLL, Nicola
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary278861170001
    COLLIER, Edward Arthur Yarlet
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    Administrateur
    Whitehill Close
    Old Whitehill
    OX5 3AB Tackley
    Oxfordshire
    BritishCompany Director72213650001
    CORBETT, Michael Anthony
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    Administrateur
    6 Keasden Avenue
    FY4 3JF Blackpool
    Lancashire
    BritishCompany Director7008160003
    CORDINGLEY, Anthony Clive
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    Administrateur
    Wildhern 28 St Martins Drive
    Eynsford
    DA4 0EZ Dartford
    Kent
    BritishDirector7008170001
    DUNN, David Young
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    Administrateur
    2 Glendarvel Avenue
    Bearsden
    G61 2PR Glasgow
    BritishDirector38982880001
    FARRAR, John Trueman
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    Administrateur
    Hillview House
    Park Close
    KT22 9BD Leatherhead
    Surrey
    BritishOffice Manager/Director34540860001
    FARROW, Dennis
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    Administrateur
    30 Montpelier Gardens
    East Ham
    E6 3JD London
    BritishDirector10910860001
    FLETT, Alan Douglas
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    Administrateur
    16 Guards Court
    Chobham Road Ascot
    SL5 0ES Sunningdale
    Berkshire
    EnglandBritishDirector93037840001
    HAYWARD, Ian Charles
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    Administrateur
    9 Wilderness Road
    RG6 7RU Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant79564240001
    KENDLE, David Philip
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    Administrateur
    99 Higher Drive
    SM17 1PS Banstead
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director95977510001
    KENYON, Rodney Frank
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    Administrateur
    62 Chiswick Green Studios
    Evershed Walk Chiswick
    W4 5BW London
    EnglandBritishCompany Director62258710001
    LAIRD, James
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    Administrateur
    17 Morlich Road
    Dalgety Bay
    KY11 5UF Dunfermline
    Fife
    BritishDirector34535330001
    LENHAM, Stephen
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    Administrateur
    17 High Beeches
    SM7 1NB Banstead
    Surrey
    BritishDirector7008190004
    MAXEY, Clement Leslie
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    Administrateur
    4 Formby Close
    Belton Lane
    NG31 9PD Grantham
    Lincolnshire
    BritishIndependent Management Consult37195980001
    PINCHIN, Terence Rodney
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    Administrateur
    2 St Judes Close
    Englefield Green
    TW20 0DE Egham
    Surrey
    BritishManaging Director65159820001
    RAY, John Albert
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    Administrateur
    Woodbrook
    Beech Drive
    KT20 6PJ Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritishDirector104536620001
    SHAW, Daniel Rankin
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    Administrateur
    Lindenlee
    Old Greenock Road
    PA7 5PA Bishopton
    Renfrewshire
    ScotlandBritishDirector7008210001
    SHEARS, John Nicholas
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    Lovania Birch Lane
    SL5 8RF Ascot
    Berkshire
    BritishBritishCompany Director61771310001
    STERN, Christopher John
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    EnglandEnglishManaging Director55825790001
    TURNER, Moira Lynne
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Woodend House
    11 Dower Close
    HP9 1XZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director82549950002
    UZIELLI, Michael Robin
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    Administrateur
    Millstream
    Maidenhead Road
    SL4 5GD Windsor
    Berkshire
    BritishFinance Director107591700002

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 15 nov. 1999
    Livré le 26 nov. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H 320C mayoral way team valley trading estate gateshead tyne & wear. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 27 sept. 1999
    Livré le 30 sept. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold - 24 hampton court king and queen wharf rotherhithe st,london SE16. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 30 sept. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 juil. 1999
    Livré le 10 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at unit 10 bessemer park herne hill london (leasehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 02 juil. 1999
    Livré le 10 juil. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The property at 239 milkwood road herne hill london (freehold).. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 10 juil. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 déc. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Rent deposit agreement
    Créé le 05 nov. 1998
    Livré le 14 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the lease of even date between the landlord and the tenant relating to unit B7 the avenues team valley gateshead
    Brèves mentions
    All the compamy's right title and interest in and to the rent deposit sum of £1,365 an all related rights thereto and thereof.
    Personnes ayant droit
    • Renbrook Limited
    Transactions
    • 14 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 14 oct. 1996
    Livré le 30 oct. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the lease of even date and the rent deposit deed
    Brèves mentions
    Rent deposit of £1300.
    Personnes ayant droit
    • Renbrook Limited
    Transactions
    • 30 oct. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 avr. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 14 mars 1996
    Livré le 16 mars 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Property at 11 lindsay square london (leasehold) with the benefit of all rights licences guarantees and rent deposits with the goodwill of the business. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 16 mars 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Fixed equitable charge
    Créé le 17 janv. 1996
    Livré le 23 janv. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All book debts invoice debts accounts notes bills acceptances and/or other forms of obligation the subject of a factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Griffin Factors Limited
    Transactions
    • 23 janv. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 05 déc. 1995
    Livré le 07 déc. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £225,000 due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    L/Hold property- 11 lindsay sq,millbank,london SW1.
    Personnes ayant droit
    • Slark Trustee Company Limited
    Transactions
    • 07 déc. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2001Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 31 janv. 1995
    Livré le 17 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a unit 12 bessemer park milkwood road herne hill london with all fixtures and fittings. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 17 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 sept. 1994
    Livré le 04 oct. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/as units 22 & 23 bessemer park milkwood road herne hill london SE24 ohh. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 04 oct. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 04 févr. 1992
    Livré le 08 févr. 1992
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    For further securing all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoeversupplemental to the principal charge dated 18/01/82
    Brèves mentions
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital patents/applications and trade marks etc. (for full details see form 395 tc ref: M331C).
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 08 févr. 1992Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 14 nov. 1986
    Livré le 19 nov. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    115 marsham court marsham street london.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 19 nov. 1986Enregistrement d'une charge
    • 31 janv. 1998Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 18 janv. 1982
    Livré le 21 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book and other debts now and from time to time due floating charge over. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 21 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    • 04 août 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    BRITISH GAS HOUSING SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 avr. 2016Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0