HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED

HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHODGSON & HODGSON GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01574452
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits métalliques n.c.a. (25990) / Industries manufacturières
    • Autres industries manufacturières n.d.a. (32990) / Industries manufacturières
    • Revêtement des sols et des murs (43330) / Construction
    • Activités de conseil en environnement (74901) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OAKTIME LIMITED15 juil. 198115 juil. 1981

    Quels sont les derniers comptes de HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2015

    Quels sont les derniers dépôts pour HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2020

    23 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2019

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 28 juin 2018

    24 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    30 pagesAM10

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    31 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    38 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    62 pages2.17B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    18 pages2.16B

    Changement d'adresse du siège social de Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ à 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 27 oct. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Déclaration de confirmation établie le 07 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Inscription de la charge 015744520013, créée le 03 août 2016

    18 pagesMR01

    Inscription de la charge 015744520016, créée le 03 août 2016

    15 pagesMR01

    Inscription de la charge 015744520014, créée le 03 août 2016

    17 pagesMR01

    Inscription de la charge 015744520015, créée le 03 août 2016

    15 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    26 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2015

    État du capital au 08 sept. 2015

    • Capital: GBP 139,433.75
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Paul David Pickup le 01 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Crown Industrial Estate Anglesey Road Burton-on-Trent Staffordshire DE14 3PA à Unit 15 the Crown Business Park, Station Road Old Dalby Melton Mowbray Leicestershire LE14 3NQ le 01 sept. 2015

    1 pagesAD01

    Inscription de la charge 015744520011, créée le 08 juil. 2015

    17 pagesMR01

    Inscription de la charge 015744520012, créée le 08 juil. 2015

    17 pagesMR01

    Qui sont les dirigeants de HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Secrétaire
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    British11661720003
    GREEN, Kevin Jeffrey
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish83354170002
    LOFTUS, Gerard
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish199232130001
    PICKUP, Paul David
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish11661720003
    WEAVERS, Paul Barrington
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandBritish63246890002
    WOOD, Martin Charles
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Administrateur
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish102354760001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Secrétaire
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    British25400000001
    PICKUP, Paul David
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    46 Hazelbank Avenue
    Mapperley
    NG3 3EY Nottingham
    Nottinghamshire
    British11661720002
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001
    BALSHAW JONES, Glynne
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish52751310002
    COMANDI, Juan Manuel
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish117153380001
    DOYLE, Thomas John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish159373190001
    GRUNDY, Nigel Arthur
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    Administrateur
    The Crofts
    CO6 4QY Stoke-By-Nayland
    Suffolk
    United KingdomBritish6498450001
    HOBBS, Philip
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    Administrateur
    2 Crownsmead
    NN4 9XP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish25400000001
    HUGO, Gerald William
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    55 Denton Road
    DE13 0QA Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842290001
    LONG, Brian Thomas
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    258 Rolleston Road
    DE13 0AY Burton On Trent
    Staffordshire
    British16842300002
    NARBURGH, Margaret
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    Administrateur
    Plas Pinwydden
    Village Road Maeshafn
    CH7 5LU Mold
    Denbighshire
    British83189380001
    PROFIT, John Anthony
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    Administrateur
    8 Tanwood Close
    B91 3JX Solihull
    West Midlands
    British69219120001
    ROBERTS, John
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish32341560001
    ROLLINSON, Philip
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    Administrateur
    Crown Industrial Estate
    Anglesey Road
    DE14 3PA Burton-On-Trent
    Staffordshire
    United KingdomBritish21921610001
    WHITE, John Michael
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    27 Clumber Avenue
    Mapperley
    NG3 5JY Nottingham
    Nottinghamshire
    British16842280001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wrogel Management Ltd
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    06 avr. 2016
    Station Road
    SL9 8EL Gerrards Cross
    Collins House
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement09353662
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 03 août 2016
    Livré le 04 août 2016
    En cours
    Brève description
    Freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wrogel Management Limited
    Transactions
    • 04 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 août 2016
    Livré le 04 août 2016
    En cours
    Brève description
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wrogel Management Limited
    Transactions
    • 04 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 août 2016
    Livré le 04 août 2016
    En cours
    Brève description
    Freeland land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gerard Christopher Loftus
    Transactions
    • 04 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 03 août 2016
    Livré le 04 août 2016
    En cours
    Brève description
    Freehold property known as 15 princewood road, corby NN17 4AP (described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby NN17 4AP) with title number NN130556.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gerard Christopher Loftus
    Transactions
    • 04 août 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 08 juil. 2015
    Livré le 21 juil. 2015
    En cours
    Brève description
    The freehold property known as 15 princewood road, corby described at the land registry as the freehold land shown edged red on the plan of the above title filed at the registry and being 23 princewood road, corby being the land registered with title number NN130556.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gerard Christopher Loftus
    Transactions
    • 21 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 08 juil. 2015
    Livré le 21 juil. 2015
    En cours
    Brève description
    Freehold land known as 14 the crown business park, station road, old dalby, LE14 3NQ registered at the land registry under title number LT308365.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Gerard Christopher Loftus
    Transactions
    • 21 juil. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 28 juin 2010
    Livré le 02 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Close Invoice Finance LTD
    Transactions
    • 02 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 23 juin 2000
    Livré le 04 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 2000
    Livré le 04 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as unit 14 sceptre road, crown business park, old dalby, melton mowbray, leicestershire LE14 3NQ t/no: LT308365. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 2000
    Livré le 04 juil. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as aldham house, 41A lady lane industrial estate, hadleigh t/no: SK119826. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 juil. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 23 juin 2000
    Livré le 04 juil. 2000
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The freehold property known as 23 (formerly 15) princewood road, earlstree industrial estate, corby, northamptonshire t/no: NN130556. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 juil. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 12 mars 2000
    Livré le 21 mars 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All obligations and liabilities due or to become due from each chargor (as defined) to the chargee on any account whatsoever and incurred under any finance document (as defined)
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transactions
    • 21 mars 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 1997
    Livré le 09 mai 1997
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ucb Invoice Discounting Limited
    Transactions
    • 09 mai 1997Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Mortgage debenture
    Créé le 04 oct. 1985
    Livré le 14 oct. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charge over:- goodwill, bookdebts.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 14 oct. 1985Enregistrement d'une charge
    • 31 août 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1982
    Livré le 28 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Estate Duties Investments Trust P.L.C.
    Transactions
    • 28 janv. 1982Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 15 janv. 1982
    Livré le 28 janv. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited.
    Transactions
    • 28 janv. 1982Enregistrement d'une charge

    HODGSON & HODGSON GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 oct. 2016Administration started
    29 juin 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2
    DateType
    29 juin 2017Commencement of winding up
    18 août 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0