GLASGOWEND LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGLASGOWEND LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01576203
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GLASGOWEND LIMITED ?

    • (4521) /

    Où se situe GLASGOWEND LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Isaacs Building
    4 Charles Street
    S1 2HS Sheffield
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GLASGOWEND LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    HENRY BOOT GLASGOW LIMITED28 juin 200228 juin 2002
    HENRY BOOT SCOTLAND LIMITED24 juil. 198124 juil. 1981

    Quels sont les derniers comptes de GLASGOWEND LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2010
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2011
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2009

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GLASGOWEND LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au18 juin 2017
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation02 juil. 2017
    En retardOui

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour GLASGOWEND LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour GLASGOWEND LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Cessation de la nomination de Amy Louise Stanbridge en tant que directeur le 02 déc. 2025

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Amy Louise Stanbridge le 10 nov. 2023

    2 pagesCH01

    Changement d'adresse du siège social de Banner Cross Hall Ecclesall Road South Sheffield S11 9PD United Kingdom à Isaacs Building 4 Charles Street Sheffield S1 2HS le 13 nov. 2023

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Darren Louis Littlewood le 25 août 2022

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Amy Louise Stanbridge en tant qu'administrateur le 31 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de John Trevor Sutcliffe en tant que directeur le 31 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Edward James Boot en tant que directeur le 31 janv. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Gordon William Hawksley en tant que secrétaire le 31 janv. 2022

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Darren Louis Littlewood en tant qu'administrateur le 31 janv. 2022

    2 pagesAP01

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire des membres

    1 pagesREST-MVL

    Bulletin officiel final dissous par radiation d'office

    1 pagesGAZ2

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Restauration par ordonnance du tribunal

    3 pagesAC92

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Ordinary Resolution :- "Books, Records,Etc."
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolution d'insolvabilité

    Resolution INSOLVENCY:Special Resolution ;- "In Specie"
    1 pagesLIQ MISC RES

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 21 déc. 2010

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    État du capital après une attribution d'actions au 22 nov. 2010

    • Capital: GBP 4,515,601
    4 pagesSH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'augmentation du capital social autorisé

    RES04
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    legacy

    3 pagesMG02

    Certificat de changement de nom

    Company name changed henry boot glasgow LIMITED\certificate issued on 11/10/10
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name11 oct. 2010

    Avis de changement de nom"

    CONNOT

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Qui sont les dirigeants de GLASGOWEND LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LITTLEWOOD, Darren Louis
    4 Charles Street
    S1 2HS Sheffield
    Isaacs Building
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Charles Street
    S1 2HS Sheffield
    Isaacs Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish202989050002
    HAWKSLEY, Gordon William
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Secrétaire
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    British16393410001
    HAWLEY, Peter Lewis
    Woodside House 178 Brincliffe Edge Road
    S11 9BY Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Woodside House 178 Brincliffe Edge Road
    S11 9BY Sheffield
    South Yorkshire
    British11424610001
    ANDREW, James Graham
    22 South Mound
    Houston
    PA6 7DX Johnstone
    Renfrewshire
    Administrateur
    22 South Mound
    Houston
    PA6 7DX Johnstone
    Renfrewshire
    ScotlandBritish123471990001
    BAIKIE, Alexander Forsyth
    Braehead
    Abernethy
    PH2 9LW Perth
    Perthshire
    Administrateur
    Braehead
    Abernethy
    PH2 9LW Perth
    Perthshire
    British11591780001
    BALME, Roger
    9 Norton Green Close
    Norton
    S8 8BP Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    9 Norton Green Close
    Norton
    S8 8BP Sheffield
    South Yorkshire
    British11591790001
    BAMFORD, Alan Maxwell
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Stonecroft 53 Vicarage Lane
    Dore
    S17 3GX Sheffield
    South Yorkshire
    British11424620001
    BOOT, Edward James
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    United KingdomBritish7568670006
    BROCKIE, John Scott
    Foinaven 9 Fishers Green
    Bridge Of Allan
    FK9 4PU Stirling
    Stirlingshire
    Administrateur
    Foinaven 9 Fishers Green
    Bridge Of Allan
    FK9 4PU Stirling
    Stirlingshire
    British11591800001
    BURBIDGE, John Patrick
    Ravenoak 23 Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    Ravenoak 23 Prestbury Road
    SK9 2LJ Wilmslow
    Cheshire
    British42713820002
    CARRICK, Colin James
    25 Castle Road
    Dunure
    KA7 4LW Ayr
    Administrateur
    25 Castle Road
    Dunure
    KA7 4LW Ayr
    United KingdomBritish82568000001
    COOPER, Anthony Paul, Mr.
    59 Snaithing Lane
    S10 3LF Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    59 Snaithing Lane
    S10 3LF Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish7568680001
    FORSYTH, Donald Hugh Darg
    10 Sarazen Drive
    KA10 6JP Troon
    Ayrshire
    Administrateur
    10 Sarazen Drive
    KA10 6JP Troon
    Ayrshire
    British11591820001
    ROBERTSON, John
    19 Bailielands
    EH49 7ST Linlithgow
    West Lothian
    Administrateur
    19 Bailielands
    EH49 7ST Linlithgow
    West Lothian
    British11591810001
    STANBRIDGE, Amy Louise
    4 Charles Street
    S1 2HS Sheffield
    Isaacs Building
    United Kingdom
    Administrateur
    4 Charles Street
    S1 2HS Sheffield
    Isaacs Building
    United Kingdom
    EnglandBritish251832120003
    SUTCLIFFE, John Trevor
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    Administrateur
    Ecclesall Road South
    S11 9PD Sheffield
    Banner Cross Hall
    United Kingdom
    EnglandBritish81186640002

    GLASGOWEND LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 06 mai 2009
    Livré le 09 mai 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 mai 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 nov. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental charge
    Créé le 25 juil. 1986
    Livré le 15 août 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever as agent & trustee for the banks as defined and hessische landesbank-gironzentrale - supplemental to the principal deed dated 21.2.86.
    Brèves mentions
    All the property undertaking and assets charged by the charges created by the guarantee & debenture dated 21.2.86. (see doc 26 for fuller details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 15 août 1986Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 21 févr. 1986
    Livré le 06 mars 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the banks on any account whatsoever
    Brèves mentions
    (For full details see doc M25). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 06 mars 1986Enregistrement d'une charge

    GLASGOWEND LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    21 déc. 2010Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0