LEADING TECHNOLOGY LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLEADING TECHNOLOGY LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01584188
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROTEK TECHNOLOGY LIMITED31 déc. 198131 déc. 1981
    BRIARBELL LIMITED04 sept. 198104 sept. 1981

    Quels sont les derniers comptes de LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 nov. 2023

    LRESSP

    Changement d'adresse du siège social de Cody Technology Park Ively Road Farnborough Hampshire GU14 0LX à C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard 1 Queen Street Bristol BS2 0HQ le 23 nov. 2023

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Modification des coordonnées de l'administrateur James Stephen Field le 17 avr. 2023

    2 pagesCH01

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de James Richard Willis en tant que directeur le 21 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Alexander Haworth en tant que directeur le 13 sept. 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de James Stephen Field en tant que secrétaire le 25 août 2022

    2 pagesAP03

    Nomination de Mrs Heather Anne Cashin en tant qu'administrateur le 25 août 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de James Stephen Field en tant qu'administrateur le 25 août 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jon Messent en tant que secrétaire le 11 août 2022

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020

    7 pagesAA

    Modification des détails de Boldon James Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 22 juin 2020

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Martin Leslie Sugden en tant que directeur le 22 juin 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2019

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 03 déc. 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2018

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FIELD, James Stephen
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    Secrétaire
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    299524900001
    CASHIN, Heather Anne
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    Administrateur
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    EnglandBritishAccountant298988210001
    FIELD, James Stephen
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    Administrateur
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    C/O Frp Advisory Trading Limited, Kings Orchard
    EnglandBritishSolicitor298479420002
    BERMAN, John Michael
    19 Moreton Place
    SW1V 2NL London
    Secrétaire
    19 Moreton Place
    SW1V 2NL London
    British13050490001
    BOARDMAN, Lynton David
    Cherwell
    Forest Drive
    KT20 6LU Kingswood
    Surrey
    Secrétaire
    Cherwell
    Forest Drive
    KT20 6LU Kingswood
    Surrey
    British72633900005
    FRENCH, Rodger Ernest Arthur
    1 Northumberland Avenue
    HP21 7HG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    1 Northumberland Avenue
    HP21 7HG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British23883290001
    HACKETT, Katherine Ann
    The Hawthorns
    Harbour Lane, Wheelton
    PR6 8JS Chorley
    Lancashire
    Secrétaire
    The Hawthorns
    Harbour Lane, Wheelton
    PR6 8JS Chorley
    Lancashire
    BritishFinance Director105793600003
    MESSENT, Jon
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Secrétaire
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    British157181650001
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Secrétaire
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Secretary100207880001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    Secrétaire
    Hill House
    Heckfield
    RG27 0JY Hook
    Hampshire
    BritishCompany Director63057200002
    ADCOCK, Miles John, Dr
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishManaging Director177091950001
    BEAUMONT, Paul Anthony
    Church Croft
    Church Lane
    HX5 9QB Elland
    West Yorkshire
    Administrateur
    Church Croft
    Church Lane
    HX5 9QB Elland
    West Yorkshire
    EnglandBritishCeo89531160001
    BENNETT, Simon David, Dr
    Manor Farm House
    Main Street, Westbury
    NN13 5JR Brackley
    Northamptonshire
    Administrateur
    Manor Farm House
    Main Street, Westbury
    NN13 5JR Brackley
    Northamptonshire
    United KingdomBritishNew Venture Director74322240001
    BERMAN, John Michael
    19 Moreton Place
    SW1V 2NL London
    Administrateur
    19 Moreton Place
    SW1V 2NL London
    BritishChairman13050490001
    BUTCHER, Geoffrey Charles
    Fosse Way
    Harbury
    CV33 9JP Nr Leamington Spa
    Leamington Hall Farm
    Warwickshire
    Administrateur
    Fosse Way
    Harbury
    CV33 9JP Nr Leamington Spa
    Leamington Hall Farm
    Warwickshire
    EnglandBritishManaging Director134288870001
    CORDING, Stephen
    114 Norsey Road
    CM11 1BH Billericay
    Essex
    Administrateur
    114 Norsey Road
    CM11 1BH Billericay
    Essex
    EnglandBritishFinance Director92462850001
    EVANS, Geoffrey Christopher
    The Cottage
    Harpsden
    RG9 4HL Henley-On-Thames
    Oxon
    Administrateur
    The Cottage
    Harpsden
    RG9 4HL Henley-On-Thames
    Oxon
    BritishManaging Director32812800001
    EVANS, Spencer Gareth
    Buckingham Gate
    SW1E 6PD London
    85
    Administrateur
    Buckingham Gate
    SW1E 6PD London
    85
    EnglandBritishFinance Director148976480001
    GARROD, Kim Maria Michelle
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director130666660002
    GARROD, Michael James Baring
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishProgramme Director224052010001
    HAWORTH, John Alexander
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director246944280001
    HUMPHRIES, Nicholas James
    8 Maple Fold
    New Farnley
    LS12 5RX Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    8 Maple Fold
    New Farnley
    LS12 5RX Leeds
    West Yorkshire
    BritishVenture Capitalist45629590001
    LING, Christopher Adam
    85 Buckingham Gate
    London
    SW1E 6PD
    Administrateur
    85 Buckingham Gate
    London
    SW1E 6PD
    EnglandBritishFinancial Controller65865520001
    MACFARLANE, Andrew John
    Gatehouse
    Ranters Lane
    TN17 1HL Kilndown
    Kent
    Administrateur
    Gatehouse
    Ranters Lane
    TN17 1HL Kilndown
    Kent
    EnglandBritishCompany Director13050510001
    MCNAUGHT-DAVIS, James
    28 King Street
    SW1 London
    Administrateur
    28 King Street
    SW1 London
    IrishFinancier65403370002
    PALETHORPE, Mark John
    2 Fitzwilliams Court
    Greatford
    PE9 4QQ Stamford
    Lincolnshire
    Administrateur
    2 Fitzwilliams Court
    Greatford
    PE9 4QQ Stamford
    Lincolnshire
    BritishFinance Director125949860001
    PALSER, Adam Howard, Dr
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    England
    United KingdomBritishManaging Director248968590001
    PICON, Jaime
    Apartado 60649
    Caracas 10
    FOREIGN Venezuela
    Administrateur
    Apartado 60649
    Caracas 10
    FOREIGN Venezuela
    VenezuelanCompany Director46984050001
    RAZDAN, Sanjay
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandCanadianManaging Director165471790001
    SMITHAM, Peter
    51 Yeomans Row
    SW3 2AL London
    Administrateur
    51 Yeomans Row
    SW3 2AL London
    BritishInvestment Advisor73234100001
    SUGDEN, Martin Leslie
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant63057200004
    WATTERSON, Ian George Walter
    314 Barkham Road
    RG41 4DA Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    314 Barkham Road
    RG41 4DA Wokingham
    Berkshire
    BritishChartered Accountant81496480001
    WILLIS, James Richard
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director243854880001
    WOOD, Martin James
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    Administrateur
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    Hampshire
    EnglandBritishFinance Director45073950001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LEADING TECHNOLOGY LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Gyldan 11 Limited
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Ively Road
    GU14 0LX Farnborough
    Cody Technology Park
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleEngland And Wales
    Lieu d'enregistrementRegister Of Companies In England And Wales
    Numéro d'enregistrement5357068
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LEADING TECHNOLOGY LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Composite guarantee and debenture
    Créé le 02 juin 2005
    Livré le 16 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any group company to the chargee or to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Isis Equity Partners PLC (The Security Trustee)
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 juin 2005
    Livré le 16 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 16 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture deed
    Créé le 02 juin 2005
    Livré le 08 juin 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 08 juin 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 juil. 2003
    Livré le 11 juil. 2003
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2003Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee and debenture
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 15 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All liability of the company under the guarantee and debenture together with all moneys,and liabilities which are now or at any time have become due and shall not have been paid under a loan agreement dated 31 march 1998 and made between protek network management limited (1) greyrock business credit (a division of nationscredit commercial corporation) (2)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Greyrock Business Credit (A Division of Nationscredit Commercial Corporation)
    Transactions
    • 15 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 14 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1998
    Livré le 07 avr. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 07 avr. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge on book debts
    Créé le 25 nov. 1991
    Livré le 26 nov. 1991
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time hereafter due or owing or incurred to the company but limited to book and other debts arriving and payable in the U.K.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 26 nov. 1991Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 avr. 2005Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Charge
    Créé le 18 janv. 1983
    Livré le 20 janv. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 20 janv. 1983Enregistrement d'une charge
    • 11 mars 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LEADING TECHNOLOGY LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    09 nov. 2023Commencement of winding up
    23 mai 2024Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Gareth Rutt Morris
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    practitioner
    Kings Orchard
    1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    Matthew Whitchurch
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol
    practitioner
    Kings Orchard 1 Queen Street
    BS2 0HQ Bristol

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0