TRUCK FINANCE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTRUCK FINANCE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01591557
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TRUCK FINANCE LIMITED ?

    • (6522) /

    Où se situe TRUCK FINANCE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de TRUCK FINANCE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CHESHIRE LEASING LIMITED09 juil. 199809 juil. 1998
    TRUCK FINANCE LIMITED31 mars 198231 mars 1982
    ZOOBARON LIMITED15 oct. 198115 oct. 1981

    Quels sont les derniers comptes de TRUCK FINANCE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quels sont les derniers dépôts pour TRUCK FINANCE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Cessation de la nomination de Clifford Chance Secretaries (Cca) Limited en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Changement d'adresse du siège social de 10 Upper Bank Street London E14 5JJ le 12 janv. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 déc. 2009

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    15 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    15 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    17 pagesAA

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    18 pagesAA

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    3 pages363a

    legacy

    1 pages353

    Qui sont les dirigeants de TRUCK FINANCE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUNN, Anthony Martin
    St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    Administrateur
    St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    EnglandBritish131062600001
    FERGUSON, Robert Iain
    Flat 6 Rostrevor Mansions
    Rostrevor Road Fulham
    SW6 5AL London
    Administrateur
    Flat 6 Rostrevor Mansions
    Rostrevor Road Fulham
    SW6 5AL London
    United KingdomBritish88389230001
    PRICE, Drew
    St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    Administrateur
    St. Mary Axe
    EC3A 8EP London
    30
    EnglandBritish131061920001
    SHAW, Philip Edward
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British107315500001
    GITTINS, Paul
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    British45660860003
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secrétaire
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    83911920002
    BANKS, Richard Kirkwood
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    SwitzerlandBritish51759370002
    BARCLAY, William Gordon
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    Administrateur
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    British33196560002
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Administrateur
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish145644720001
    FRYATT, David Richard
    24 Spital Road
    CH63 9JE Bebington
    Wirral
    Administrateur
    24 Spital Road
    CH63 9JE Bebington
    Wirral
    British81063350001
    HALLIWELL, Christopher Roger
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    Administrateur
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    British4254150002
    HAN, Philip James
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish74160910001
    HARE, Robert Brown
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    13 Balgreen Avenue
    EH12 5SX Edinburgh
    Lothian
    British64474720003
    HOLLIDAY, Phillip Brook
    Woodbridge Road
    Tunstall
    IP12 2JE Woodbridge
    Tunstall Grange
    Suffolk
    Administrateur
    Woodbridge Road
    Tunstall
    IP12 2JE Woodbridge
    Tunstall Grange
    Suffolk
    United KingdomBritish30603210004
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Administrateur
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    British4672880001
    PAYNE, Michael
    Flat 3
    17 Granville Park
    SE13 7DY London
    Administrateur
    Flat 3
    17 Granville Park
    SE13 7DY London
    British120618520001
    PURCELL, Kevin
    9 Brittany House
    Balmuir Gardens
    SW15 6NF London
    Administrateur
    9 Brittany House
    Balmuir Gardens
    SW15 6NF London
    British,American120618240001
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Administrateur
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    British95498730001
    RITCHIE, Carol Ann
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish46402710001
    SMART, Christianne Fiona
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    British102262750002
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    WEBSTER, Alistair Linn
    1 Muirfield Drive
    EH52 6BU Uphall
    West Lothian
    Administrateur
    1 Muirfield Drive
    EH52 6BU Uphall
    West Lothian
    British60101190001
    WELLS, John Henry Edmund
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    Administrateur
    30 St Mary Axe
    EC3A 8EP London
    EnglandBritish141311090001
    WOODERSON, Michael
    17 Mortimer Court
    KY11 9UQ Dalgety Bay
    Fife
    Administrateur
    17 Mortimer Court
    KY11 9UQ Dalgety Bay
    Fife
    ScotlandBritish73899660001

    TRUCK FINANCE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Letter of charge
    Créé le 19 juin 1996
    Livré le 10 juil. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account or accounts in the banks books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 10 juil. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 24 mai 1997Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 20 févr. 1995
    Livré le 22 févr. 1995
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 22 févr. 1995Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 août 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 13 déc. 1994
    Livré le 23 déc. 1994
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 déc. 1994Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 févr. 1995Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of charge
    Créé le 12 août 1993
    Livré le 20 août 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 20 août 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 déc. 1994Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    TRUCK FINANCE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 déc. 2010Dissolved on
    15 déc. 2009Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    practitioner
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0