DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED

DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéDS SMITH DORMANT FOUR LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01598565
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    • (7499) /

    Où se situe DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Beech House Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Berkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    DS SMITH PACKAGING LIMITED22 déc. 200022 déc. 2000
    DS SMITH CORRUGATED LIMITED29 nov. 200029 nov. 2000
    COSSALL PRINTERS LIMITED12 févr. 198212 févr. 1982
    BODEMA LIMITED19 nov. 198119 nov. 1981

    Quels sont les derniers comptes de DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 avr. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Cessation de la nomination de Carolyn Cattermole en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 sept. 2010

    État du capital au 21 sept. 2010

    • Capital: GBP 2
    SH01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 avr. 2010

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Anthony Thorne en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Miles William Roberts en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Comptes consolidés établis au 30 avr. 2009

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Dr Anthony David Thorne le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Stephen William Dryden le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Carolyn Tracy Cattermole le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Anne Steele le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages287

    Comptes établis au 30 avr. 2008

    4 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes établis au 30 avr. 2007

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2006

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Comptes établis au 30 avr. 2005

    5 pagesAA

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    STEELE, Anne
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Secrétaire
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    British77624110001
    DRYDEN, Stephen William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director47821400004
    ROBERTS, Miles William
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director57880630003
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    Secrétaire
    81 Cranbrook Road
    Chiswick
    W4 2LJ London
    BritishCompany Secretary53026290001
    RICHARDSON, Alan John
    118 Paxford Road
    Sudbury Court
    HA0 3RH North Wembley
    Middlesex
    Secrétaire
    118 Paxford Road
    Sudbury Court
    HA0 3RH North Wembley
    Middlesex
    British43179370001
    RUSSELL, John Stuart
    Hundred Lodge
    25 The Forebury
    CM21 9BD Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    Hundred Lodge
    25 The Forebury
    CM21 9BD Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    British480230001
    BUTTFIELD, David Frank
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Mill Meadow Mill Lane
    HP7 0EH Amersham
    Buckinghamshire
    BritishAccountant37624090002
    CATTERMOLE, Carolyn Tracy
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Secretary53026290002
    GREEN, Michael George
    Thorniethwaite
    DG11 1JH Lockerbie
    Dumfries
    Administrateur
    Thorniethwaite
    DG11 1JH Lockerbie
    Dumfries
    ScotlandBritishDirector23613980001
    MORRIS, Gavin Mathew
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    Administrateur
    20 Argyll Road
    W8 7BG London
    EnglandBritishCompany Executive16228990001
    RUSSELL, John Stuart
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    Administrateur
    Little Pennys 70 High Wych Road
    CM21 0HG Sawbridgeworth
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary480230002
    THORNE, Anthony David
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    Administrateur
    Whitebrook Park
    68 Lower Cookham Road
    SL6 8XY Maidenhead
    Beech House
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Executive40130640001
    WILLIAMS, John Peter
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    Administrateur
    30 Egerton Crescent
    SW3 2EB London
    United KingdomBritishDirector707720002

    DS SMITH DORMANT FOUR LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 mars 1984
    Livré le 19 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Merchant Bank Limited
    Transactions
    • 19 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 mars 1984
    Livré le 16 avr. 1984
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 16 avr. 1984Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 03 sept. 1982
    Livré le 09 sept. 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 09 sept. 1982Enregistrement d'une charge
    Further guarantee & debenture
    Créé le 25 mai 1982
    Livré le 01 juin 1982
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brèves mentions
    Fixed & floating charges undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Barclays Bank PLC
    Transactions
    • 01 juin 1982Enregistrement d'une charge

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0