AC201 REALISATIONS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAC201 REALISATIONS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01600753
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    • (9305) /

    Où se situe AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2A 1AG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ANGLAIR LIMITED20 oct. 198620 oct. 1986
    AIRTEC LIMITED27 mars 198627 mars 1986
    ATC PNEUMATICS LIMITED09 sept. 198209 sept. 1982
    DOUBLEBADGE LIMITED30 nov. 198130 nov. 1981

    Quels sont les derniers comptes de AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2008

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    9 pages4.72

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 mars 2015

    8 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 mars 2014

    7 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 mars 2013

    8 pages4.68

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 mars 2012

    6 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 sept. 2011

    6 pages2.24B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 mars 2011

    8 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    2 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 22 sept. 2010

    7 pages2.24B

    Résultat de la réunion des créanciers

    11 pages2.23B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    10 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de * 115 Burrell Road Ipswich Suffolk IP2 8AE* le 09 avr. 2010

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pages2.12B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed anglair LIMITED\certificate issued on 31/03/10
    2 pagesCERTNM

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2008

    10 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    10 pagesAA

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    7 pages363s
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    annual-return04 juil. 2007

    legacy

    363(288)

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2005

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AC201 REALISATIONS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Secrétaire
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    SHANKS, Alastair Paul Henry
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    Administrateur
    Alde House
    Polstead Street
    CO6 4SA Stoke By Nayland
    BritainBritish101167430002
    SHANKS, Alexander Gavin
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    Administrateur
    Waterside House
    G76 9HN Glasgow
    ScotlandBritish21890001
    SHELDON, James
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    Administrateur
    69 Clober Road
    Milngavie
    G62 7SU Glasgow
    British79738990001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    Secrétaire
    2 Red Hall Court
    IP11 7AQ Felixstowe
    Suffolk
    British52221890002
    PRATT, Cyril Harry
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    Secrétaire
    33 Briar Hill
    Woolpit
    IP30 9SD Bury St Edmunds
    Suffolk
    British8832470001
    WOOLLHEAD, John Andrew
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    Secrétaire
    23 Ruxley Ridge
    Claygate
    KT10 0HZ Esher
    Surrey
    British13072060002
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish47892490001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish4250980001
    CHILTON, Albert Edmund
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    Administrateur
    1 Garfield Close
    IP11 7PX Felixstowe
    Suffolk
    British6236180002
    FOSTER, Simon
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    Woodlands Old Farm
    Upper Denby Grange Moor
    WF4 4BJ Wakefield
    West Yorkshire
    British94152980001
    FRYER, Peter Kenneth
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Administrateur
    4 Hope Crescent
    Melton
    IP12 1SJ Woodbridge
    Suffolk
    Other79955580001
    JACKSON, David James
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    10 Stone Rings Close
    HG2 9HZ Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish62867720010
    JACKSON, Frank
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    Administrateur
    Orchard House
    IP12 1AS Woodbridge
    Suffolk
    British10015550001
    KING, Geoffrey Edward
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    Administrateur
    27 Thirlmere Road
    Barrow On Soar
    LE12 8QQ Loughborough
    Leicestershire
    British10425820001
    LATIMER, Stephen Berjie James
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    154 Taverham Road
    Taverham
    NR8 6SD Norwich
    Norfolk
    British10425810001
    STANTON, Derek William
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    Administrateur
    74 Barnards Hill
    SL7 2NZ Marlow
    Buckinghamshire
    British10425830001
    URQUHART, Robert Todd
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    Administrateur
    24 Menteith View
    FK15 0PD Dunblane
    Perthshire
    British56397610002

    AC201 REALISATIONS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland Commercial Services Limited
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a 5 pinfold road, thurmaston, leicester t/no LT130050. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land k/a 203 to 207 (odd) attercliffe road, sheffield t/nos SYK448819 and SYK343842. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a 199/201/203 mile cross lane, norwich t/nos NK21866 and NK6883. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a 115 burrell road ipswich t/no SK124923. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 16 janv. 2004
    Livré le 22 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    Composite guarantee and trust debenture
    Créé le 07 oct. 2002
    Livré le 09 oct. 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any of them to the trustee and or the beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Agent and Trustee for Thebeneficiaries (As Defined)
    Transactions
    • 09 oct. 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 janv. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 31 mars 1999
    Livré le 08 avr. 1999
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 08 avr. 1999Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2002Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Single debenture
    Créé le 19 sept. 1983
    Livré le 27 sept. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 27 sept. 1983Enregistrement d'une charge
    • 02 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Letter of set off
    Créé le 07 févr. 1983
    Livré le 18 févr. 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or jackson group PLC to the chargee
    Brèves mentions
    Sums standing to the credit of the company with lloyds bank PLC.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 18 févr. 1983Enregistrement d'une charge
    • 02 avr. 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    AC201 REALISATIONS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 mars 2010Administration started
    20 mars 2012Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Caven
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    practitioner
    Grant Thornton
    95 Bothwell Street
    Glasgow
    G2 7jz
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    practitioner
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    2
    DateType
    20 mars 2012Commencement of winding up
    14 sept. 2016Due to be dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert Caven
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    practitioner
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    John Gerard Montague
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh
    practitioner
    1/4 Atholl Crescent
    EH19 3LW Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0