PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPTARMIGAN (LEEDS) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 01601077
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    • (5190) /

    Où se situe PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Gelderd Road
    Leeds
    LS12 6NB West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VAN-LINE LIMITED01 déc. 198101 déc. 1981

    Quels sont les derniers comptes de PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Achèvement de la liquidation

    1 pagesL64.07

    Ordonnance du tribunal pour liquider

    3 pagesCOCOMP

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    2 pagesDS01

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2007

    9 pagesAA

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2006

    13 pagesAA

    legacy

    8 pages363s

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    2 pages288a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2005

    15 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    BritishManaging Director117111790001
    MEYER, Arnold Corydon
    Via D'Arezzo Drive
    Bonita Springs
    28607
    Florida 34135
    Usa
    Administrateur
    Via D'Arezzo Drive
    Bonita Springs
    28607
    Florida 34135
    Usa
    AmericanCeo118011210003
    WOELCKE, Gerald
    12637 Little Palm Lane
    Boca Raton
    Florida 33428
    Usa
    Administrateur
    12637 Little Palm Lane
    Boca Raton
    Florida 33428
    Usa
    CanadianCfo119073850001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director117111790001
    LAX, Noel Geoffrey
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    Secrétaire
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director51487610001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Secrétaire
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    British21912090001
    YATES, John Martyn
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    Secrétaire
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    British7608780001
    BLUTH, Thomas
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    Administrateur
    289 Landines Blvd
    Weston
    33327
    Usa
    AmericanAttorney70476630001
    BORZILLO, Anthony David
    4026 N. Ocean Drive
    Hollywood
    Florida
    33019
    Usa
    Administrateur
    4026 N. Ocean Drive
    Hollywood
    Florida
    33019
    Usa
    AmericanCfo113811410001
    DAVIDSON, Bruce Wood Hardy
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    Moor Close
    St Johns Park Menston Ilkley
    LS29 6ES Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector117111790001
    FAWCETT, Michael Alan
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    Administrateur
    94 Mottram Old Road
    SK15 2TE Stalybridge
    Cheshire
    BritishAccountant38913590002
    FOX, Patrick Adam Charles
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    Administrateur
    30 Dorville Crescent
    W6 0HJ London
    BritishCompany Director34607130001
    HALL, John Maddison
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Granary Briery Hall Farm
    Chevet Lane
    WF2 6PT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director61236690001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Administrateur
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritishCompany Director50729030001
    HERSH, Robert
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    Administrateur
    6700 Sw 88 Terrace
    Miami
    FOREIGN Florida
    33156
    United States
    United StatesExecutive72215110001
    LAX, Noel Geoffrey
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    Administrateur
    5 Haweswater Close
    LS22 6FG Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinancial Director51487610001
    MARBLE, Stephen Gerald
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    Administrateur
    10430 Sw 20 Street
    Davie
    Florida
    Fl33324
    Usa
    AmericanCfo86928580001
    MORRALL, Albert Bryan
    Cedar Lodge
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Cedar Lodge
    Wilmslow Road Mottram St Andrew
    SK10 4QH Macclesfield
    Cheshire
    BritishCompany Director7608800001
    MORRIS, Anthony Edwin
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    Administrateur
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    EnglandBritishOperations Director105158910004
    MORRIS, Anthony Edwin
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    Administrateur
    Delf Field Fold
    Kebroyd Lane, Kebroyd
    HX6 3HT Sowerby Bridge
    EnglandBritishOperations Director105158910004
    PEARCE, Colin James
    The Lilacs 2 Rutland Avenue
    WF8 3RD Pontefract
    West Yorkshire
    Administrateur
    The Lilacs 2 Rutland Avenue
    WF8 3RD Pontefract
    West Yorkshire
    BritishManaging Director26810630001
    PRICE, William Anthony
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    Administrateur
    34 Lea Drive
    Shepley
    HD8 8HA Huddersfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director45498850001
    RAPPAPORT, Dean
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    Administrateur
    11988 Classic Drive
    Coral Springs
    Florida 33071
    Usa
    AmericanExecutive71410030001
    RODNEY, Gary
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    Administrateur
    3101 Pierson Drive
    FLORIDA Delray Beach
    33483
    Usa
    AmericanDirector102721900001
    SASNETT, David Warren
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    Administrateur
    16254 S.W.67 Court
    Fort Lauderdale
    Florida 33331
    Usa
    AmericanAccountant76805900001
    SKILLEN, Robert Lynn
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    Administrateur
    Apt 510
    7345 Fairway Drive
    FOREIGN Miami Lakes
    Florida 33014
    United States
    BritishCfo80493540001
    STATHAM, James Edward Anthony
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    Administrateur
    Highlands
    TR11 5LA Helford Passage
    Cornwall
    United KingdomBritishChartered Accountant150614890001
    VARAKIAN, Robert
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    Administrateur
    17555 Collins Avenue Apt 1703
    FLORIDA Sunny Isles Beach
    33160
    America
    AmericanDirector102721240001
    WELHAM, Anthony Frederick
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    82 West End Lane
    Horsforth
    LS18 5EP Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishCertified Accountant21912090001
    YATES, John Martyn
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    Administrateur
    5 Melia Close
    BB4 6RQ Rossendale
    Lancashire
    BritishSolicitor7608780001

    PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental debenture (supplementing and amending a guarantee and debenture dated 23 december 2003)
    Créé le 23 déc. 2004
    Livré le 04 janv. 2005
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in the blocked accounts, book debts,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida) as Agent and Trustee for Itself and Each of Thelenders
    Transactions
    • 04 janv. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Guarantee & debenture
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 24 févr. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee and the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida) (the Agent) as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders
    Transactions
    • 24 févr. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Loan and security agreement
    Créé le 23 déc. 2003
    Livré le 09 janv. 2004
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any or all of borrowers to agent or any lender and/or any of their affiliates under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The collateral being all accounts all general intangibles including without limitation all intellectual property all goods all real property and fixtures all chattel paper all instruments all documents and all deposit accounts * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Congress Financial Corporation (Florida), in Its Capacity as Agent for Lenders (the Agent)
    Transactions
    • 09 janv. 2004Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 mai 2005Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    Mortgage debenture
    Créé le 30 mai 2002
    Livré le 14 juin 2002
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The leasehold property known as marlborough works marlborough road accrington england BB5 5BE title number LA858360. Freehold property known as beza road hunslet leeds england LS10 2BR title number WYK569370. The leasehold property known as broadway broadway industrial estate hyde greater manchester SK14 5BE title number GM12514. For further details of properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks
    Transactions
    • 14 juin 2002Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 18 août 2000
    Livré le 01 sept. 2000
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies obligations and liabilites due owing or incurred by each obligor to the chargee under or in connection with the facilities or any document given as security therefor by any such obligor on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Suntrust Bank as Trustee and Agent for the Banks (As Defined) ("Administrative Agent")
    Transactions
    • 01 sept. 2000Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 févr. 2004Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 nov. 1998
    Livré le 12 nov. 1998
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Midland Bank PLC
    Transactions
    • 12 nov. 1998Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal nortgage
    Créé le 12 nov. 1996
    Livré le 13 nov. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that land and buildings at the east side of beza road hunslet leeds t/no;-WYK569370 goodwill of any business at the property full benefit of all licences proceeds of sale of the property all monies under any insurance policy. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal mortgage
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 05 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All that f/h land and buildings at the east side of beza road hunslet leeds t/n WYK294041 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 13 nov. 1996Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage debenture
    Créé le 29 mars 1996
    Livré le 05 avr. 1996
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 05 avr. 1996Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 nov. 2000Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 10 déc. 1993
    Livré le 17 déc. 1993
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the debenture (as defined)
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 déc. 1993Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 1999Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 févr. 1986
    Livré le 21 févr. 1986
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/Hold land and buildings on the east size of beza road hunslet leeds west yorkshire title no wyk 294041 together with, fixed charge over plant machinery fixtures implements and utensils fittings, furniture & equipment.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Banks of Scotland PLC
    Transactions
    • 21 févr. 1986Enregistrement d'une charge
    • 10 sept. 1993Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 25 nov. 1985
    Livré le 29 nov. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brèves mentions
    Land & buildings on the east side of beza street hunslet leeds title no wyk 294041.
    Personnes ayant droit
    • Martin Murray
    Transactions
    • 29 nov. 1985Enregistrement d'une charge
    Legal mortgage
    Créé le 28 août 1985
    Livré le 02 sept. 1985
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land and buildings at beza road. Title no wyx 294041 (see doc M9 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Bank of Credit & Commerce International Society Anonyme
    Transactions
    • 02 sept. 1985Enregistrement d'une charge
    Debenture
    Créé le 18 mai 1983
    Livré le 25 mai 1983
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a factory agreement dated 18TH may 1983
    Brèves mentions
    All bookdebts and other debts both present and future. (See doc M8 for full details).
    Personnes ayant droit
    • Kellock Factors LTD.
    Transactions
    • 25 mai 1983Enregistrement d'une charge

    PTARMIGAN (LEEDS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    23 avr. 2014Dissolved on
    24 mars 2011Petition date
    21 janv. 2014Conclusion of winding up
    06 juin 2011Commencement of winding up
    Compulsory liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    The Official Receiver Or Leeds
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds
    practitioner
    3rd Floor
    1 City Walk
    LS11 9DA Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0